KENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED

KENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED
    Stato della societàConvertita/Chiusa
    Forma giuridicaConvertita o chiusa
    Numero di società 03372093
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED?

    • Commercio al dettaglio in negozi non specializzati con prevalenza di alimentari, bevande o tabacco (47110) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova KENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 Angel Square
    M60 0AG Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di KENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PRICESTORE LIMITED16 mag 199716 mag 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di KENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al11 gen 2015

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per KENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per KENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Varie

    Forms b & z convert to rs
    2 pagineMISC

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Convert to rs 02/06/2016
    RES13

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 02 giu 2016

    • Capitale: GBP 2,800,002
    3 pagineSH01

    Nomina di Mr David Roberts come amministratore in data 01 apr 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Steven Clive Bailey come amministratore in data 01 apr 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 27 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 apr 2016

    Stato del capitale al 28 apr 2016

    • Capitale: GBP 2,800,000
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    1 pagineMR04

    Conto per una società dormiente redatto al 11 gen 2015

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 mag 2015

    Stato del capitale al 01 mag 2015

    • Capitale: GBP 2,800,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 02 gen 2014

    4 pagineAA

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 02 gen 2015 al 11 gen 2015

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 31 lug 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 ago 2014

    Stato del capitale al 29 ago 2014

    • Capitale: GBP 2,800,000
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 27 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 mag 2014

    Stato del capitale al 06 mag 2014

    • Capitale: GBP 2,800,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 05 gen 2013

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da * New Century House Corporation Street Manchester M60 4ES* in data 03 dic 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 27 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    4 pagineAA

    Nomina di Cws (No.1) Limited come amministratore

    2 pagineAP02

    Nomina di Mr Steven Clive Bailey come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Stephen Humes come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Timothy Hurrell come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 27 apr 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 01 gen 2011

    4 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Timothy Hurrell il 01 ago 2010

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di KENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SELLERS, Caroline Jane
    1 Gale Close
    Littleborough
    OL15 9EJ Rochdale
    Lancashire
    Segretario
    1 Gale Close
    Littleborough
    OL15 9EJ Rochdale
    Lancashire
    British45801060004
    ROBERTS, David Francis
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector Of Estates Services200852560001
    CWS (NO.1) LIMITED
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Amministratore
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione1925625
    130695310001
    COBURN, Ian David
    6 Sorrel Drive
    GU18 5PB Lightwater
    Surrey
    Segretario
    6 Sorrel Drive
    GU18 5PB Lightwater
    Surrey
    BritishCompany Director3000420001
    COUSINS, Alan Gordon Arthur
    94 Bridge Road
    SO31 7EP Sarisbury Green
    Hampshire
    Segretario
    94 Bridge Road
    SO31 7EP Sarisbury Green
    Hampshire
    British57534360001
    WHITTAKER, Katherine Alison
    22 Westfield Drive
    Woodley
    SK6 1LD Stockport
    Cheshire
    Segretario
    22 Westfield Drive
    Woodley
    SK6 1LD Stockport
    Cheshire
    British29899300002
    EXCELLET INVESTMENTS LIMITED
    Senator House
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4JL London
    Segretario
    Senator House
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4JL London
    1872620003
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Segretario nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    BAILEY, Steven Clive
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant95753690002
    BRAITHWAITE, Neil
    74 Stockton Lane
    YO31 1BN York
    Amministratore
    74 Stockton Lane
    YO31 1BN York
    EnglandBritishChartered Accountant87486660004
    CHEYNE, David George Thomson
    The Covert 98 Woodlands Road
    Ashurst
    SO40 7AH Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    The Covert 98 Woodlands Road
    Ashurst
    SO40 7AH Southampton
    Hampshire
    BritainBritishCommercial Director74956170001
    CLAPHAM, David John
    4 Heritage Hill
    BR2 6AU Keston
    Kent
    Amministratore
    4 Heritage Hill
    BR2 6AU Keston
    Kent
    United KingdomBritishManaging Director Retail Alld29705630001
    COBURN, Ian David
    6 Sorrel Drive
    GU18 5PB Lightwater
    Surrey
    Amministratore
    6 Sorrel Drive
    GU18 5PB Lightwater
    Surrey
    BritishCompany Director3000420001
    HENSHAW, Stephen Anthony
    Aylesbury House
    Horsebridge Road Broughton
    SO20 8BD Stockbridge
    Hampshire
    Amministratore
    Aylesbury House
    Horsebridge Road Broughton
    SO20 8BD Stockbridge
    Hampshire
    BritishDirector91828160001
    HOLLAND, Joseph
    87 Chapleton Road
    Bromley Cross
    BL7 9LZ Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    87 Chapleton Road
    Bromley Cross
    BL7 9LZ Bolton
    Lancashire
    EnglandBritishCompany Director14141950001
    HOOKE, Anthony Arnold
    Cedars Wildwood Gardens
    Dingels Lane Cricket Hill
    GU46 6EB Yateley
    Hampshire
    Amministratore
    Cedars Wildwood Gardens
    Dingels Lane Cricket Hill
    GU46 6EB Yateley
    Hampshire
    BritishShopkeeper69353000002
    HUMES, Stephen
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    Amministratore
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United KingdomBritishFinance Director84087790001
    HURRELL, Timothy
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    Amministratore
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    United KingdomBritishGeneral Manager Food Group99724260001
    LAWSON, Stuart
    Treetops Smithwood Avenue
    GU6 8PS Cranleigh
    Surrey
    Amministratore
    Treetops Smithwood Avenue
    GU6 8PS Cranleigh
    Surrey
    BritishChief Executive60361810001
    MCCRACKEN, Philip Guy
    The Bothy
    Bere Court Farm Pangbourne
    RG8 8HT Reading
    Berkshire
    Amministratore
    The Bothy
    Bere Court Farm Pangbourne
    RG8 8HT Reading
    Berkshire
    United KingdomBritishRetailer106997230001
    ROBSON, William Henry Mark
    90 Springfield Road
    SL4 3PH Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    90 Springfield Road
    SL4 3PH Windsor
    Berkshire
    BritishFinancial Director57803420001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Amministratore delegato nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001
    QUICKNESS LIMITED
    Senator House
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4JL London
    Amministratore
    Senator House
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4JL London
    47109420002

    KENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and mortgage debenture
    Creato il 31 mag 2001
    Consegnato il 06 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All actual, contingent, present and/or future obligations and liabilities of the company to the chargee and each of the secured parties
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Agent and Security Trustee for Itself and the Secured Parties (as Defined) (the "Security Trustee")
    Transazioni
    • 06 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 mag 1999
    Consegnato il 21 mag 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that l/h property k/a 105A junction road andover hampshire and the proceeds of sale all planat machinery fixtures and fittings goodwill and the benefit of the option dated 18/05/99.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 apr 1999
    Consegnato il 12 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Premises known as the maisonette/shop at 2/3 atholl court,kingsway gardens andover; see form 395. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 feb 1999
    Consegnato il 25 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 150A junction road andover hampshire the benefit of the option dated 23 february 1999 between the company and alldays stores limited. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 25 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 gen 1999
    Consegnato il 28 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Ground floor shop and first floor office premises at 5 queens road farnborough hants. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 28 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 gen 1999
    Consegnato il 07 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Ground floor shop premises and first and second floor maisonettes at 1/5 elizabeth parade tudor drive yateley hants. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 nov 1998
    Consegnato il 24 nov 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 570 wokingham road earley reading-BK84581 assigned the benefit of the option dated 10TH november 1998 between the company and alldays stores limited relating to the property (the option). By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 24 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 nov 1998
    Consegnato il 09 nov 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property at 8 alexandra road north camp farnborough hampshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 09 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of variation to a legal charge dated 21 august 1998
    Creato il 20 ott 1998
    Consegnato il 28 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property means the ground floor shop premises at 286 gosbrook road caversham reading berkshire.. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 28 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 set 1998
    Consegnato il 30 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Leasehold property k/a 109/113 queens road aldershot hampshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 set 1998
    Consegnato il 18 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at ash street ash surrey. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 18 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 21 ago 1998
    Consegnato il 09 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Piece or parcel of land at the ground floor shop premises at 286 gosbrook road caversham reading berkshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 09 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 giu 1998
    Consegnato il 15 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Ground floor shop premises at 1 and 2 giles court brookside walk tadley hampshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 mar 1998
    Consegnato il 18 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this legal charge
    Brevi particolari
    The company charges the property being land at ground floor shop premises at 53 high street aldershot hampshire GU11 1BH t/n-HP371495 (to the full extent of the company's interest in the property or its proceeds of sale) by way of legal mortagage of all legal interests and otherwise by way of specific equitable charge, assigned the benefit of all covenants and rights affecting or concerning the property subject to re-assignment on redemption, by way of fixed charge all the plant machinery and fixtures and fittings equipment and utensils, all the present or future goodwill of any business.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 18 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 dic 1997
    Consegnato il 24 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a ground floor and basement 55/57 erleigh road reading berkshire the goodwill of the business and the benefit of the option dated 23 december 1997 between the company and alldays stores limited. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 24 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 nov 1997
    Consegnato il 19 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Ground floor and basement at 133/135 oxford road reading berkshire RG1 7UU t/n BK285171 all legal ineterests and otherwise by specific equitable charge assinged the benefit of all covenants and rights fixed charge all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements utensils all present or future goodwill of any business assigns the benefit of the option of even date.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 19 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 21 ott 1997
    Consegnato il 24 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease dated 5TH february 1990
    Brevi particolari
    The rent deposit being an amount equal to 6 months rent from time to time firstly reserved by the lease being at the date of creation of the charge a deposit of £6,500.
    Persone aventi diritto
    • Double Reading Limited
    Transazioni
    • 24 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 15 ott 1997
    Consegnato il 24 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    That piece or parcel of land at 1 anstey close, basingstoke, hampshire and the goodwill of any business. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 24 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 set 1997
    Consegnato il 12 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Piece or parcel of land at 27/31 high street chobham surrey. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 set 1997
    Consegnato il 12 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Piece or parcel of land at 37 guildford road lightwater surrey. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 ago 1997
    Consegnato il 27 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    That piece or parcel of land at 8 alexandra road north camp farnborough hants t/no.HP527455 and goodwill of any business.. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 27 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 ago 1997
    Consegnato il 22 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a 132 cove road farnborough hants t/no HP504574 by way of fixed charge all the present or future goodwill of any business. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 ago 1997
    Consegnato il 22 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 lug 1997
    Consegnato il 28 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Alldays Stores Limited
    Transazioni
    • 28 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 lug 1997
    Consegnato il 28 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Alldays Franchising Limited
    Transazioni
    • 28 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0