MINORPLANET SYSTEMS PLC

MINORPLANET SYSTEMS PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMINORPLANET SYSTEMS PLC
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 03372097
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MINORPLANET SYSTEMS PLC?

    • (7415) /

    Dove si trova MINORPLANET SYSTEMS PLC?

    Indirizzo della sede legale
    BDO LLP
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MINORPLANET SYSTEMS PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PIXIEDEAL PLC16 mag 199716 mag 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di MINORPLANET SYSTEMS PLC?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ago 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per MINORPLANET SYSTEMS PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    17 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 ott 2017

    17 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Bdo Llp 1 Bridgewater Place Water Lane Leeds West Yorkshire LS11 5RU a Central Square 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL in data 20 apr 2017

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 ott 2016

    11 pagine4.68

    Domanda di insolvenza

    INSOLVENCY:Sec. Of State Cert of Release of Liquidator
    1 pagineLIQ MISC

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:co to remove/replace liquidator
    13 pagineLIQ MISC OC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 ott 2015

    23 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 ott 2014

    17 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 ott 2013

    19 pagine4.68

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 30 ott 2012

    10 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    1 pagine2.34B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 08 mag 2012

    12 pagine2.24B

    Risultato della riunione dei creditori

    2 pagine2.23B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    47 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    20 pagine2.16B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 08 nov 2011

    11 pagine2.24B

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 08 nov 2011

    14 pagine2.24B

    Avviso di termine automatico dell'amministrazione

    9 pagine2.30B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 08 nov 2011

    13 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 08 mag 2011

    17 pagine2.24B

    Chi sono gli amministratori di MINORPLANET SYSTEMS PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HOPKIN, Richard
    37 The Meadows
    HX6 2UN Sowerby Bridge
    West Yorkshire
    Segretario
    37 The Meadows
    HX6 2UN Sowerby Bridge
    West Yorkshire
    British12491060010
    DONOVAN, Terence John
    Glebe House
    The Terrace Boston Spa
    LS23 6AH Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    Glebe House
    The Terrace Boston Spa
    LS23 6AH Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish101474510001
    HOPKIN, Richard
    37 The Meadows
    HX6 2UN Sowerby Bridge
    West Yorkshire
    Amministratore
    37 The Meadows
    HX6 2UN Sowerby Bridge
    West Yorkshire
    EnglandBritish12491060010
    HURLEY, Carolanne
    Flowery Fields Cottage
    Common Road
    ST8 7SR Biddulph Park
    Flowery Fields Cottage
    Staffs
    Amministratore
    Flowery Fields Cottage
    Common Road
    ST8 7SR Biddulph Park
    Flowery Fields Cottage
    Staffs
    EnglandEnglish80127620002
    WALKER, Andrew William
    The Fields Linton Road
    Collingham
    LS22 5BS Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Fields Linton Road
    Collingham
    LS22 5BS Wetherby
    West Yorkshire
    United KingdomBritish12066700001
    BYWELL, Robert Howard
    Moorlands
    Moorbottom Lane
    BD16 4HA Bingley
    West Yorkshire
    Segretario
    Moorlands
    Moorbottom Lane
    BD16 4HA Bingley
    West Yorkshire
    British72284400001
    KELLY, Robert Daniel
    Stafford House
    33 Stafford Hill Lane
    HD5 0EE Huddersfield
    West Yorkshire
    Segretario
    Stafford House
    33 Stafford Hill Lane
    HD5 0EE Huddersfield
    West Yorkshire
    British71715970001
    KING, Andrew Paul
    12 Princess Mead
    Goldsborough
    HG5 8NP Knaresborough
    N Yorkshire
    Segretario
    12 Princess Mead
    Goldsborough
    HG5 8NP Knaresborough
    N Yorkshire
    British24333360002
    MELTHAM, John David
    Willow Garth
    Howden Croft Hill, Ellerker
    HU15 2DE Brough
    North Humberside
    Segretario
    Willow Garth
    Howden Croft Hill, Ellerker
    HU15 2DE Brough
    North Humberside
    British74570910001
    MULLEN, Kenneth John
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    Segretario
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    Scottish146642810001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Segretario nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    WESTLEX REGISTRARS LIMITED
    21 Southampton Row
    WC1B 5HS London
    Segretario
    21 Southampton Row
    WC1B 5HS London
    39191480001
    ABRAHAMS, Michael David
    Newfield
    Mickley
    HG4 3JH Ripon
    North Yorkshire
    Amministratore
    Newfield
    Mickley
    HG4 3JH Ripon
    North Yorkshire
    EnglandBritish5117870001
    ALEXANDER, Charles Edward
    1 Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    Amministratore
    1 Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    British32134300001
    BENNETT, Philip William
    Scalvert Parade
    Newport
    New South Wales 2106
    Amministratore
    Scalvert Parade
    Newport
    New South Wales 2106
    Australian130990430001
    BEST, David Martin
    34 Vicarage Meadows
    WF14 9JL Mirfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    34 Vicarage Meadows
    WF14 9JL Mirfield
    West Yorkshire
    EnglandBritish47892490001
    FISH, Graham Stewart
    The Old School House
    Church Street
    LE17 6EZ North Kilworth
    Leicester
    Amministratore
    The Old School House
    Church Street
    LE17 6EZ North Kilworth
    Leicester
    United KingdomBritish181919010001
    GAUNT, David Benjamin
    1a Saint Winifreds Road
    HG2 8LN Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    1a Saint Winifreds Road
    HG2 8LN Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish91939970001
    HARRISON, Christopher Gerard, Professor
    11 Ringley Park
    Whitefield
    M45 7NT Manchester
    Amministratore
    11 Ringley Park
    Whitefield
    M45 7NT Manchester
    EnglandBritish50288450002
    JACOMB, Martin Wakefield
    Manor Cottage
    Mill Lane, Adderbury
    OX17 3LW Banbury
    Oxfordshire
    Amministratore
    Manor Cottage
    Mill Lane, Adderbury
    OX17 3LW Banbury
    Oxfordshire
    British75361610004
    JARVIS, John Michael
    2 Greystone Park
    TN14 6EB Sundridge
    Kent
    Amministratore
    2 Greystone Park
    TN14 6EB Sundridge
    Kent
    EnglandBritish80470600001
    KEATING, James
    Robinscourt
    Model Farm Road
    IRISH Cork
    County Cork
    Ireland
    Amministratore
    Robinscourt
    Model Farm Road
    IRISH Cork
    County Cork
    Ireland
    IrelandIrish34330720001
    KELLY, Neil
    Beverley 22 Hill Top Road
    Stockton Heath
    WA4 2EF Warrington
    Amministratore
    Beverley 22 Hill Top Road
    Stockton Heath
    WA4 2EF Warrington
    EnglandBritish11745350004
    KELLY, Robert Daniel
    Stafford House
    33 Stafford Hill Lane
    HD5 0EE Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Stafford House
    33 Stafford Hill Lane
    HD5 0EE Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritish71715970001
    KING, Andrew Paul
    12 Princess Mead
    Goldsborough
    HG5 8NP Knaresborough
    N Yorkshire
    Amministratore
    12 Princess Mead
    Goldsborough
    HG5 8NP Knaresborough
    N Yorkshire
    British24333360002
    MACEY, John Dennis
    27 Whitegates Crescent
    Willaston
    L64 2UX South Wirral
    Amministratore
    27 Whitegates Crescent
    Willaston
    L64 2UX South Wirral
    British51013920001
    MCBRIDE, John Kristian Lars
    61 Arthur Road
    Wimbledon
    SW19 7DN London
    Amministratore
    61 Arthur Road
    Wimbledon
    SW19 7DN London
    EnglandBritish54651830001
    MELTHAM, John David
    Willow Garth
    Howden Croft Hill, Ellerker
    HU15 2DE Brough
    North Humberside
    Amministratore
    Willow Garth
    Howden Croft Hill, Ellerker
    HU15 2DE Brough
    North Humberside
    United KingdomBritish74570910001
    MORRIS, Jeffrey Clive
    Moor End Farm
    Harewood Avenue
    LS17 9HL East Keswick
    Leeds
    Amministratore
    Moor End Farm
    Harewood Avenue
    LS17 9HL East Keswick
    Leeds
    United KingdomBritish10648420001
    PERRY, David Gordon
    Deighton House
    York Road
    YO19 6HQ Deighton
    York
    Amministratore
    Deighton House
    York Road
    YO19 6HQ Deighton
    York
    British6323460001
    SPOONER, James Douglas, Sir
    Swire House
    59 Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    Amministratore
    Swire House
    59 Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    British35374990005
    TILLMAN, Andrew Daniel
    Hill Dean
    Barrowby Lane Kirby Overblow
    HG3 1HQ Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Hill Dean
    Barrowby Lane Kirby Overblow
    HG3 1HQ Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish36748120001
    WOODS, Lucy Ann
    Ballencrief Road
    RG27 8JY Sunningdale
    Windlestream Cottage
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ballencrief Road
    RG27 8JY Sunningdale
    Windlestream Cottage
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish89944470003
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Amministratore delegato nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Amministratore
    120 East Road
    N1 6AA London
    38524190001

    MINORPLANET SYSTEMS PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge over shares
    Creato il 13 mag 2010
    Consegnato il 01 giu 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its right title and interest in and to the securities all dividends all stocks shares and the securities system rights see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Digicore International Holdings Bv
    Transazioni
    • 01 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 09 feb 2010
    Consegnato il 19 feb 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Tcjm Limited
    Transazioni
    • 19 feb 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 03 set 2009
    Consegnato il 12 set 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Asbury Park S.A.R.L
    Transazioni
    • 12 set 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 04 set 2008
    Consegnato il 09 set 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 09 set 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 26 set 2006
    Consegnato il 29 set 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All monies standing to the credit of a deposit account pursuant to the terms of the rent deposit deed.
    Persone aventi diritto
    • Sanderson Logistics Limited
    Transazioni
    • 29 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 16 mag 2006
    Consegnato il 20 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 28 giu 2005
    Consegnato il 18 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Ge Capital Equity Holdings Inc & Terence Donovan
    Transazioni
    • 18 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 15 nov 2004
    Consegnato il 27 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Capital Equity Holdings, Inc (As Security Trustee for the Secured Creditors)
    Transazioni
    • 27 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge/security over shares
    Creato il 13 gen 2004
    Consegnato il 22 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All securities and their proceeds of sale, all dividends, interest and other distributions paid in respect of the securities. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 set 2002
    Consegnato il 18 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a 2 and 4 meanwood road leeds t/no WYK532960. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Escrow account charge
    Creato il 11 giu 2002
    Consegnato il 11 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    With full title guarantee charges by way of first fixed charge to hfgl all of its right title and interest in and to the account of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hfgl Limited
    Transazioni
    • 11 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 feb 2002
    Consegnato il 15 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a city garage manor street sheepscar leeds t/no WYK456290. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 21 nov 2001
    Consegnato il 23 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a peregrine house gelderd close gelderd road leeds t/n WYK301906. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 ott 1997
    Consegnato il 31 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    MINORPLANET SYSTEMS PLC ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    09 nov 2010Inizio dell'amministrazione
    08 nov 2011Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Francis Graham Newton
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Dermot Justin Power
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    2
    DataTipo
    09 nov 2011Inizio dell'amministrazione
    30 ott 2012Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Dermot Justin Power
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Francis Graham Newton
    Bdo Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5RU Water Lane
    Leeds
    Praticante
    Bdo Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5RU Water Lane
    Leeds
    3
    DataTipo
    30 ott 2012Inizio della liquidazione
    08 set 2018Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Dermot Justin Power
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Francis Graham Newton
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Kerry Bailey
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    Praticante
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0