John Michael JARVIS
Persona fisica
| Titolo | Mr |
|---|---|
| Nome | John |
| Secondo nome | Michael |
| Cognome | JARVIS |
| Data di nascita | |
| È un dirigente societario | No |
| Incarichi | |
| Attivo | 1 |
| Inattivo | 5 |
| Dimesso | 15 |
| Totale | 21 |
Incarichi
| Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REMATCH CREDIT LTD | 03 ago 2015 | Liquidazione | Amministratore | 110 Cannon Street EC4N 6EU London 2nd Floor | England | British | ||
| TWO MINUTES TO MIDNIGHT LIMITED | 17 gen 2014 | Sciolta | Amministratore | Greystone Park TN14 6EB Sundridge 2 Kent England | England | British | ||
| E-SYNERGY LIMITED | 20 mar 2013 | Sciolta | Amministratore | Swan Street LE12 7NN Sileby 109 Leicestershire | England | British | ||
| EIDC LIMITED | 04 feb 2011 | Sciolta | Amministratore | Main Road BH20 5RJ West Lulworth Breach House Dorset United Kingdom | England | British | ||
| SUCCESS IN RECOVERY LIMITED | 09 set 2008 | Sciolta | Amministratore | 2 Greystone Park TN14 6EB Sundridge Kent | England | British | ||
| SUCCESS IN RECOVERY LIMITED | 29 feb 2008 | Sciolta | Segretario | 2 Greystone Park TN14 6EB Sundridge Kent | British | |||
| NCIMB LIMITED | 21 feb 2019 | 08 set 2023 | Attiva | Amministratore | Wellheads Place Dyce AB21 7GB Aberdeen . Scotland | England | British | |
| INTOUCH WITH HEALTH LIMITED | 28 mar 2013 | 19 ago 2020 | Sciolta | Amministratore | Floor 39-41 Charing Cross Road WC2H 0AR London 3rd England | England | British | |
| PERSCITUS LLP | 03 ott 2016 | 24 giu 2019 | Attiva | Socio designato di LLP | Buckingham Street WC2N 6DF London 10 England | England | ||
| MANOLETE PARTNERS PLC | 05 ott 2012 | 19 nov 2018 | Attiva | Amministratore | Greystone Park TN14 6EB Sundridge 2 Kent England | England | British | |
| POWERLINE TECHNOLOGIES LTD | 22 nov 2013 | 29 ott 2015 | Attiva | Amministratore | Greystone Park Sundridge TN14 6EB Sevenoaks 2 Kent England | England | British | |
| POWERLINE DEVELOPMENTS LTD | 22 nov 2013 | 29 ott 2015 | Attiva | Amministratore | Greystone Park Sundridge TN14 6EB Sevenoaks 2 Kent England | England | British | |
| BARCHESTER PLACE (EASTBOURNE) LIMITED | 07 mag 2004 | 10 set 2015 | Attiva | Amministratore | 2 Greystone Park TN14 6EB Sundridge Kent | England | British | |
| V12 PERSONAL FINANCE LIMITED | 04 feb 2011 | 02 gen 2013 | Attiva | Amministratore | Arleston Way Shirley B90 4LH Solihull One West Midlands United Kingdom | England | British | |
| V12 FINANCE GROUP LIMITED | 04 feb 2011 | 02 gen 2013 | Attiva | Amministratore | Neptune Court Vanguard Way CF24 5PJ Cardiff Unit 19-20 City Of Cardiff | England | British | |
| V12 RETAIL FINANCE LIMITED | 04 feb 2011 | 02 gen 2013 | Attiva | Amministratore | Arleston Way Shirley B90 4LH Solihull One West Midlands United Kingdom | England | British | |
| INTERNATIONAL IMAGES LIMITED | 27 lug 2006 | 09 lug 2007 | Sciolta | Amministratore | 2 Greystone Park TN14 6EB Sundridge Kent | England | British | |
| OXFORD GENE TECHNOLOGY (OPERATIONS) LTD | 31 gen 2002 | 31 mag 2005 | Attiva | Amministratore | 2 Greystone Park TN14 6EB Sundridge Kent | England | British | |
| OXFORD GENE TECHNOLOGY LIMITED | 31 gen 2002 | 31 mag 2005 | Attiva | Amministratore | 2 Greystone Park TN14 6EB Sundridge Kent | England | British | |
| OXFORD GENE TECHNOLOGY IP LIMITED | 17 gen 2002 | 31 mag 2005 | Attiva | Amministratore | 2 Greystone Park TN14 6EB Sundridge Kent | England | British | |
| MINORPLANET SYSTEMS PLC | 16 nov 1998 | 21 set 1999 | Sciolta | Amministratore | 2 Greystone Park TN14 6EB Sundridge Kent | England | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0