GRAND CENTRAL BROADCASTING LIMITED

GRAND CENTRAL BROADCASTING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGRAND CENTRAL BROADCASTING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03459102
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GRAND CENTRAL BROADCASTING LIMITED?

    • Radiodiffusione (60100) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova GRAND CENTRAL BROADCASTING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 London Bridge Street
    SE1 9GF London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di GRAND CENTRAL BROADCASTING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 giu 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per GRAND CENTRAL BROADCASTING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 lug 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 giu 2020

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 lug 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2019

    5 pagineAA

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 lug 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 01 lug 2018

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 lug 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Scott William Taunton il 02 mar 2018

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2017

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di Anthony David Tompkins come amministratore in data 30 set 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 lug 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Cessazione della carica di Norman Mckeown come amministratore in data 30 apr 2017

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2016 al 30 giu 2017

    1 pagineAA01

    Nomina di Mr Michael Charles Gill come amministratore in data 30 nov 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Anthony Tompkins come segretario in data 30 nov 2016

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Christopher Charles Stoddart Longcroft come amministratore in data 30 nov 2016

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Scott William Taunton il 19 dic 2016

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 dic 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Ground Floor 401 Faraday Street, Birchwood Park Warrington WA3 6GA England a 1 London Bridge Street London SE1 9GF in data 02 dic 2016

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di John Mccann come amministratore in data 12 mag 2016

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di GRAND CENTRAL BROADCASTING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GILL, Michael Charles
    London Bridge Street
    SE1 9GF London
    1
    England
    Amministratore
    London Bridge Street
    SE1 9GF London
    1
    England
    United KingdomBritish123013340001
    LONGCROFT, Christopher Charles Stoddart
    London Bridge Street
    SE1 9GF London
    1
    England
    Amministratore
    London Bridge Street
    SE1 9GF London
    1
    England
    EnglandBritish163116880001
    TAUNTON, Scott William
    London Bridge Street
    SE1 9GF London
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    London Bridge Street
    SE1 9GF London
    1
    United Kingdom
    United KingdomAustralian80505610007
    CHADWICK, Jane Wendy
    Rivendell
    Riddings Lane
    S32 3YD Curbar
    Segretario
    Rivendell
    Riddings Lane
    S32 3YD Curbar
    British43025160002
    DOWNEY, James Robinson
    33 Karrington Heights
    Comber Road Dundonald
    BT16 1XZ Belfast
    County Antrim
    Northern Ireland
    Segretario
    33 Karrington Heights
    Comber Road Dundonald
    BT16 1XZ Belfast
    County Antrim
    Northern Ireland
    British107097580001
    FRANCIS, Sharon Lesley
    3 Primrose Close
    DL16 7YE Spennymoor
    County Durham
    Segretario
    3 Primrose Close
    DL16 7YE Spennymoor
    County Durham
    British72419260001
    LAWRENCE, Eric Alexander
    26 Foxhills Covert
    Whickham
    NE16 5TN Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    26 Foxhills Covert
    Whickham
    NE16 5TN Newcastle Upon Tyne
    British4250810002
    REED, Stuart William
    The Dingle
    Dingle Lane Nether Whitacre
    B46 2EE Coleshill
    Warwickshire
    Segretario
    The Dingle
    Dingle Lane Nether Whitacre
    B46 2EE Coleshill
    Warwickshire
    British47858000001
    SADLER, Keith John
    12 Parrys Grove
    Stoke Bishop
    BS9 1TT Bristol
    Avon
    Segretario
    12 Parrys Grove
    Stoke Bishop
    BS9 1TT Bristol
    Avon
    British73173100006
    TOMPKINS, Anthony
    London Bridge Street
    SE1 9GF London
    1
    England
    Segretario
    London Bridge Street
    SE1 9GF London
    1
    England
    165681310001
    NOMINEE SECRETARIES LTD
    3 Garden Walk
    EC2A 3EQ London
    Segretario nominato
    3 Garden Walk
    EC2A 3EQ London
    900006780001
    BODDY, Pamela Anne
    One Ash Farm
    Cowley
    S18 7SD Holmesfield
    Dronfield
    Derbys
    Amministratore
    One Ash Farm
    Cowley
    S18 7SD Holmesfield
    Dronfield
    Derbys
    British60188530001
    CAPLAN, Rex
    Freebirch House Freebirch
    Eastmoor
    S42 7DQ Chesterfield
    Derbyshire
    Amministratore
    Freebirch House Freebirch
    Eastmoor
    S42 7DQ Chesterfield
    Derbyshire
    EnglandBritish15713290002
    CHADBOURNE, Paul
    Cedar Barn
    West Moor Road Walkeringham
    DN10 4LR Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    Cedar Barn
    West Moor Road Walkeringham
    DN10 4LR Doncaster
    South Yorkshire
    United KingdomBritish93737960001
    CHADWICK, Wayne Anthony
    Bank House
    Riverside Crescent
    DE45 1HF Bakewell
    Derbyshire
    Amministratore
    Bank House
    Riverside Crescent
    DE45 1HF Bakewell
    Derbyshire
    British43025120002
    DARCH, Jonathan Robert
    Ivy Dene Main Street
    Elvington
    YO4 5AA York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Ivy Dene Main Street
    Elvington
    YO4 5AA York
    North Yorkshire
    British40673150001
    DOWNEY, James Robinson
    33 Karrington Heights
    Comber Road Dundonald
    BT16 1XZ Belfast
    County Antrim
    Northern Ireland
    Amministratore
    33 Karrington Heights
    Comber Road Dundonald
    BT16 1XZ Belfast
    County Antrim
    Northern Ireland
    United KingdomBritish107097580001
    ECKERSLEY, Mark Robert
    421 Whirlowdale Road
    S11 9NG Sheffield
    Amministratore
    421 Whirlowdale Road
    S11 9NG Sheffield
    British14188210002
    EVANS, Barrie
    Middle Barley Wilkin Hill
    Barlow
    S18 7TE Dronfield
    Derbyshire
    Amministratore
    Middle Barley Wilkin Hill
    Barlow
    S18 7TE Dronfield
    Derbyshire
    EnglandBritish3935910001
    EVANS, Barrie
    Middle Barley Wilkin Hill
    Barlow
    S18 7TE Dronfield
    Derbyshire
    Amministratore
    Middle Barley Wilkin Hill
    Barlow
    S18 7TE Dronfield
    Derbyshire
    EnglandBritish3935910001
    FRANCIS, Sharon Lesley
    3 Primrose Close
    DL16 7YE Spennymoor
    County Durham
    Amministratore
    3 Primrose Close
    DL16 7YE Spennymoor
    County Durham
    British72419260001
    JOSEPHS, John Irving
    22 Osbaldeston Gardens
    NE3 4JE Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    22 Osbaldeston Gardens
    NE3 4JE Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish3830990001
    KILNER, David Mark
    2 Woburn Place
    S11 9QS Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    2 Woburn Place
    S11 9QS Sheffield
    South Yorkshire
    British54108900001
    LAWRENCE, Eric Alexander
    26 Foxhills Covert
    Whickham
    NE16 5TN Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    26 Foxhills Covert
    Whickham
    NE16 5TN Newcastle Upon Tyne
    British4250810002
    MACDONALD, William Symon
    12 Kingsley Park Grove
    S11 9HL Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    12 Kingsley Park Grove
    S11 9HL Sheffield
    South Yorkshire
    British8503500001
    MACKENZIE, Ashley Calder
    6 Springshaw Close
    TN13 2QE Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    6 Springshaw Close
    TN13 2QE Sevenoaks
    Kent
    British59529980005
    MACKENZIE, Kelvin Calder
    Christophers
    Lockstone Close
    KT13 8EF Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    Christophers
    Lockstone Close
    KT13 8EF Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritish141795340001
    MCCANN, John
    175 Malone Road
    BT9 6TB Belfast
    County Antrim
    Northern Ireland
    Amministratore
    175 Malone Road
    BT9 6TB Belfast
    County Antrim
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish75447990001
    MCKEOWN, Norman
    Ormeau Road
    BT7 1EB Belfast
    Havelock House
    Northern Ireland
    Amministratore
    Ormeau Road
    BT7 1EB Belfast
    Havelock House
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish165664890001
    MCNERNEY, Peter James
    44 Wheel Lane
    Grenoside
    S35 8RN Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    44 Wheel Lane
    Grenoside
    S35 8RN Sheffield
    South Yorkshire
    British58684010001
    REED, Stuart William
    The Dingle
    Dingle Lane Nether Whitacre
    B46 2EE Coleshill
    Warwickshire
    Amministratore
    The Dingle
    Dingle Lane Nether Whitacre
    B46 2EE Coleshill
    Warwickshire
    British47858000001
    SADLER, Keith John
    12 Parrys Grove
    Stoke Bishop
    BS9 1TT Bristol
    Avon
    Amministratore
    12 Parrys Grove
    Stoke Bishop
    BS9 1TT Bristol
    Avon
    British73173100006
    SHAW, Barry
    18 Ayzgarth Rise
    YO16 7HX Bridlington
    East Yorkshire
    Amministratore
    18 Ayzgarth Rise
    YO16 7HX Bridlington
    East Yorkshire
    British96413730001
    TOMPKINS, Anthony David
    London Bridge Street
    SE1 9GF London
    1
    England
    Amministratore
    London Bridge Street
    SE1 9GF London
    1
    England
    EnglandBritish165684030001
    NOMINEE DIRECTORS LTD
    3 Garden Walk
    EC2A 3EQ London
    Amministratore delegato nominato
    3 Garden Walk
    EC2A 3EQ London
    900006850001

    Chi sono le persone con controllo significativo di GRAND CENTRAL BROADCASTING LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    London Bridge Street
    SE1 9GF London
    1
    England
    06 apr 2016
    London Bridge Street
    SE1 9GF London
    1
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 1989
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03844914
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    GRAND CENTRAL BROADCASTING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 14 ott 2002
    Consegnato il 22 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • John Mark
    Transazioni
    • 22 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 set 2002
    Consegnato il 02 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts, uncalled capital, buildings, fixtures and fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • John Mark
    Transazioni
    • 02 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 nov 2001
    Consegnato il 24 nov 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 24 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 feb 2003Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage debenture
    Creato il 03 mar 1999
    Consegnato il 09 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mar 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 09 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0