UK GENERAL (AIS) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | UK GENERAL (AIS) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03487744 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di UK GENERAL (AIS) LIMITED?
- Assicurazioni diverse da quelle sulla vita (65120) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova UK GENERAL (AIS) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Cast House Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds West Yorkshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di UK GENERAL (AIS) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ACUMUS INSURANCE SOLUTIONS LIMITED | 13 dic 2004 | 13 dic 2004 |
| PRIMARY DIRECT LIMITED | 26 ott 1998 | 26 ott 1998 |
| DIRECT RESPONSE HOLDINGS LIMITED | 02 gen 1998 | 02 gen 1998 |
Quali sono gli ultimi bilanci di UK GENERAL (AIS) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per UK GENERAL (AIS) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 gen 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016 | 2 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Stephen Blott come segretario in data 24 mar 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Nomina di Mrs Penny Fullerton come segretario in data 24 mar 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Peter John Hubbard come amministratore in data 29 feb 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 02 gen 2016 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessazione della carica di Jeffrey Christopher Orton come segretario in data 01 nov 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Stephen Blott come segretario in data 01 nov 2015 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015 | 2 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 02 gen 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014 | 2 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Michael Warren come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Jeffrey Christopher Orton come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Penelope Fullerton come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 02 gen 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomina di Mr Ryan Mark Gill come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Mrs Penelope Jane Fullerton come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Stacey Zaczkiewicz come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013 | 2 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 02 gen 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed acumus insurance solutions LIMITED\certificate issued on 18/10/12 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2012 | 6 pagine | AA | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di UK GENERAL (AIS) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FULLERTON, Penny | Segretario | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | 206866120001 | |||||||
| BEALES, Karen Anne | Amministratore | Marling Road Ainley Top HD2 2EE Huddersfield The Chalet Uk | England | British | 135540180002 | |||||
| GILL, Ryan Mark | Amministratore | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | England | British | 184068890001 | |||||
| SMITH, Malachy Paul | Amministratore | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | Ireland | Irish | 262619320001 | |||||
| BLOTT, Stephen | Segretario | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | 202286350001 | |||||||
| BLOTT, Stephen | Segretario | Low Wood Wilsden BD15 0JS Bradford 30 West Yorkshire England | British | 139352410001 | ||||||
| FULLERTON, Penelope Jane | Segretario | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | 184069340001 | |||||||
| KEILL, Tracy Elizabeth | Segretario | 'Verandah House' 8 Pokiok Road Smith's Fl05 Bermuda | British | 127332980001 | ||||||
| MCMAHON, Andrew Neil Mcintyre | Segretario | 39 Lynwood Grove BR6 0BD Orpington Kent | British | 75598460002 | ||||||
| NEWELL, Mark Verity | Segretario | Moffat Pains Hill Limpsfield Chart RH8 0RG Oxted Surrey | British | 77855100001 | ||||||
| NEWELL, Mark Verity | Segretario | Moffat Pains Hill Limpsfield Chart RH8 0RG Oxted Surrey | British | 77855100001 | ||||||
| ORTON, Jeffrey Christopher | Segretario | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | 185563130001 | |||||||
| WEAVER, Clare Louise | Segretario | 27 Scholars Walk GU2 7TR Guildford Surrey | British | 66552530002 | ||||||
| ZACZKIEWICZ, Stacey | Segretario | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | 170322820001 | |||||||
| EVERSECRETARY LIMITED | Segretario | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 60471940015 | |||||||
| SEVERNSIDE SECRETARIAL LIMITED | Segretario nominato | 14-18 City Road CF24 3DL Cardiff | 900003990001 | |||||||
| BERRY, Timothy Andrew | Amministratore | The Coach House Lodge Lane WA4 4HP Dutton Cheshire | United Kingdom | British | 44238370004 | |||||
| BIBBY, John Brian | Amministratore | Keltie Cottage Alcocks Lane KT20 6BA Kingswood Surrey | United Kingdom | British | 238819530001 | |||||
| BIBBY, John | Amministratore | Downway House Fir Tree Lane RH20 2RA West Chiltington West Sussex | British | 27995540002 | ||||||
| BRADBURY, Susan Patricia | Amministratore | Causeway Foot Rochdale Road Pole Moor Outlane HD3 3FQ Huddersfield West Yorkshire | United Kingdom | British | 40471660002 | |||||
| DWYER, Helen Mary | Amministratore | The Coach House Lodge Lane Dutton WA4 4HP Warrington Cheshire | England | British | 74301990001 | |||||
| HARNBY, Alastair John | Amministratore | Dene Bank BD16 4AR Bingley 21 West Yorkshire Uk | United Kingdom | British | 172070220002 | |||||
| HODES, Jonathan | Amministratore | 81 Lauderdale Mansions Lauderdale Road W9 1LX London | British | 79523100001 | ||||||
| HUBBARD, Peter John | Amministratore | Sevenleaze Lane Edge GL6 6NL Stroud Huddaknoll House Gloucestershire United Kingdom | England | British | 28375870003 | |||||
| JAMES, Philip William Henry | Amministratore | Hampton Head 9 Peppercorn Lane Southampton Sn 04 Bermuda | England | British | 33901640008 | |||||
| KEILL, Tracy Elizabeth | Amministratore | 'Verandah House' 8 Pokiok Road Smith's Fl05 Bermuda | British | 127332980001 | ||||||
| KING, Michael Henry | Amministratore | 45 Leicester Road Wanstead E11 2DW London | British | 14395670002 | ||||||
| LAIRD, Oliver Walter | Amministratore | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | United Kingdom | British | 233726140001 | |||||
| LEATHERBY, Stuart | Amministratore | 122 Shelford Road Trumpington CB2 2NF Cambridge Cambridgeshire | British | 79421100001 | ||||||
| MARLEY, Nicholas James | Amministratore | 6 The Brambles Woodside SW19 7AY London | United Kingdom | British | 113304050001 | |||||
| MCMAHON, Andrew Neil Mcintyre | Amministratore | 39 Lynwood Grove BR6 0BD Orpington Kent | England | British | 75598460002 | |||||
| NEWELL, Mark Verity | Amministratore | Moffat Pains Hill Limpsfield Chart RH8 0RG Oxted Surrey | British | 77855100001 | ||||||
| NICHOL, Duncan Kirkbride, Sir | Amministratore | 1 Pipers Close CH60 9LJ Heswall Merseyside | United Kingdom | British | 85618250001 | |||||
| POSNER, Howard Michael | Amministratore | Stocks Lane HX2 6PR Luddenden Eaves House Halifax | United Kingdom | British | 139631580001 | |||||
| ROLFE, Timothy Paul | Amministratore | 9 Overhill CR6 9JR Warlingham Surrey | England | British | 107872640001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di UK GENERAL (AIS) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uk General Insurance Limited | 06 apr 2016 | Gibraltar Island Road, Old Mill Business Park LS10 1RJ Leeds Cast House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
UK GENERAL (AIS) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 30 gen 2007 Consegnato il 15 feb 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari (For details of properties charged please refer to the form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 18 gen 2006 Consegnato il 02 feb 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0