UK GENERAL (AIS) LIMITED

UK GENERAL (AIS) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàUK GENERAL (AIS) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03487744
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di UK GENERAL (AIS) LIMITED?

    • Assicurazioni diverse da quelle sulla vita (65120) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova UK GENERAL (AIS) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Cast House Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di UK GENERAL (AIS) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ACUMUS INSURANCE SOLUTIONS LIMITED13 dic 200413 dic 2004
    PRIMARY DIRECT LIMITED26 ott 199826 ott 1998
    DIRECT RESPONSE HOLDINGS LIMITED02 gen 199802 gen 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di UK GENERAL (AIS) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per UK GENERAL (AIS) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 gen 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016

    2 pagineAA

    Cessazione della carica di Stephen Blott come segretario in data 24 mar 2016

    1 pagineTM02

    Nomina di Mrs Penny Fullerton come segretario in data 24 mar 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Peter John Hubbard come amministratore in data 29 feb 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 02 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 gen 2016

    Stato del capitale al 19 gen 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Cessazione della carica di Jeffrey Christopher Orton come segretario in data 01 nov 2015

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Stephen Blott come segretario in data 01 nov 2015

    2 pagineAP03

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 gen 2015

    Stato del capitale al 28 gen 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    2 pagineAA

    Cessazione della carica di Michael Warren come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Jeffrey Christopher Orton come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Penelope Fullerton come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 02 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 gen 2014

    Stato del capitale al 16 gen 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Nomina di Mr Ryan Mark Gill come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mrs Penelope Jane Fullerton come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Stacey Zaczkiewicz come segretario

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed acumus insurance solutions LIMITED\certificate issued on 18/10/12
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name18 ott 2012

    Risoluzione di cambio di nome della società il 17 ott 2012

    RES15
    change-of-name18 ott 2012

    Cambio di nome" per delibera

    NM01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2012

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di UK GENERAL (AIS) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FULLERTON, Penny
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Segretario
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    206866120001
    BEALES, Karen Anne
    Marling Road
    Ainley Top
    HD2 2EE Huddersfield
    The Chalet
    Uk
    Amministratore
    Marling Road
    Ainley Top
    HD2 2EE Huddersfield
    The Chalet
    Uk
    EnglandBritish135540180002
    GILL, Ryan Mark
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Amministratore
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    EnglandBritish184068890001
    SMITH, Malachy Paul
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Amministratore
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    IrelandIrish262619320001
    BLOTT, Stephen
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Segretario
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    202286350001
    BLOTT, Stephen
    Low Wood
    Wilsden
    BD15 0JS Bradford
    30
    West Yorkshire
    England
    Segretario
    Low Wood
    Wilsden
    BD15 0JS Bradford
    30
    West Yorkshire
    England
    British139352410001
    FULLERTON, Penelope Jane
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Segretario
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    184069340001
    KEILL, Tracy Elizabeth
    'Verandah House'
    8 Pokiok Road
    Smith's
    Fl05
    Bermuda
    Segretario
    'Verandah House'
    8 Pokiok Road
    Smith's
    Fl05
    Bermuda
    British127332980001
    MCMAHON, Andrew Neil Mcintyre
    39 Lynwood Grove
    BR6 0BD Orpington
    Kent
    Segretario
    39 Lynwood Grove
    BR6 0BD Orpington
    Kent
    British75598460002
    NEWELL, Mark Verity
    Moffat Pains Hill
    Limpsfield Chart
    RH8 0RG Oxted
    Surrey
    Segretario
    Moffat Pains Hill
    Limpsfield Chart
    RH8 0RG Oxted
    Surrey
    British77855100001
    NEWELL, Mark Verity
    Moffat Pains Hill
    Limpsfield Chart
    RH8 0RG Oxted
    Surrey
    Segretario
    Moffat Pains Hill
    Limpsfield Chart
    RH8 0RG Oxted
    Surrey
    British77855100001
    ORTON, Jeffrey Christopher
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Segretario
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    185563130001
    WEAVER, Clare Louise
    27 Scholars Walk
    GU2 7TR Guildford
    Surrey
    Segretario
    27 Scholars Walk
    GU2 7TR Guildford
    Surrey
    British66552530002
    ZACZKIEWICZ, Stacey
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Segretario
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    170322820001
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Segretario
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    60471940015
    SEVERNSIDE SECRETARIAL LIMITED
    14-18 City Road
    CF24 3DL Cardiff
    Segretario nominato
    14-18 City Road
    CF24 3DL Cardiff
    900003990001
    BERRY, Timothy Andrew
    The Coach House
    Lodge Lane
    WA4 4HP Dutton
    Cheshire
    Amministratore
    The Coach House
    Lodge Lane
    WA4 4HP Dutton
    Cheshire
    United KingdomBritish44238370004
    BIBBY, John Brian
    Keltie Cottage
    Alcocks Lane
    KT20 6BA Kingswood
    Surrey
    Amministratore
    Keltie Cottage
    Alcocks Lane
    KT20 6BA Kingswood
    Surrey
    United KingdomBritish238819530001
    BIBBY, John
    Downway House
    Fir Tree Lane
    RH20 2RA West Chiltington
    West Sussex
    Amministratore
    Downway House
    Fir Tree Lane
    RH20 2RA West Chiltington
    West Sussex
    British27995540002
    BRADBURY, Susan Patricia
    Causeway Foot Rochdale Road
    Pole Moor Outlane
    HD3 3FQ Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Causeway Foot Rochdale Road
    Pole Moor Outlane
    HD3 3FQ Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish40471660002
    DWYER, Helen Mary
    The Coach House
    Lodge Lane Dutton
    WA4 4HP Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    The Coach House
    Lodge Lane Dutton
    WA4 4HP Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish74301990001
    HARNBY, Alastair John
    Dene Bank
    BD16 4AR Bingley
    21
    West Yorkshire
    Uk
    Amministratore
    Dene Bank
    BD16 4AR Bingley
    21
    West Yorkshire
    Uk
    United KingdomBritish172070220002
    HODES, Jonathan
    81 Lauderdale Mansions
    Lauderdale Road
    W9 1LX London
    Amministratore
    81 Lauderdale Mansions
    Lauderdale Road
    W9 1LX London
    British79523100001
    HUBBARD, Peter John
    Sevenleaze Lane
    Edge
    GL6 6NL Stroud
    Huddaknoll House
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Sevenleaze Lane
    Edge
    GL6 6NL Stroud
    Huddaknoll House
    Gloucestershire
    United Kingdom
    EnglandBritish28375870003
    JAMES, Philip William Henry
    Hampton Head
    9 Peppercorn Lane
    Southampton
    Sn 04
    Bermuda
    Amministratore
    Hampton Head
    9 Peppercorn Lane
    Southampton
    Sn 04
    Bermuda
    EnglandBritish33901640008
    KEILL, Tracy Elizabeth
    'Verandah House'
    8 Pokiok Road
    Smith's
    Fl05
    Bermuda
    Amministratore
    'Verandah House'
    8 Pokiok Road
    Smith's
    Fl05
    Bermuda
    British127332980001
    KING, Michael Henry
    45 Leicester Road
    Wanstead
    E11 2DW London
    Amministratore
    45 Leicester Road
    Wanstead
    E11 2DW London
    British14395670002
    LAIRD, Oliver Walter
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Amministratore
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    United KingdomBritish233726140001
    LEATHERBY, Stuart
    122 Shelford Road
    Trumpington
    CB2 2NF Cambridge
    Cambridgeshire
    Amministratore
    122 Shelford Road
    Trumpington
    CB2 2NF Cambridge
    Cambridgeshire
    British79421100001
    MARLEY, Nicholas James
    6 The Brambles
    Woodside
    SW19 7AY London
    Amministratore
    6 The Brambles
    Woodside
    SW19 7AY London
    United KingdomBritish113304050001
    MCMAHON, Andrew Neil Mcintyre
    39 Lynwood Grove
    BR6 0BD Orpington
    Kent
    Amministratore
    39 Lynwood Grove
    BR6 0BD Orpington
    Kent
    EnglandBritish75598460002
    NEWELL, Mark Verity
    Moffat Pains Hill
    Limpsfield Chart
    RH8 0RG Oxted
    Surrey
    Amministratore
    Moffat Pains Hill
    Limpsfield Chart
    RH8 0RG Oxted
    Surrey
    British77855100001
    NICHOL, Duncan Kirkbride, Sir
    1 Pipers Close
    CH60 9LJ Heswall
    Merseyside
    Amministratore
    1 Pipers Close
    CH60 9LJ Heswall
    Merseyside
    United KingdomBritish85618250001
    POSNER, Howard Michael
    Stocks Lane
    HX2 6PR Luddenden
    Eaves House
    Halifax
    Amministratore
    Stocks Lane
    HX2 6PR Luddenden
    Eaves House
    Halifax
    United KingdomBritish139631580001
    ROLFE, Timothy Paul
    9 Overhill
    CR6 9JR Warlingham
    Surrey
    Amministratore
    9 Overhill
    CR6 9JR Warlingham
    Surrey
    EnglandBritish107872640001

    Chi sono le persone con controllo significativo di UK GENERAL (AIS) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Gibraltar Island Road, Old Mill Business Park
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    England
    06 apr 2016
    Gibraltar Island Road, Old Mill Business Park
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione04506493
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    UK GENERAL (AIS) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 30 gen 2007
    Consegnato il 15 feb 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    (For details of properties charged please refer to the form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse,London Branch (Security Agent)
    Transazioni
    • 15 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 gen 2006
    Consegnato il 02 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 02 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0