THE GRAY OX LIMITED
Panoramica
| Nome della società | THE GRAY OX LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03546158 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di THE GRAY OX LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova THE GRAY OX LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Marston's House Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di THE GRAY OX LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 02 ott 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per THE GRAY OX LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 2 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 apr 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 02 ott 2021 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Anne Marie Brennan come segretario in data 05 ott 2021 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mrs Michelle Louise Woodall come segretario in data 05 ott 2021 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Nomina di Edward Hancock come amministratore in data 05 ott 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Robert Anthony Leach come amministratore in data 05 ott 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Hayleigh Lupino come amministratore in data 05 ott 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ralph Graham Findlay come amministratore in data 02 ott 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 03 ott 2020 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 apr 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard James Westwood come amministratore in data 30 ott 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 apr 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 28 set 2019 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 apr 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 29 set 2018 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 apr 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2017 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Peter Dalzell come amministratore in data 29 set 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 apr 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 01 ott 2016 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 apr 2016 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di THE GRAY OX LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOODALL, Michelle Louise | Segretario | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House United Kingdom | 288186670001 | |||||||
| ANDREA, Andrew Andonis | Amministratore | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House West Midlands | England | British | 137383120001 | |||||
| HANCOCK, Edward John | Amministratore | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House United Kingdom | United Kingdom | British | 288133210001 | |||||
| LEACH, Robert Anthony | Amministratore | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House United Kingdom | United Kingdom | British | 194085550001 | |||||
| LUPINO, Hayleigh | Amministratore | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House United Kingdom | United Kingdom | British | 207826950002 | |||||
| BRENNAN, Anne Marie | Segretario | Marston's House WV1 4JT Wolverhampton West Midlands | British | 109935620001 | ||||||
| GRAHAM, Granville | Segretario | 40 Chadwick Lane WF14 8RA Mirfield West Yorkshire | British | 45842190002 | ||||||
| HODGSON, Mark Ian | Segretario | Breeze Hill Portinscale CA12 5RW Keswick Cumbria | British | 97778860001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ANDREW, Derek | Amministratore | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House West Midlands | British | 39071260003 | ||||||
| DALZELL, Peter | Amministratore | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House United Kingdom | England | British | 163616170001 | |||||
| DARBY, Alistair William | Amministratore | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House West Midlands | British | 87846880002 | ||||||
| FINDLAY, Ralph Graham | Amministratore | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marstons House West Midlands | England | British | 129897400001 | |||||
| GRAHAM, Ann Maria | Amministratore | 40 Chadwick Lane WF14 8RA Mirfield West Yorkshire | British | 57762320002 | ||||||
| GRAHAM, Granville | Amministratore | 40 Chadwick Lane WF14 8RA Mirfield West Yorkshire | British | 45842190002 | ||||||
| HOUGHTON, John | Amministratore | 8 Rubbybanks Road CA13 9RG Cockermouth Cumbria | British | 73576380002 | ||||||
| INGLETT, Paul | Amministratore | Marston's House WV1 4JT Wolverhampton West Midlands | British | 81617110002 | ||||||
| OLIVER, Stephen John | Amministratore | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House West Midlands | British | 66123690003 | ||||||
| RYAN, Diane Mary | Amministratore | 47 Headlands Close WF15 7QJ Liversedge West Yorkshire | British | 57762330003 | ||||||
| RYAN, Wayne Glen | Amministratore | 47 Headlands Close WF15 7QJ Liversedge West Yorkshire | British | 57762340003 | ||||||
| STEVENSON, David Robert | Amministratore | Rosemount Burgh By Sands CA5 6AN Carlisle Cumbria | England | British | 91952830001 | |||||
| WESTWOOD, Richard James | Amministratore | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House United Kingdom | England | British | 314691870001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di THE GRAY OX LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marston's Acquisitions Limited | 06 apr 2016 | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
THE GRAY OX LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 30 giu 1998 Consegnato il 17 lug 1998 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 30 giu 1998 Consegnato il 17 lug 1998 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The gray ox,15 hartshead lane,hartshead,near liversedge,west yorkshire WF15 8AL; wyk 520438. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 30 giu 1998 Consegnato il 17 lug 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The boathouse victoria rd,saltaire,shipley,west yorkshire; wyk 252862;. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0