THE GRAY OX LIMITED

THE GRAY OX LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHE GRAY OX LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03546158
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di THE GRAY OX LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova THE GRAY OX LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Marston's House
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di THE GRAY OX LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al02 ott 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per THE GRAY OX LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 apr 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 02 ott 2021

    8 pagineAA

    Cessazione della carica di Anne Marie Brennan come segretario in data 05 ott 2021

    1 pagineTM02

    Nomina di Mrs Michelle Louise Woodall come segretario in data 05 ott 2021

    2 pagineAP03

    Nomina di Edward Hancock come amministratore in data 05 ott 2021

    2 pagineAP01

    Nomina di Robert Anthony Leach come amministratore in data 05 ott 2021

    2 pagineAP01

    Nomina di Mrs Hayleigh Lupino come amministratore in data 05 ott 2021

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Ralph Graham Findlay come amministratore in data 02 ott 2021

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 03 ott 2020

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 apr 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Richard James Westwood come amministratore in data 30 ott 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 apr 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 set 2019

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 apr 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 29 set 2018

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 apr 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2017

    8 pagineAA

    Cessazione della carica di Peter Dalzell come amministratore in data 29 set 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 apr 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 01 ott 2016

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 apr 2016

    Stato del capitale al 07 apr 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Chi sono gli amministratori di THE GRAY OX LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WOODALL, Michelle Louise
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    Segretario
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    288186670001
    ANDREA, Andrew Andonis
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    Amministratore
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    EnglandBritish137383120001
    HANCOCK, Edward John
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    Amministratore
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    United KingdomBritish288133210001
    LEACH, Robert Anthony
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    Amministratore
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    United KingdomBritish194085550001
    LUPINO, Hayleigh
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    Amministratore
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    United KingdomBritish207826950002
    BRENNAN, Anne Marie
    Marston's House
    WV1 4JT Wolverhampton
    West Midlands
    Segretario
    Marston's House
    WV1 4JT Wolverhampton
    West Midlands
    British109935620001
    GRAHAM, Granville
    40 Chadwick Lane
    WF14 8RA Mirfield
    West Yorkshire
    Segretario
    40 Chadwick Lane
    WF14 8RA Mirfield
    West Yorkshire
    British45842190002
    HODGSON, Mark Ian
    Breeze Hill
    Portinscale
    CA12 5RW Keswick
    Cumbria
    Segretario
    Breeze Hill
    Portinscale
    CA12 5RW Keswick
    Cumbria
    British97778860001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ANDREW, Derek
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    Amministratore
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    British39071260003
    DALZELL, Peter
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    Amministratore
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    EnglandBritish163616170001
    DARBY, Alistair William
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    Amministratore
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    British87846880002
    FINDLAY, Ralph Graham
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marstons House
    West Midlands
    Amministratore
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marstons House
    West Midlands
    EnglandBritish129897400001
    GRAHAM, Ann Maria
    40 Chadwick Lane
    WF14 8RA Mirfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    40 Chadwick Lane
    WF14 8RA Mirfield
    West Yorkshire
    British57762320002
    GRAHAM, Granville
    40 Chadwick Lane
    WF14 8RA Mirfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    40 Chadwick Lane
    WF14 8RA Mirfield
    West Yorkshire
    British45842190002
    HOUGHTON, John
    8 Rubbybanks Road
    CA13 9RG Cockermouth
    Cumbria
    Amministratore
    8 Rubbybanks Road
    CA13 9RG Cockermouth
    Cumbria
    British73576380002
    INGLETT, Paul
    Marston's House
    WV1 4JT Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    Marston's House
    WV1 4JT Wolverhampton
    West Midlands
    British81617110002
    OLIVER, Stephen John
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    Amministratore
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    British66123690003
    RYAN, Diane Mary
    47 Headlands Close
    WF15 7QJ Liversedge
    West Yorkshire
    Amministratore
    47 Headlands Close
    WF15 7QJ Liversedge
    West Yorkshire
    British57762330003
    RYAN, Wayne Glen
    47 Headlands Close
    WF15 7QJ Liversedge
    West Yorkshire
    Amministratore
    47 Headlands Close
    WF15 7QJ Liversedge
    West Yorkshire
    British57762340003
    STEVENSON, David Robert
    Rosemount
    Burgh By Sands
    CA5 6AN Carlisle
    Cumbria
    Amministratore
    Rosemount
    Burgh By Sands
    CA5 6AN Carlisle
    Cumbria
    EnglandBritish91952830001
    WESTWOOD, Richard James
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    Amministratore
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    EnglandBritish314691870001

    Chi sono le persone con controllo significativo di THE GRAY OX LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione00024795
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    THE GRAY OX LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 30 giu 1998
    Consegnato il 17 lug 1998
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 30 giu 1998
    Consegnato il 17 lug 1998
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The gray ox,15 hartshead lane,hartshead,near liversedge,west yorkshire WF15 8AL; wyk 520438. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 30 giu 1998
    Consegnato il 17 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The boathouse victoria rd,saltaire,shipley,west yorkshire; wyk 252862;. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0