DGP INTERNATIONAL LTD
Panoramica
| Nome della società | DGP INTERNATIONAL LTD |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03686895 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di DGP INTERNATIONAL LTD?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova DGP INTERNATIONAL LTD?
| Indirizzo della sede legale | 4 Mount Ephraim Road TN1 1EE Tunbridge Wells Kent |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di DGP INTERNATIONAL LTD?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| D.G.P. (CONSULTING ENGINEERS) LIMITED | 09 apr 1999 | 09 apr 1999 |
| MARPLACE (NUMBER 436) LIMITED | 22 dic 1998 | 22 dic 1998 |
Quali sono gli ultimi bilanci di DGP INTERNATIONAL LTD?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 27 set 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per DGP INTERNATIONAL LTD?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 11 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 03 feb 2023 | 12 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 03 feb 2022 | 12 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Morte di un liquidatore | 3 pagine | LIQ09 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Aldgate Tower 2 Leman Street London E1 8FA | 2 pagine | AD02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da , Aldgate Tower 2 Leman Street, London, E1 8FA, United Kingdom a 4 Mount Ephraim Road Tunbridge Wells Kent TN1 1EE in data 20 mar 2021 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 dic 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 27 set 2019 | 22 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 dic 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Bolaji Moruf Taiwo il 14 ago 2019 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Bernice Constance Lilian Philps come amministratore in data 03 lug 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Joanne Lucy Lang come amministratore in data 03 lug 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 28 set 2018 | 20 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Bernice Constance Lilian Philps il 28 mag 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr David John Price il 30 mag 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Urs Corporation Group Limited come persona con controllo significativo il 28 mag 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da , St. George's House 5 st. George's Road, Wimbledon, London, SW19 4DR, England a 4 Mount Ephraim Road Tunbridge Wells Kent TN1 1EE in data 28 mag 2019 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Mr Bolaji Moruf Taiwo come segretario in data 21 dic 2018 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 dic 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 29 set 2017 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di DGP INTERNATIONAL LTD?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWO, Bolaji Moruf | Segretario | Mount Ephraim Road TN1 1EE Tunbridge Wells 4 Kent | 253962090001 | |||||||
| LANG, Joanne Lucy | Amministratore | Mount Ephraim Road TN1 1EE Tunbridge Wells 4 Kent | United Kingdom | British | 255152790001 | |||||
| PRICE, David John | Amministratore | Mount Ephraim Road TN1 1EE Tunbridge Wells 4 Kent | Wales | British | 237792960001 | |||||
| BRANDWOOD, Christopher Mark | Segretario | Brook House 77 Fountain Street M2 2EE Manchester | British | 813160001 | ||||||
| CROOK, Karen Lesley | Segretario | Gristlehurst House Top O Th Wood Bury And Rochdale Old Road OL10 4BQ Heywood Lancashire | British | 64126430003 | ||||||
| PARRY-JONES, Alan | Segretario | Scott House, Alencon Link Basingstoke RG21 7PP Hampshire | 159511410001 | |||||||
| REDWOOD, Geoffrey Michael | Segretario | 17 Folly Lane North Hale GU9 0HU Farnham Surrey | British | 4727540001 | ||||||
| BETTENBUEHL, Volker Helmut | Amministratore | Greencoat Place SW1P 1PL London 6-8 United Kingdom | Germany | German | 161161870001 | |||||
| CROOK, Karen Lesley | Amministratore | Gristlehurst House Top O Th Wood Bury And Rochdale Old Road OL10 4BQ Heywood Lancashire | British | 64126430003 | ||||||
| FITZGERALD, David Sean | Amministratore | Brook House 77 Fountain Street M2 2EE Manchester | British | 61196400003 | ||||||
| GALLAGHER, Joseph Michael | Amministratore | 1 Wadham Way Hale WA15 9LJ Altrincham Cheshire | England | British | 31380810001 | |||||
| HEMSHALL, Rebecca Elizabeth | Amministratore | 5 St. George's Road Wimbledon SW19 4DR London St. George's House England | England | British | 196043500001 | |||||
| JENNISON, Christopher William | Amministratore | Brook House Brookside East Leake LE12 6PB Loughborough Leicestershire | United Kingdom | British | 43585840001 | |||||
| MARRETT, Abraham Varghese | Amministratore | Warrawee Avenue 2074 Warrawee 16 N S W Australia | Australia | Australian | 176139550001 | |||||
| MUNRO-LAFON, Jerome Phillipe | Amministratore | Burtons Gardens Old Basing RG24 7AF Basingstoke 9 Hampshire United Kingdom | England | British | 43584910001 | |||||
| PHILPS, Bernice Constance Lilian | Amministratore | 2 Leman Street E1 8FA London Aldgate Tower United Kingdom | England | British | 237778290001 | |||||
| PLATT, David | Amministratore | Gristlehurst House Top O Th Wood Bury And Rochdale Old Road OL10 4BQ Heywood Lancashire | England | British | 31380820003 |
Chi sono le persone con controllo significativo di DGP INTERNATIONAL LTD?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urs Corporation Group Limited | 06 apr 2016 | 2 Leman Street E1 8FA London Aldgate Tower United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
DGP INTERNATIONAL LTD ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Composite guarantee and debenture | Creato il 07 apr 1999 Consegnato il 15 apr 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company formerly k/a marplace (number 436) limited and D.G.P. limited formerly k/a D.G.P. (consulting engineers) limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 07 apr 1999 Consegnato il 15 apr 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company formerly k/a marplace (number 436) limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignment of life policy | Creato il 07 apr 1999 Consegnato il 15 apr 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company formerly k/a marplace (number 436) limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All money payable under the policy of life assurance number C143258S with swiss life (UK) PLC on the life of joseph michael gallagher. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignment of life policy | Creato il 07 apr 1999 Consegnato il 15 apr 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company formerly k/a marplace (number 436) limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All money payable under the policy of life assurance number C143323S with swiss life (UK) PLC on the life of david platt. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignment of life policy | Creato il 07 apr 1999 Consegnato il 15 apr 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company formerly k/a marplace (number 436) limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All money payable under the policy of life assurance number C143277S with swiss life (UK) PLC on the life of karen lesley crook. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
DGP INTERNATIONAL LTD ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0