DGP INTERNATIONAL LTD

DGP INTERNATIONAL LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDGP INTERNATIONAL LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03686895
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DGP INTERNATIONAL LTD?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova DGP INTERNATIONAL LTD?

    Indirizzo della sede legale
    4 Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    Kent
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DGP INTERNATIONAL LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    D.G.P. (CONSULTING ENGINEERS) LIMITED09 apr 199909 apr 1999
    MARPLACE (NUMBER 436) LIMITED22 dic 199822 dic 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di DGP INTERNATIONAL LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al27 set 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per DGP INTERNATIONAL LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    11 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 03 feb 2023

    12 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 03 feb 2022

    12 pagineLIQ03

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Morte di un liquidatore

    3 pagineLIQ09

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Aldgate Tower 2 Leman Street London E1 8FA

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da , Aldgate Tower 2 Leman Street, London, E1 8FA, United Kingdom a 4 Mount Ephraim Road Tunbridge Wells Kent TN1 1EE in data 20 mar 2021

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 04 feb 2021

    LRESSP

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 dic 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 27 set 2019

    22 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 dic 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Bolaji Moruf Taiwo il 14 ago 2019

    1 pagineCH03

    Cessazione della carica di Bernice Constance Lilian Philps come amministratore in data 03 lug 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Mrs Joanne Lucy Lang come amministratore in data 03 lug 2019

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 28 set 2018

    20 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Bernice Constance Lilian Philps il 28 mag 2019

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David John Price il 30 mag 2019

    2 pagineCH01

    Modifica dei dettagli di Urs Corporation Group Limited come persona con controllo significativo il 28 mag 2019

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da , St. George's House 5 st. George's Road, Wimbledon, London, SW19 4DR, England a 4 Mount Ephraim Road Tunbridge Wells Kent TN1 1EE in data 28 mag 2019

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Bolaji Moruf Taiwo come segretario in data 21 dic 2018

    2 pagineAP03

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 dic 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 29 set 2017

    19 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di DGP INTERNATIONAL LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TAIWO, Bolaji Moruf
    Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    4
    Kent
    Segretario
    Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    4
    Kent
    253962090001
    LANG, Joanne Lucy
    Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    4
    Kent
    Amministratore
    Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    4
    Kent
    United KingdomBritish255152790001
    PRICE, David John
    Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    4
    Kent
    Amministratore
    Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    4
    Kent
    WalesBritish237792960001
    BRANDWOOD, Christopher Mark
    Brook House 77 Fountain Street
    M2 2EE Manchester
    Segretario
    Brook House 77 Fountain Street
    M2 2EE Manchester
    British813160001
    CROOK, Karen Lesley
    Gristlehurst House Top O Th Wood
    Bury And Rochdale Old Road
    OL10 4BQ Heywood
    Lancashire
    Segretario
    Gristlehurst House Top O Th Wood
    Bury And Rochdale Old Road
    OL10 4BQ Heywood
    Lancashire
    British64126430003
    PARRY-JONES, Alan
    Scott House, Alencon Link
    Basingstoke
    RG21 7PP Hampshire
    Segretario
    Scott House, Alencon Link
    Basingstoke
    RG21 7PP Hampshire
    159511410001
    REDWOOD, Geoffrey Michael
    17 Folly Lane North
    Hale
    GU9 0HU Farnham
    Surrey
    Segretario
    17 Folly Lane North
    Hale
    GU9 0HU Farnham
    Surrey
    British4727540001
    BETTENBUEHL, Volker Helmut
    Greencoat Place
    SW1P 1PL London
    6-8
    United Kingdom
    Amministratore
    Greencoat Place
    SW1P 1PL London
    6-8
    United Kingdom
    GermanyGerman161161870001
    CROOK, Karen Lesley
    Gristlehurst House Top O Th Wood
    Bury And Rochdale Old Road
    OL10 4BQ Heywood
    Lancashire
    Amministratore
    Gristlehurst House Top O Th Wood
    Bury And Rochdale Old Road
    OL10 4BQ Heywood
    Lancashire
    British64126430003
    FITZGERALD, David Sean
    Brook House 77 Fountain Street
    M2 2EE Manchester
    Amministratore
    Brook House 77 Fountain Street
    M2 2EE Manchester
    British61196400003
    GALLAGHER, Joseph Michael
    1 Wadham Way
    Hale
    WA15 9LJ Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    1 Wadham Way
    Hale
    WA15 9LJ Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish31380810001
    HEMSHALL, Rebecca Elizabeth
    5 St. George's Road
    Wimbledon
    SW19 4DR London
    St. George's House
    England
    Amministratore
    5 St. George's Road
    Wimbledon
    SW19 4DR London
    St. George's House
    England
    EnglandBritish196043500001
    JENNISON, Christopher William
    Brook House Brookside
    East Leake
    LE12 6PB Loughborough
    Leicestershire
    Amministratore
    Brook House Brookside
    East Leake
    LE12 6PB Loughborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish43585840001
    MARRETT, Abraham Varghese
    Warrawee Avenue
    2074 Warrawee
    16
    N S W
    Australia
    Amministratore
    Warrawee Avenue
    2074 Warrawee
    16
    N S W
    Australia
    AustraliaAustralian176139550001
    MUNRO-LAFON, Jerome Phillipe
    Burtons Gardens
    Old Basing
    RG24 7AF Basingstoke
    9
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Burtons Gardens
    Old Basing
    RG24 7AF Basingstoke
    9
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish43584910001
    PHILPS, Bernice Constance Lilian
    2 Leman Street
    E1 8FA London
    Aldgate Tower
    United Kingdom
    Amministratore
    2 Leman Street
    E1 8FA London
    Aldgate Tower
    United Kingdom
    EnglandBritish237778290001
    PLATT, David
    Gristlehurst House Top O Th Wood
    Bury And Rochdale Old Road
    OL10 4BQ Heywood
    Lancashire
    Amministratore
    Gristlehurst House Top O Th Wood
    Bury And Rochdale Old Road
    OL10 4BQ Heywood
    Lancashire
    EnglandBritish31380820003

    Chi sono le persone con controllo significativo di DGP INTERNATIONAL LTD?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Urs Corporation Group Limited
    2 Leman Street
    E1 8FA London
    Aldgate Tower
    United Kingdom
    06 apr 2016
    2 Leman Street
    E1 8FA London
    Aldgate Tower
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione5639381
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    DGP INTERNATIONAL LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 07 apr 1999
    Consegnato il 15 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly k/a marplace (number 436) limited and D.G.P. limited formerly k/a D.G.P. (consulting engineers) limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Agent for Itself and Close Brothers Protected Vct PLC)
    Transazioni
    • 15 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 apr 1999
    Consegnato il 15 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly k/a marplace (number 436) limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of life policy
    Creato il 07 apr 1999
    Consegnato il 15 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly k/a marplace (number 436) limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All money payable under the policy of life assurance number C143258S with swiss life (UK) PLC on the life of joseph michael gallagher.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of life policy
    Creato il 07 apr 1999
    Consegnato il 15 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly k/a marplace (number 436) limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All money payable under the policy of life assurance number C143323S with swiss life (UK) PLC on the life of david platt.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of life policy
    Creato il 07 apr 1999
    Consegnato il 15 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly k/a marplace (number 436) limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All money payable under the policy of life assurance number C143277S with swiss life (UK) PLC on the life of karen lesley crook.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    DGP INTERNATIONAL LTD ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    04 feb 2021Inizio della liquidazione
    26 set 2023Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark Newman
    4 Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    Kent
    Praticante
    4 Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    Kent
    Vincent John Green
    4 Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    Kent
    Praticante
    4 Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    Kent
    Steven Edwards
    4 Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    Kent
    Praticante
    4 Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    Kent

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0