Christopher Mark BRANDWOOD
Persona fisica
| Titolo | |
|---|---|
| Nome | Christopher |
| Secondo nome | Mark |
| Cognome | BRANDWOOD |
| È un dirigente societario | No |
| Incarichi | |
| Attivo | 0 |
| Inattivo | 1 |
| Dimesso | 16 |
| Totale | 17 |
Incarichi
| Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRABNERS CHAFFE STREET LIMITED | 20 lug 1995 | Sciolta | Segretario | King Street M2 4LQ Manchester 5th Floor 55 | British | |||
| DAVID RUSSELL (KENDAL) LIMITED | 09 dic 2009 | Sciolta | Solicitor | Amministratore | King Street M2 4LQ Manchester Fifth Floor 55 | British | ||
| DAVID RUSSELL (KENDAL) LIMITED | 09 dic 2009 | Sciolta | Segretario | King Street M2 4LQ Manchester Fifth Floor 55 | British | |||
| BEGBIES TRAYNOR GROUP PLC | 24 set 2004 | 17 gen 2008 | Attiva | Segretario | Brook House 77 Fountain Street M2 2EE Manchester | British | ||
| DGP INTERNATIONAL LTD | 22 dic 1998 | 07 apr 1999 | Sciolta | Segretario | Brook House 77 Fountain Street M2 2EE Manchester | British | ||
| SENIOR RESPONSE LIMITED | 22 dic 1998 | 02 feb 1999 | Attiva | Segretario | Brook House 77 Fountain Street M2 2EE Manchester | British | ||
| BAINBRIDGE ENTERPRISES (UK) LIMITED | 22 dic 1998 | 02 feb 1999 | Attiva | Segretario | Brook House 77 Fountain Street M2 2EE Manchester | British | ||
| NICHOLL-SMITH HORTICULTURAL LIMITED | 17 nov 1998 | 24 dic 1998 | Sciolta | Segretario | Brook House 77 Fountain Street M2 2EE Manchester | British | ||
| NIKAL LTD | 16 nov 1998 | 23 dic 1998 | In amministrazione | Segretario | Brook House 77 Fountain Street M2 2EE Manchester | British | ||
| MARPLACE (NUMBER 434) LIMITED | 17 nov 1998 | 16 dic 1998 | Sciolta | Segretario | Brook House 77 Fountain Street M2 2EE Manchester | British | ||
| THARLMAN LIMITED | 20 lug 1995 | 16 mag 1996 | Sciolta | Segretario | Brook House 77 Fountain Street M2 2EE Manchester | British | ||
| GSD (CORPORATE) LIMITED | 20 lug 1995 | 11 mar 1996 | Attiva | Segretario | Brook House 77 Fountain Street M2 2EE Manchester | British | ||
| NCC GROUP ESCROW LIMITED | 20 lug 1995 | 06 mar 1996 | Attiva | Segretario | Brook House 77 Fountain Street M2 2EE Manchester | British | ||
| SGL CARBON FIBERS LIMITED | 06 giu 1989 | 12 apr 1995 | Attiva | Segretario | Brook House 77 Fountain Street M2 2EE Manchester | British | ||
| R.K. TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED | 12 apr 1995 | Sciolta | Segretario | Brook House 77 Fountain Street M2 2EE Manchester | British | |||
| KBC PROCESS TECHNOLOGY (MIDDLE EAST) LIMITED | 20 feb 1993 | Attiva | Segretario | Brook House 77 Fountain Street M2 2EE Manchester | British | |||
| LINNHOFF MARCH INTERNATIONAL | 19 feb 1993 | Sciolta | Segretario | Brook House 77 Fountain Street M2 2EE Manchester | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0