NPS (UK10) LIMITED
Panoramica
Nome della società | NPS (UK10) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03757788 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di NPS (UK10) LIMITED?
- Altre attività di pubblicazione di software (58290) / Informazione e comunicazione
Dove si trova NPS (UK10) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 15 Canada Square E14 5GL London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di NPS (UK10) LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
NORTHGATE WORK MANAGEMENT LIMITED | 09 gen 2009 | 09 gen 2009 |
ANITE WORK MANAGEMENT LIMITED | 26 mar 2001 | 26 mar 2001 |
IMASYS WORK MANAGEMENT LIMITED | 20 ago 1999 | 20 ago 1999 |
BACKCROSS LIMITED | 22 apr 1999 | 22 apr 1999 |
Quali sono gli ultimi bilanci di NPS (UK10) LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 apr 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per NPS (UK10) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 6 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands Avenue Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 4NW a 15 Canada Square London E14 5GL in data 03 mag 2019 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 apr 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 apr 2018 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Esercizio contabile in corso abbreviato dal 30 apr 2019 al 31 mar 2019 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen James Callaghan il 06 ago 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ian Michael Noble come amministratore in data 06 ago 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 apr 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio abbreviato redatto al 30 apr 2017, non revisionato | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 apr 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2016 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Coll come amministratore in data 06 dic 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Ian Michael Noble come amministratore in data 06 dic 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Stephen James Callaghan come amministratore in data 10 ott 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David John Meaden come amministratore in data 10 ott 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 apr 2016 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2015 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed northgate work management LIMITED\certificate issued on 16/06/15 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 apr 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2014 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di David John Meaden come amministratore in data 22 dic 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di NPS (UK10) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Segretario | Park Row LS1 5AB Leeds 1 United Kingdom |
| 76579530001 | ||||||||||
CALLAGHAN, Stephen James | Amministratore | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 201347710052 | ||||||||
COUTTS, Cheryl Jane | Segretario | 6 Esmond Road W4 1JQ Chiswick London | British | 12016130002 | ||||||||||
COX, Melanie Rachel | Segretario | 1 The Green Bisham SL7 1RY Marlow Buckinghamshire | British | 96139050001 | ||||||||||
HEMMING, Vivienne Ruth | Segretario | 25 Saint Johns Road OX10 9AW Wallingford Oxon | British | 41962390006 | ||||||||||
HUMPHREY, Christopher John | Segretario | Well House School Lane, Northend BA1 7EP Bath Somerset | British | 32877720003 | ||||||||||
RICHARDSON, John David | Segretario | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire | British | 128558470001 | ||||||||||
SADLER, John Michael | Segretario | 14 Highlands Close SL9 0DR Chalfont St Peter Buckinghamshire | British | 78431540001 | ||||||||||
SCHENCK, Daniel William | Segretario | Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate Marylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead 3rd Floor Hertfordshire United Kingdom | Usa | 181204960001 | ||||||||||
WENMAN, Nicholas Edward | Segretario | Three Gates 40a Guildown Road GU2 5EY Guildford Surrey | British | Director | 14373460003 | |||||||||
LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Segretario nominato | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001510001 | |||||||||||
AL-SALEH, Adel Bedry | Amministratore | Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate Marylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead 3rd Floor Hertfordshire United Kingdom | United States | American | Director | 165900220001 | ||||||||
BASS, Neil Anthony | Amministratore | 31 Archery Fields RG29 1AE Odiham Hampshire | England | British | Director | 70199330002 | ||||||||
BEATON, Richard L'Estrange | Amministratore | Prestbury Hall The Village SK10 4BN Prestbury Cheshire | England | British | Director | 97291590001 | ||||||||
BODHA, James Sanjay | Amministratore | Rook How 22 Elm Tree Road WA13 0NB Lymm Cheshire | England | British | Director | 93657140001 | ||||||||
COLL, Andrew | Amministratore | Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British | Finance Director | 237260100001 | ||||||||
GIBSON, John Leonard | Amministratore | Ivydene Delly End OX29 9XD Hailey Oxfordshire | British | Director | 104554430001 | |||||||||
HUNT, Simon Anthony | Amministratore | Apt 31 21 Sheldon Square Paddington Central W2 6DS London | British | Chartered Accountant | 118771650001 | |||||||||
MCCANN, James | Amministratore | 32 Carter Close SL4 3QX Windsor Berkshire | British | Chartered Management Accountan | 69923680001 | |||||||||
MEADEN, David John | Amministratore | Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Executive | 193740420001 | ||||||||
NOBLE, Ian Michael | Amministratore | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British | Director | 199843940001 | ||||||||
PHILLIPS, David Alan | Amministratore | 16 Ryhill Way Lower Earley RG6 4AZ Reading Berkshire | British | Accountant | 54616920001 | |||||||||
STIER, John Robert | Amministratore | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 78901530003 | ||||||||
STONE, Christopher Michael Renwick | Amministratore | Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Hertfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 66955690003 | ||||||||
TAIT, Ian | Amministratore | Field House Evesham Road WR10 2QR Fladbury Worcestershire | United Kingdom | British | Director | 76976490001 | ||||||||
TYRRELL, Simon Robert Edgar | Amministratore | Larks 15 Burstead Close KT11 2NL Cobham Surrey | England | British | Company Director | 77284710002 | ||||||||
WENMAN, Nicholas Edward | Amministratore | Three Gates 40a Guildown Road GU2 5EY Guildford Surrey | British | Director | 14373460003 | |||||||||
LONDON LAW SERVICES LIMITED | Amministratore delegato nominato | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001500001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di NPS (UK10) LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nps (Uk5) Limited | 06 apr 2016 | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
NPS (UK10) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28 november 2006 | Creato il 16 feb 2007 Consegnato il 01 mar 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28 november 2006 | Creato il 15 feb 2007 Consegnato il 01 mar 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Omnibus guarantee and set-off agreement | Creato il 28 nov 2006 Consegnato il 30 nov 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 9TH december 2002 | Creato il 28 feb 2006 Consegnato il 02 mar 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
An omnibus letter of set-off | Creato il 09 dic 2002 Consegnato il 13 dic 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Second deed of amendment (supplemental to a guarantee and debenture dated 6 october 1995 as amended and restated by deed of amendment dated 9 april 1999) | Creato il 08 nov 1999 Consegnato il 10 nov 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
NPS (UK10) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0