ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03792893 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 4th Floor 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| A S G MIDLANDS LIMITED | 21 giu 1999 | 21 giu 1999 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 apr 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ2 | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||
Modifica dei dettagli di Castlegate 796 Limited come persona con controllo significativo il 06 gen 2023 | 2 pagine | PSC05 | ||
Modifica dei dettagli di Castlegate 796 Limited come persona con controllo significativo il 06 gen 2023 | 2 pagine | PSC05 | ||
Cessazione della carica di Rjp Secretaries Limited come segretario in data 25 gen 2023 | 1 pagine | TM02 | ||
Nomina di Cossey Cosec Services Limited come segretario in data 25 gen 2023 | 2 pagine | AP04 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da Ground Floor, Egerton House 68 Baker Street Weybridge Surrey KT13 8AL United Kingdom a 4th Floor 24 Old Bond Street Mayfair London W1S 4AW in data 06 gen 2023 | 1 pagine | AD01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 giu 2022 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Modifica dei dettagli di Gold Round Limited come persona con controllo significativo il 25 lug 2022 | 2 pagine | PSC05 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Gold Round Limited il 25 lug 2022 | 1 pagine | CH02 | ||
Modifica dei dettagli di Ansa Utilities Limited come persona con controllo significativo il 09 giu 2022 | 2 pagine | PSC05 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2021 | 7 pagine | AA | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Stuart Pace il 21 lug 2021 | 2 pagine | CH01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 giu 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2020 | 7 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Alan Albert Horton come amministratore in data 30 giu 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Stuart Pace il 29 giu 2020 | 2 pagine | CH01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 giu 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Modifica dei dettagli di Gold Round Limited come persona con controllo significativo il 18 apr 2016 | 2 pagine | PSC05 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2019 | 7 pagine | AA | ||
Modifica dei dettagli di Ansa Utilities Limited come persona con controllo significativo il 09 ago 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da 2 a C Court High Street Thames Ditton Surrey KT7 0SR England a Ground Floor, Egerton House 68 Baker Street Weybridge Surrey KT13 8AL in data 12 ago 2019 | 1 pagine | AD01 | ||
Dettagli del segretario cambiati per Rjp Secretaries Limited il 09 ago 2019 | 1 pagine | CH04 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 giu 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Soddisfazione dell'onere 8 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Chi sono gli amministratori di ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSSEY COSEC SERVICES LIMITED | Segretario | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom |
| 302964180001 | ||||||||||
| PACE, Stuart | Amministratore | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom | England | British | 207506130003 | |||||||||
| GOLD ROUND LIMITED | Amministratore | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom |
| 149588400001 | ||||||||||
| BOYES, Stephen | Segretario | Grassdale Cottage Valley Road, Houghton Bottoms PR5 0SD Preston Lancashire | British | 78387220001 | ||||||||||
| DAVIS, Peter Nicholas | Segretario | 35 Chatsworth Road Eccles M30 9DZ Manchester Lancashire | British | 29902470001 | ||||||||||
| DICKINSON, Louise | Segretario | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | British | 139480580001 | ||||||||||
| GRAEME, Dorothy May | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | 900001330001 | ||||||||||
| MCINNES, Timothy Ian | Segretario | 34 Cumberland Drive Bowdon WA14 3QP Altrincham Cheshire | British | 108973030002 | ||||||||||
| PRILL, Robert David | Segretario | Moorfield, Roe Green Worsley M28 2FL Manchester 8 United Kingdom | British | 131613520001 | ||||||||||
| WATKINS, Steven James | Segretario | Roscownans Old Kea TR3 6AX Truro Cornwall | British | 127928260001 | ||||||||||
| RJP SECRETARIES LIMITED | Segretario | 68 Baker Street KT13 8AL Weybridge Ground Floor, Egerton House Surrey United Kingdom |
| 61999120002 | ||||||||||
| BARRETT, John | Amministratore | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | United Kingdom | British | 118475070001 | |||||||||
| BROOK, Philip John | Amministratore | 8 Hillside Drive BH23 2RU Christchurch Dorset | British | 64789650001 | ||||||||||
| DAVIS, Peter Nicholas | Amministratore | 35 Chatsworth Road Eccles M30 9DZ Manchester Lancashire | England | British | 29902470001 | |||||||||
| DICKINSON, Louise | Amministratore | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | England | British | 139480580001 | |||||||||
| GRAEME, Lesley Joyce | Amministratore delegato nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | 900001320001 | ||||||||||
| HORTON, Alan Albert | Amministratore | 68 Baker Street KT13 8AL Weybridge Ground Floor, Egerton House Surrey United Kingdom | England | British | 182208240001 | |||||||||
| LEE, Peter Francis | Amministratore | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | England | British | 207608120001 | |||||||||
| LEES, Stuart | Amministratore | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | England | British | 70032700001 | |||||||||
| LLOYD JONES, Andrew Mark | Amministratore | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | England | British | 180809810001 | |||||||||
| MAHONEY, Kevin David | Amministratore | 6 Ferrymans Quay William Morris Way SW6 2UT London | United Kingdom | British | 63238350002 | |||||||||
| MAUDE, Simon David | Amministratore | The Main Hall Rufford Park Lane Rufford L40 1XE Ormskirk 1 Lancashire | United Kingdom | British | 89719660003 | |||||||||
| MCINNES, Timothy Ian | Amministratore | 34 Cumberland Drive Bowdon WA14 3QP Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | 108973030002 | |||||||||
| POLLARD, Niall Mackinlay | Amministratore | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | England | British | 176786520001 | |||||||||
| SMITH, Andrew John | Amministratore | High Street KT7 0SR Thames Ditton 2 A C Court Surrey England | United Kingdom | British | 207506140001 | |||||||||
| TURNER, Paul Leslie | Amministratore | Netherlaw Greendale Lane SK10 4AY Mottram St Andrew Cheshire | British | 72964390004 | ||||||||||
| VINCENT, Michael | Amministratore | 23 Saint Aubyns's Avenue SW19 7BL London | England | British | 99258270001 | |||||||||
| WATKINS, Steven James | Amministratore | Park Crescent TR11 2DL Falmouth 1 Cornwall United Kingdom | United Kingdom | British | 127928260002 | |||||||||
| WATKINS, Steven James | Amministratore | Roscownans Old Kea TR3 6AX Truro Cornwall | British | 127928260001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Round Limited | 18 apr 2016 | 24 Old Bond Street W1S 4AW Mayfair 4th Floor London United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Gold Round Limited | 06 apr 2016 | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 5th Floor United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Castlegate 796 Limited | 06 apr 2016 | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 01 set 2016 Consegnato il 13 set 2016 | In corso | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 03 giu 2016 Consegnato il 16 giu 2016 | In corso | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A composite guarantee and debenture | Creato il 31 gen 2011 Consegnato il 08 feb 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creato il 26 giu 2009 Consegnato il 02 lug 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 26 giu 2009 Consegnato il 30 giu 2009 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Accession deed | Creato il 30 giu 2005 Consegnato il 06 lug 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due of any chargor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The payment of the secured liabilities,any f/h or l/h property,its interest in present and future licences,fixed charge all othe present and future fittings,plant,equipment,machinery,tools,vehicles,furniture and other tangible movable property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 29 giu 2004 Consegnato il 02 lug 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 12 set 2002 Consegnato il 21 set 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 21 set 2001 Consegnato il 27 set 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0