CHESHIRE CAVITY STORAGE GROUP LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CHESHIRE CAVITY STORAGE GROUP LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03875121 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CHESHIRE CAVITY STORAGE GROUP LIMITED?
- Trasporto via condotte (49500) / Trasporto e stoccaggio
Dove si trova CHESHIRE CAVITY STORAGE GROUP LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 90 Whitfield Street W1T 4EZ London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CHESHIRE CAVITY STORAGE GROUP LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| BRITISH SALT LIMITED | 07 apr 2000 | 07 apr 2000 |
| UK SALT HOLDINGS LIMITED | 10 mar 2000 | 10 mar 2000 |
| UK SALT LIMITED | 09 dic 1999 | 09 dic 1999 |
| INTERCEDE 1505 LIMITED | 11 nov 1999 | 11 nov 1999 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CHESHIRE CAVITY STORAGE GROUP LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per CHESHIRE CAVITY STORAGE GROUP LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Cessazione della carica di Anthony Paul Winkle come amministratore in data 01 gen 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 2 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Matilda Jane Spencer come amministratore in data 01 nov 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2018 | 21 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 3 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 18 set 2019
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Modifica dei dettagli di Edf Energy Plc come persona con controllo significativo il 03 ott 2018 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 mag 2019 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Anthony Winkle il 30 apr 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Matthew Sykes il 09 gen 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael James Harrison come amministratore in data 06 giu 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Paul Anthony Winkle come amministratore in data 06 giu 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Miss Matilda Jane Spencer come amministratore in data 06 giu 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 mag 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di David Tomblin come amministratore in data 05 feb 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Fraser Mitchell come amministratore in data 05 feb 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Edf Energy Plc come persona con controllo significativo il 09 gen 2018 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Cessazione della carica di Gwen Susan Parry-Jones come amministratore in data 22 dic 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 40 Grosvenor Place Victoria London SW1X 7EN a 90 Whitfield Street London W1T 4EZ in data 09 gen 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 15 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CHESHIRE CAVITY STORAGE GROUP LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEBBINGTON, Christopher Andrew | Amministratore | Whitfield Street W1T 4EZ London 90 England | United Kingdom | British | 197462460001 | |||||
| SYKES, Matthew | Amministratore | Whitfield Street W1T 4EZ London 90 England | England | British | 119933330036 | |||||
| TOMBLIN, David | Amministratore | Whitfield Street W1T 4EZ London 90 England | England | British | 244241550001 | |||||
| CRAIG, Miranda Cathryn | Segretario | Grosvenor Place Victoria SW1X 7EN London 40 | British | 139819800001 | ||||||
| DOLAN, Timothy Patrick | Segretario | 10955 Lowell Avenue Suite 600 Overland Park Ks 66210 Usa | American | 69249930002 | ||||||
| MURPHY, Gerald Michael, Vice President | Segretario | 14175 143rd St West Olathe Kansas 66062 Usa | Canadian | 99163520001 | ||||||
| THOMPSON, Christopher William | Segretario | Halfpenny Barn Cranes Lane, Lathom L40 5UJ Ormskirk Lancashire | British | 114283730001 | ||||||
| MITRE SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London | 900004680001 | |||||||
| CHALLINOR, David | Amministratore | Rosebank Marbury Road, Comberbach CW9 6AU Northwich Cheshire | United Kingdom | British | 111045130001 | |||||
| DEMETREE, Mark Charles | Amministratore | 10955 Lowell Avenue Suite 600 Overland Park Ks 66210 Usa | American | 69249840002 | ||||||
| DOLAN, Timothy Patrick | Amministratore | 10955 Lowell Avenue Suite 600 Overland Park Ks 66210 Usa | American | 69249930002 | ||||||
| GALLAND, Jean Baptiste | Amministratore | 44 Victoria Road W8 5RQ London | England | French | 110098880001 | |||||
| GUYLER, Robert | Amministratore | Grosvenor Place Victoria SW1X 7EN London 40 | Scotland | British | 183996210001 | |||||
| HARRISON, Michael James | Amministratore | Whitfield Street W1T 4EZ London 90 England | United Kingdom | British | 202276140001 | |||||
| JONES, Robert Owen | Amministratore | 7 Somerford Close CW11 1YL Sandbach Cheshire | United Kingdom | British | 103532410001 | |||||
| KUSTERER, Thomas Andreas | Amministratore | Grosvenor Place Victoria SW1X 7EN London 40 United Kingdom | United Kingdom | German | 137548090001 | |||||
| LORY, Ronan Emmanuel | Amministratore | Grosvenor Place Victoria SW1X 7EN London 40 | United Kingdom | French | 163104520001 | |||||
| MCDERMOTT, Neil | Amministratore | Grosvenor Place Victoria SW1X 7EN London 40 United Kingdom | United Kingdom | British | 149077600001 | |||||
| MITCHELL, David Fraser | Amministratore | Whitfield Street W1T 4EZ London 90 England | England | British | 197462520001 | |||||
| MURPHY, Gerald | Amministratore | 10955 Lowell Avenue Suite 600 Overland Park Kansas 66210 Usa | American | 69429470003 | ||||||
| PARRY-JONES, Gwen Susan | Amministratore | Whitfield Street W1T 4EZ London 90 England | United Kingdom | British | 187892980001 | |||||
| RICH, Michael William | Amministratore delegato nominato | Hillfield Gorse Hill DA4 0JU Farningham Kent | British | 900015380001 | ||||||
| ROSSI, Simone | Amministratore | Grosvenor Place Victoria SW1X 7EN London 40 United Kingdom | Uk | Italian | 159333940001 | |||||
| SHIH, Henry C Y | Amministratore | 10955 Lowell Avenue Suite 600 Overland Park Kansas 66210 Usa | American | 69429520002 | ||||||
| SPENCER, Matilda Jane | Amministratore | Whitfield Street W1T 4EZ London 90 England | England | British | 244227590001 | |||||
| STEVEN, David Andrew, Dr | Amministratore | Willow Bank Butchers Lane Aughton L39 6SY Ormskirk Lancashire | United Kingdom | British | 37384700001 | |||||
| THOMPSON, Christopher William | Amministratore | Halfpenny Barn Cranes Lane, Lathom L40 5UJ Ormskirk Lancashire | England | British | 114283730001 | |||||
| WARNER, William | Amministratore | 2 Honeysuckle Gardens CR0 8XU Croydon | British | 62351120001 | ||||||
| WINKLE, Anthony Paul | Amministratore | Whitfield Street W1T 4EZ London 90 England | Scotland | British | 270324580001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CHESHIRE CAVITY STORAGE GROUP LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edf Energy Limited | 06 apr 2016 | Whitfield Street W1T 4EZ London 90 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
CHESHIRE CAVITY STORAGE GROUP LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Senior security deed of accession | Creato il 01 gen 2008 Acquisito il 19 giu 2009 Consegnato il 01 lug 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari F/H land at hilltop farm school lane warmingham sandbach cheshire t/no CH428473. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mezzanine security deed of accession | Creato il 01 gen 2008 Acquisito il 19 giu 2009 Consegnato il 01 lug 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari F/H land at hilltop farm school lane warmingham sandbach cheshire t/no CH428473. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and debentures | Creato il 01 gen 2008 Acquisito il 19 giu 2009 Consegnato il 30 giu 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The f/h land at hilltop farm school lane warmingham sandbach cheshire t/n CH428473. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A deed of admission supplemental to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 29/06/2007 and | Creato il 01 gen 2008 Consegnato il 09 gen 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company formerly known as british salt limited and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 29 giu 2007 Acquisito il 19 giu 2009 Consegnato il 01 lug 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari F/H land at hilltop farm school lane warmingham sandbach cheshire t/no CH428473. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mezzanine debenture | Creato il 29 giu 2007 Acquisito il 19 giu 2009 Consegnato il 01 lug 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari F/H land at hilltop farm school lane warmingham sandbach cheshire t/no CH428473. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Share charge | Creato il 29 giu 2007 Consegnato il 10 lug 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All of the companys interest in the shares and the related rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Share charge | Creato il 29 giu 2007 Consegnato il 10 lug 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All the companys interest in the shares and the related rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 29 giu 2007 Consegnato il 07 lug 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari For details of property charged please R. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 29 giu 2007 Consegnato il 07 lug 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari For details of property charged please R. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Creato il 29 giu 2007 Consegnato il 07 lug 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creato il 29 giu 2007 Consegnato il 05 lug 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any group company to the security trustee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 23 ago 2004 Consegnato il 03 set 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any obligor to any security beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari F/H land k/a hole house farm minshull vernon t/no CH441867, f/h land on the north side of cledford lane and land at faulkner drive middlewich t/no CH292747, f/h mines, minerals, salt, salt rock and brine under the land at parkfields farm minshull vernon middlewich t/no CH455194 (for further details of properties charge. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge of deposit | Creato il 26 set 2002 Consegnato il 30 set 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All deposits now and in the future credited to account designation 10100051 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 07 apr 2000 Consegnato il 26 apr 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The prompt performance and observance by the company formerly known as UK salt holdings limited of all the UK obligations (as defined) together with all costs,charges and expenses incurred by the bank of america international limited acting in its capacity as agent and trustee for and on behalf of the agents and the lenders in the protection,preservation and enforcement of their respective rights in relation thereto | |
Brevi particolari First legal mortgage over land on the north side of cledford land and land at faulkner drive, middlewich t/no.CH292747; hilltop farm, warmingham road, warmingham t/no.CH428473; hole house farm, minshull vernon t/no.CH441867.please refer to form 395 for full property details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0