CHESHIRE CAVITY STORAGE GROUP LIMITED

CHESHIRE CAVITY STORAGE GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCHESHIRE CAVITY STORAGE GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03875121
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CHESHIRE CAVITY STORAGE GROUP LIMITED?

    • Trasporto via condotte (49500) / Trasporto e stoccaggio

    Dove si trova CHESHIRE CAVITY STORAGE GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    90 Whitfield Street
    W1T 4EZ London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CHESHIRE CAVITY STORAGE GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BRITISH SALT LIMITED07 apr 200007 apr 2000
    UK SALT HOLDINGS LIMITED10 mar 200010 mar 2000
    UK SALT LIMITED09 dic 199909 dic 1999
    INTERCEDE 1505 LIMITED11 nov 199911 nov 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di CHESHIRE CAVITY STORAGE GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per CHESHIRE CAVITY STORAGE GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Cessazione della carica di Anthony Paul Winkle come amministratore in data 01 gen 2020

    1 pagineTM01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Cessazione della carica di Matilda Jane Spencer come amministratore in data 01 nov 2019

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    21 pagineAA

    legacy

    3 pagineSH20

    Stato del capitale al 18 set 2019

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    3 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Modifica dei dettagli di Edf Energy Plc come persona con controllo significativo il 03 ott 2018

    2 paginePSC05

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 mag 2019 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Anthony Winkle il 30 apr 2019

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Matthew Sykes il 09 gen 2018

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    18 pagineAA

    Cessazione della carica di Michael James Harrison come amministratore in data 06 giu 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Paul Anthony Winkle come amministratore in data 06 giu 2018

    2 pagineAP01

    Nomina di Miss Matilda Jane Spencer come amministratore in data 06 giu 2018

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 mag 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Nomina di David Tomblin come amministratore in data 05 feb 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Fraser Mitchell come amministratore in data 05 feb 2018

    1 pagineTM01

    Modifica dei dettagli di Edf Energy Plc come persona con controllo significativo il 09 gen 2018

    2 paginePSC05

    Cessazione della carica di Gwen Susan Parry-Jones come amministratore in data 22 dic 2017

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da 40 Grosvenor Place Victoria London SW1X 7EN a 90 Whitfield Street London W1T 4EZ in data 09 gen 2018

    1 pagineAD01

    Soddisfazione dell'onere 15 in pieno

    1 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di CHESHIRE CAVITY STORAGE GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BEBBINGTON, Christopher Andrew
    Whitfield Street
    W1T 4EZ London
    90
    England
    Amministratore
    Whitfield Street
    W1T 4EZ London
    90
    England
    United KingdomBritish197462460001
    SYKES, Matthew
    Whitfield Street
    W1T 4EZ London
    90
    England
    Amministratore
    Whitfield Street
    W1T 4EZ London
    90
    England
    EnglandBritish119933330036
    TOMBLIN, David
    Whitfield Street
    W1T 4EZ London
    90
    England
    Amministratore
    Whitfield Street
    W1T 4EZ London
    90
    England
    EnglandBritish244241550001
    CRAIG, Miranda Cathryn
    Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    40
    Segretario
    Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    40
    British139819800001
    DOLAN, Timothy Patrick
    10955 Lowell Avenue
    Suite 600
    Overland Park
    Ks 66210
    Usa
    Segretario
    10955 Lowell Avenue
    Suite 600
    Overland Park
    Ks 66210
    Usa
    American69249930002
    MURPHY, Gerald Michael, Vice President
    14175 143rd St West
    Olathe
    Kansas 66062
    Usa
    Segretario
    14175 143rd St West
    Olathe
    Kansas 66062
    Usa
    Canadian99163520001
    THOMPSON, Christopher William
    Halfpenny Barn
    Cranes Lane, Lathom
    L40 5UJ Ormskirk
    Lancashire
    Segretario
    Halfpenny Barn
    Cranes Lane, Lathom
    L40 5UJ Ormskirk
    Lancashire
    British114283730001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Segretario nominato
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900004680001
    CHALLINOR, David
    Rosebank
    Marbury Road, Comberbach
    CW9 6AU Northwich
    Cheshire
    Amministratore
    Rosebank
    Marbury Road, Comberbach
    CW9 6AU Northwich
    Cheshire
    United KingdomBritish111045130001
    DEMETREE, Mark Charles
    10955 Lowell Avenue
    Suite 600
    Overland Park
    Ks 66210
    Usa
    Amministratore
    10955 Lowell Avenue
    Suite 600
    Overland Park
    Ks 66210
    Usa
    American69249840002
    DOLAN, Timothy Patrick
    10955 Lowell Avenue
    Suite 600
    Overland Park
    Ks 66210
    Usa
    Amministratore
    10955 Lowell Avenue
    Suite 600
    Overland Park
    Ks 66210
    Usa
    American69249930002
    GALLAND, Jean Baptiste
    44 Victoria Road
    W8 5RQ London
    Amministratore
    44 Victoria Road
    W8 5RQ London
    EnglandFrench110098880001
    GUYLER, Robert
    Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    40
    Amministratore
    Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    40
    ScotlandBritish183996210001
    HARRISON, Michael James
    Whitfield Street
    W1T 4EZ London
    90
    England
    Amministratore
    Whitfield Street
    W1T 4EZ London
    90
    England
    United KingdomBritish202276140001
    JONES, Robert Owen
    7 Somerford Close
    CW11 1YL Sandbach
    Cheshire
    Amministratore
    7 Somerford Close
    CW11 1YL Sandbach
    Cheshire
    United KingdomBritish103532410001
    KUSTERER, Thomas Andreas
    Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    Amministratore
    Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    United KingdomGerman137548090001
    LORY, Ronan Emmanuel
    Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    40
    Amministratore
    Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    40
    United KingdomFrench163104520001
    MCDERMOTT, Neil
    Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    Amministratore
    Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    United KingdomBritish149077600001
    MITCHELL, David Fraser
    Whitfield Street
    W1T 4EZ London
    90
    England
    Amministratore
    Whitfield Street
    W1T 4EZ London
    90
    England
    EnglandBritish197462520001
    MURPHY, Gerald
    10955 Lowell Avenue
    Suite 600
    Overland Park
    Kansas 66210
    Usa
    Amministratore
    10955 Lowell Avenue
    Suite 600
    Overland Park
    Kansas 66210
    Usa
    American69429470003
    PARRY-JONES, Gwen Susan
    Whitfield Street
    W1T 4EZ London
    90
    England
    Amministratore
    Whitfield Street
    W1T 4EZ London
    90
    England
    United KingdomBritish187892980001
    RICH, Michael William
    Hillfield
    Gorse Hill
    DA4 0JU Farningham
    Kent
    Amministratore delegato nominato
    Hillfield
    Gorse Hill
    DA4 0JU Farningham
    Kent
    British900015380001
    ROSSI, Simone
    Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    Amministratore
    Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    UkItalian159333940001
    SHIH, Henry C Y
    10955 Lowell Avenue
    Suite 600
    Overland Park
    Kansas 66210
    Usa
    Amministratore
    10955 Lowell Avenue
    Suite 600
    Overland Park
    Kansas 66210
    Usa
    American69429520002
    SPENCER, Matilda Jane
    Whitfield Street
    W1T 4EZ London
    90
    England
    Amministratore
    Whitfield Street
    W1T 4EZ London
    90
    England
    EnglandBritish244227590001
    STEVEN, David Andrew, Dr
    Willow Bank Butchers Lane
    Aughton
    L39 6SY Ormskirk
    Lancashire
    Amministratore
    Willow Bank Butchers Lane
    Aughton
    L39 6SY Ormskirk
    Lancashire
    United KingdomBritish37384700001
    THOMPSON, Christopher William
    Halfpenny Barn
    Cranes Lane, Lathom
    L40 5UJ Ormskirk
    Lancashire
    Amministratore
    Halfpenny Barn
    Cranes Lane, Lathom
    L40 5UJ Ormskirk
    Lancashire
    EnglandBritish114283730001
    WARNER, William
    2 Honeysuckle Gardens
    CR0 8XU Croydon
    Amministratore
    2 Honeysuckle Gardens
    CR0 8XU Croydon
    British62351120001
    WINKLE, Anthony Paul
    Whitfield Street
    W1T 4EZ London
    90
    England
    Amministratore
    Whitfield Street
    W1T 4EZ London
    90
    England
    ScotlandBritish270324580001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CHESHIRE CAVITY STORAGE GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Whitfield Street
    W1T 4EZ London
    90
    England
    06 apr 2016
    Whitfield Street
    W1T 4EZ London
    90
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione2366852
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    CHESHIRE CAVITY STORAGE GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Senior security deed of accession
    Creato il 01 gen 2008
    Acquisito il 19 giu 2009
    Consegnato il 01 lug 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land at hilltop farm school lane warmingham sandbach cheshire t/no CH428473.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 01 lug 2009Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 30 lug 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 08 gen 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mezzanine security deed of accession
    Creato il 01 gen 2008
    Acquisito il 19 giu 2009
    Consegnato il 01 lug 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land at hilltop farm school lane warmingham sandbach cheshire t/no CH428473.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 01 lug 2009Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 30 lug 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 08 gen 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debentures
    Creato il 01 gen 2008
    Acquisito il 19 giu 2009
    Consegnato il 30 giu 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The f/h land at hilltop farm school lane warmingham sandbach cheshire t/n CH428473.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transazioni
    • 30 giu 2009Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 30 lug 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 22 nov 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A deed of admission supplemental to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 29/06/2007 and
    Creato il 01 gen 2008
    Consegnato il 09 gen 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as british salt limited and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 09 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 giu 2007
    Acquisito il 19 giu 2009
    Consegnato il 01 lug 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land at hilltop farm school lane warmingham sandbach cheshire t/no CH428473.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 01 lug 2009Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 30 lug 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 08 gen 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mezzanine debenture
    Creato il 29 giu 2007
    Acquisito il 19 giu 2009
    Consegnato il 01 lug 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land at hilltop farm school lane warmingham sandbach cheshire t/no CH428473.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 01 lug 2009Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 30 lug 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 08 gen 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Share charge
    Creato il 29 giu 2007
    Consegnato il 10 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of the companys interest in the shares and the related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 10 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Share charge
    Creato il 29 giu 2007
    Consegnato il 10 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the companys interest in the shares and the related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 10 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 giu 2007
    Consegnato il 07 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    For details of property charged please R. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 07 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 giu 2007
    Consegnato il 07 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    For details of property charged please R. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 07 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 29 giu 2007
    Consegnato il 07 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 07 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 29 giu 2007
    Consegnato il 05 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company to the security trustee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 05 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 ago 2004
    Consegnato il 03 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any security beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land k/a hole house farm minshull vernon t/no CH441867, f/h land on the north side of cledford lane and land at faulkner drive middlewich t/no CH292747, f/h mines, minerals, salt, salt rock and brine under the land at parkfields farm minshull vernon middlewich t/no CH455194 (for further details of properties charge. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 03 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge of deposit
    Creato il 26 set 2002
    Consegnato il 30 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All deposits now and in the future credited to account designation 10100051 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 apr 2000
    Consegnato il 26 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The prompt performance and observance by the company formerly known as UK salt holdings limited of all the UK obligations (as defined) together with all costs,charges and expenses incurred by the bank of america international limited acting in its capacity as agent and trustee for and on behalf of the agents and the lenders in the protection,preservation and enforcement of their respective rights in relation thereto
    Brevi particolari
    First legal mortgage over land on the north side of cledford land and land at faulkner drive, middlewich t/no.CH292747; hilltop farm, warmingham road, warmingham t/no.CH428473; hole house farm, minshull vernon t/no.CH441867.please refer to form 395 for full property details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of America International Limited
    Transazioni
    • 26 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0