ABSOLUTE FORBURY LIMITED

ABSOLUTE FORBURY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàABSOLUTE FORBURY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04012450
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ABSOLUTE FORBURY LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova ABSOLUTE FORBURY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Tempsford Hall, .
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ABSOLUTE FORBURY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    JLPBS FORBURY LIMITED21 giu 200021 giu 2000
    INTERCEDE 1580 LIMITED12 giu 200012 giu 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di ABSOLUTE FORBURY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per ABSOLUTE FORBURY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Kevin Dixon come amministratore in data 29 dic 2017

    1 pagineTM01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 21 nov 2017

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 mag 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2016

    6 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Mrs Bethan Melges il 16 lug 2016

    1 pagineCH03

    Dettagli del segretario cambiati per Mrs Bethan Melges il 16 lug 2016

    1 pagineCH03

    Bilancio annuale redatto al 22 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 giu 2016

    Stato del capitale al 22 giu 2016

    • Capitale: GBP 100,001
    SH01

    Nomina di Mr Lee Howard come amministratore in data 01 giu 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Alastair James Gordon-Stewart come amministratore in data 01 giu 2016

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2015

    2 pagineAA

    Cessazione della carica di Nigel Alan Turner come amministratore in data 19 gen 2016

    1 pagineTM01

    Varie

    Section 519
    1 pagineMISC

    Nomina di Mrs Bethan Melges come segretario in data 16 lug 2015

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Matthew Armitage come segretario in data 16 lug 2015

    1 pagineTM02

    Dimissioni del revisore

    4 pagineAUD

    Varie

    Section 519
    1 pagineMISC

    Bilancio annuale redatto al 22 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 giu 2015

    Stato del capitale al 12 giu 2015

    • Capitale: GBP 100,001
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2014

    2 pagineAA

    Nomina di Mr Matthew Armitage come segretario in data 22 dic 2014

    2 pagineAP03

    Chi sono gli amministratori di ABSOLUTE FORBURY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MELGES, Bethan
    Tempsford Hall, .
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    Segretario
    Tempsford Hall, .
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    199664230001
    HOWARD, Lee
    Tempsford Hall, .
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    Amministratore
    Tempsford Hall, .
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    EnglandBritish208700940001
    THOMAS, Leigh Parry
    Tempsford Hall, .
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    Amministratore
    Tempsford Hall, .
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    EnglandBritish159413310001
    ARMITAGE, Matthew
    Tempsford Hall, .
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    Segretario
    Tempsford Hall, .
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    193688980001
    BOND, Christopher Joseph
    22 George Street
    MK17 9PY Woburn
    Bedfordshire
    Segretario
    22 George Street
    MK17 9PY Woburn
    Bedfordshire
    British169680930001
    HAMILTON, Deborah Pamela
    Tempsford Hall, .
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    Segretario
    Tempsford Hall, .
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    161846090001
    SMITH, David Ian
    35 Wimbolt Street
    E2 7BX London
    Segretario
    35 Wimbolt Street
    E2 7BX London
    British5186170001
    WOODS, Ian Paul
    Tempsford Hall, .
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    Segretario
    Tempsford Hall, .
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    British3535740003
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Segretario nominato
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900004680001
    ARDERN, Derrick
    Twyvidales
    85 Eythrope Road
    HP17 8PH Stone Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Twyvidales
    85 Eythrope Road
    HP17 8PH Stone Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish44478670001
    BAIN, Colin Ronald
    Orion Villa
    63 Church Road
    DA7 4DL Bexleyheath
    Kent
    Amministratore
    Orion Villa
    63 Church Road
    DA7 4DL Bexleyheath
    Kent
    United KingdomBritish89021130003
    BOND, Christopher Joseph
    22 George Street
    MK17 9PY Woburn
    Bedfordshire
    Amministratore
    22 George Street
    MK17 9PY Woburn
    Bedfordshire
    EnglandBritish169680930001
    BRADLEY, Pauline Anne
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    Amministratore
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    British122926460001
    BYRNE, James Anthony John
    4 Blythe Way
    B91 3EY Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    4 Blythe Way
    B91 3EY Solihull
    West Midlands
    British83499160001
    CUMMINGS, Peter Joseph
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    Amministratore
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    ScotlandBritish68241910003
    DIXON, Kevin
    Cavendish Place
    W1G 9NB London
    6
    England
    Amministratore
    Cavendish Place
    W1G 9NB London
    6
    England
    EnglandBritish41560840002
    DUNCOMBE, Roger John
    Croft House
    16 Faircross Way
    AL1 4SD St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    Croft House
    16 Faircross Way
    AL1 4SD St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish20158760001
    GILMAN, Thomas George
    4 Court Barton Lane
    Clifford
    LS23 6SN Wetherby
    The Maples
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    4 Court Barton Lane
    Clifford
    LS23 6SN Wetherby
    The Maples
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish159657830001
    GILMAN, Thomas George
    70 High Street
    Clifford
    LS23 6HJ Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    70 High Street
    Clifford
    LS23 6HJ Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish103084110001
    GORDON-STEWART, Alastair James
    Tempsford Hall, .
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    Amministratore
    Tempsford Hall, .
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    EnglandBritish124512200002
    LAMBERT, James Paul
    2 Portman Avenue
    East Sheen
    SW14 8NX London
    Amministratore
    2 Portman Avenue
    East Sheen
    SW14 8NX London
    United KingdomBritish103062380001
    RICH, Michael William
    Hillfield
    Gorse Hill, Farningham
    DA4 0JU Dartford
    Kent
    Amministratore
    Hillfield
    Gorse Hill, Farningham
    DA4 0JU Dartford
    Kent
    British70341190001
    ROBB, Gordon William
    7 High Buckstone
    Fairmilehead
    EH10 6XS Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    7 High Buckstone
    Fairmilehead
    EH10 6XS Edinburgh
    Midlothian
    British11456230001
    SIMKIN, Richard William
    14 Little Plucketts Way
    IG9 5QU Buckhurst Hill
    Essex
    Amministratore
    14 Little Plucketts Way
    IG9 5QU Buckhurst Hill
    Essex
    EnglandBritish13432460001
    TURNER, Nigel Alan, Mr.
    Tempsford Hall, .
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    Amministratore
    Tempsford Hall, .
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    EnglandBritish71592210007
    WARNER, William
    2 Honeysuckle Gardens
    CR0 8XU Croydon
    Amministratore
    2 Honeysuckle Gardens
    CR0 8XU Croydon
    British62351120001
    WHITE, Andrew Nicholas Howard
    Tempsford Hall, .
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    Amministratore
    Tempsford Hall, .
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    United KingdomBritish99292200003
    WOODS, Ian Paul
    Tempsford Hall, .
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    Amministratore
    Tempsford Hall, .
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    EnglandBritish3535740003

    Chi sono le persone con controllo significativo di ABSOLUTE FORBURY LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    Tempsford Hall
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    Tempsford Hall
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneUnited Kingdom
    Numero di registrazione3810395
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    ABSOLUTE FORBURY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental debenture
    Creato il 29 lug 2004
    Consegnato il 12 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H property 4 and 6 cavendish place london t/n NGL734622 by way of fixed charge all interests in the new property or the proceeds of sale, the benefit of all options easements agreements for lease and other agreements, all plant and machinery and all rights and interests of the company under all agreements for purchase maintenance or use of plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Agent and Trustee for Thebeneficiaries
    Transazioni
    • 12 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 12 apr 2002
    Consegnato il 22 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security agent or to each other beneficiary (as defined) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 30 apr 2001
    Consegnato il 17 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the terms of any of the finance documents
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland(In Its Capacity as Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 17 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Senior supplemental legal mortgage
    Creato il 21 lug 2000
    Consegnato il 08 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursant to the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    F/H property k/a land at the junction of vastern road and forbury road reading - BK338798 with full title guarantee together with all present and future buildings fixtures plant and machinery and all the provisions of the debenture shall apply to the supplemental legal mortgage. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Second senior supplemental legal mortgage
    Creato il 21 lug 2000
    Consegnato il 08 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursant to the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    F/H property k/a land at the junction of vastern road and forbury road reading - BK338798 with full title guarantee together with all present and future buildings fixtures plant and machinery and all the provisions of the debenture shall apply to the supplemental legal mortgage. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 05 lug 2000
    Consegnato il 25 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Lender Under the Loan Agreement,as Defined
    Transazioni
    • 25 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 05 lug 2000
    Consegnato il 25 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the bos senior documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Lender Under the Senior Facility Letter(As Defined)
    Transazioni
    • 25 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0