B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED

B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàB MIDGLEY SEAFOODS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04036033
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED?

    • Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi (10200) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 St. Peters Square
    M2 3AE Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 09 lug 2021

    6 pagineLIQ03

    Dimissioni di un liquidatore

    3 pagineLIQ06

    Nomina di un liquidatore volontario

    42 pagine600

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Kpmg Llp 8 Princes Parade Liverpool L3 1QH a 1 st. Peters Square Manchester M2 3AE in data 07 mag 2021

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Ross House Wickham Road Grimsby North East Lincolnshire DN31 3SW a 8 Princes Parade Liverpool L3 1QH in data 05 ago 2020

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 10 lug 2020

    LRESSP

    Cessazione di English Seafoods Limited come persona con controllo significativo il 29 mar 2020

    1 paginePSC07

    Notifica di Youngs Seafood Ltd come persona con controllo significativo il 29 mar 2020

    2 paginePSC02

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 30 mar 2020

    • Capitale: GBP 200
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduce share prem a/c 18/03/2020
    RES13

    Cessazione della carica di Jenny Nancy Loncaster come amministratore in data 25 set 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 lug 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Timothy Mark Busby come amministratore in data 12 set 2019

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2019 al 31 mar 2020

    1 pagineAA01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da PO Box 16 Wilkin Chapman Llp New Oxford House Town Hall Square Grimsby North East Lincolnshire DN31 1HE England a Karro Food Group Hugden Way Norton Grove Industrial Estate Norton Malton North Yorkshire YO17 9HG

    1 pagineAD02

    Nomina di Mr Michael Kamiel Jan Alfons Kestemont come amministratore in data 04 lug 2019

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2018

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di Wilkin Chapman Company Secretarial Services Limited come segretario in data 04 lug 2019

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 lug 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KESTEMONT, Michael Kamiel Jan Alfons
    St. Peters Square
    M2 3AE Manchester
    1
    Amministratore
    St. Peters Square
    M2 3AE Manchester
    1
    United KingdomBelgian231792890001
    CHEESEMAN, David Benjamin
    83 Newland Park
    HU5 2DR Hull
    Segretario
    83 Newland Park
    HU5 2DR Hull
    British1031110002
    MIDGLEY, Lisbeth Jane
    64 Mill Road
    Swanland
    HU14 3PL North Ferriby
    North Humberside
    Segretario
    64 Mill Road
    Swanland
    HU14 3PL North Ferriby
    North Humberside
    British70971410001
    WILKIN CHAPMAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    Segretario
    Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione02249348
    75197930001
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Segretario nominato
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    BRITTON, Christopher Paul
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish127835580001
    BUSBY, Timothy Mark
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    Amministratore
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    EnglandEnglish169852920001
    CHEESEMAN, David Benjamin
    83 Newland Park
    HU5 2DR Hull
    Amministratore
    83 Newland Park
    HU5 2DR Hull
    EnglandBritish1031110002
    DEN HOLLANDER, Leendert Pieter
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    EnglandDutch166335910001
    EVANS, Thomas Jeffrey
    Tudor Lodge
    308 Beverley Road Anlaby
    HU10 7BG Hull
    Amministratore
    Tudor Lodge
    308 Beverley Road Anlaby
    HU10 7BG Hull
    EnglandBritish2183390002
    LEADBEATER, Stephen Paul
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    Amministratore
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    EnglandBritish84487230001
    LEADBEATER, Stephen Paul
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    Amministratore
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    EnglandBritish84487230001
    LOFTS, Malcolm Herbert
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    EnglandBritish177239110001
    LONCASTER, Jenny Nancy
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    EnglandBritish205633180001
    MIDGLEY, Barry George
    64 Mill Road
    Swanland
    HU14 3PL North Ferriby
    North Humberside
    Amministratore
    64 Mill Road
    Swanland
    HU14 3PL North Ferriby
    North Humberside
    EnglandBritish38013830001
    MIDGLEY, Fraser
    16 Kenilworth Avenue
    HU5 4BH Hull
    Amministratore
    16 Kenilworth Avenue
    HU5 4BH Hull
    British70971400002
    PARKER, Michael
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    Amministratore
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    United KingdomBritish2785890001
    WARD, Peter Selwyn
    155 Eastgate
    LN11 8DB Louth
    Lincolnshire
    Amministratore
    155 Eastgate
    LN11 8DB Louth
    Lincolnshire
    United KingdomBritish33803400001

    Chi sono le persone con controllo significativo di B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    England
    29 mar 2020
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    England
    No
    Forma giuridicaYoungs Seafood Ltd
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione3751665
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleEngland & Wales
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02353338
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 23 ott 2008
    Consegnato il 01 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale as Security Agent for the Secured Parties
    Transazioni
    • 01 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 23 set 2008
    Consegnato il 04 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale as Security Agent for the Secured Parties (The Security Agent)
    Transazioni
    • 04 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 21 mar 2007
    Consegnato il 31 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale the Security Agent
    Transazioni
    • 31 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 16 mar 2006
    Consegnato il 25 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale as Security Agent for the Secured Parties (The 'Security Agent')
    Transazioni
    • 25 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 dic 2005
    Consegnato il 17 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All material premises being l/h interest in land and buildings on the north east side of wassand street, kingston upon hull, together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) and all the subsidiary shares and investments and all corresponding distribution rights. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale (The Security Agent)
    Transazioni
    • 17 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security accession deed
    Creato il 30 giu 2004
    Consegnato il 10 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    With full title guarantee, both present and future by way of first legal mortgage the property specified in schedule 1 to the accession deed, together with all buildings and fixtures and all the subsidiary shares and investments specified in schedule 2 to the accession deed;. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The Securityagent)
    Transazioni
    • 10 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 02 mag 2003
    Consegnato il 15 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 15 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 mar 2001
    Consegnato il 03 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 03 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 ott 2000
    Consegnato il 01 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 01 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    10 lug 2020Inizio della liquidazione
    13 gen 2022Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Nicholas James Timpson
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Praticante
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Mark Jeremy Orton
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Praticante
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Stephen John Absolom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0