COMMUNITY HEALTH PARTNERSHIPS LIMITED

COMMUNITY HEALTH PARTNERSHIPS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOMMUNITY HEALTH PARTNERSHIPS LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04220587
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di COMMUNITY HEALTH PARTNERSHIPS LIMITED?

    • Attività di amministrazione pubblica generale (84110) / Amministrazione pubblica e difesa; previdenza sociale obbligatoria

    Dove si trova COMMUNITY HEALTH PARTNERSHIPS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Suite 12b, Manchester One
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di COMMUNITY HEALTH PARTNERSHIPS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PARTNERSHIPS FOR HEALTH LIMITED 11 set 200111 set 2001
    INTERCEDE 1730 LIMITED21 mag 200121 mag 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di COMMUNITY HEALTH PARTNERSHIPS LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 mar 2026
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 dic 2026
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2025

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per COMMUNITY HEALTH PARTNERSHIPS LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al15 mag 2026
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma29 mag 2026
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al15 mag 2025
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per COMMUNITY HEALTH PARTNERSHIPS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Bilancio redatto al 31 mar 2025

    85 pagineAA

    Nomina di Ms Sylwia Kuteszko-Tranmer come amministratore in data 31 ago 2025

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Matthew James Cooper come amministratore in data 31 ago 2025

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Stephen David Talboys come amministratore in data 01 mag 2025

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 mag 2025 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Nomina di Mr Ian Simon Ailles come amministratore in data 14 apr 2025

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Robert Alexander come amministratore in data 31 mar 2025

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Malcolm Douglas Twite come amministratore in data 10 apr 2025

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mar 2024

    135 pagineAA

    Nomina di Mr Matthew James Cooper come amministratore in data 29 ott 2024

    2 pagineAP01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 18 set 2024

    • Capitale: GBP 82,788,664
    3 pagineSH01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 16 ott 2024

    • Capitale: GBP 82,788,664
    3 pagineSH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 mag 2024 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Nomina di Eleanor Mason come amministratore in data 01 apr 2024

    2 pagineAP01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 25 mar 2024

    • Capitale: GBP 80,038,142
    3 pagineSH01

    Cessazione della carica di Ben Masterson come amministratore in data 01 apr 2024

    1 pagineTM01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 18 dic 2023

    • Capitale: GBP 77,677,142
    3 pagineSH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2023

    118 pagineAA

    Nomina di Mr Eric Thierry Guillaume come amministratore in data 01 nov 2023

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Peter Cornforth come amministratore in data 01 nov 2023

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Geraldine Mary Strathdee come amministratore in data 31 ago 2023

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Charaanjit Kaur Yogeshbhai Patel come amministratore in data 31 ago 2023

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 mag 2023 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2022

    59 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 ott 2022 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di COMMUNITY HEALTH PARTNERSHIPS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    AILLES, Ian Simon
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    Amministratore
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    EnglandBritish128695490001
    ARIF, Nafees
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    Amministratore
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    EnglandBritish205771390001
    CORNFORTH, Peter
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    Amministratore
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    United KingdomBritish15813820010
    FARRINGTON CHADD, Wendy
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    Amministratore
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    EnglandBritish285255660001
    GUILLAUME, Eric Thierry
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    Amministratore
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    EnglandFrench205578950002
    KUTESZKO-TRANMER, Sylwia
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    Amministratore
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    United KingdomBritish338776580001
    MASON, Catherine
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    Amministratore
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    EnglandBritish262828280001
    MASON, Eleanor Lucy
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    Amministratore
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    United KingdomBritish322659450001
    TALBOYS, Stephen David
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    Amministratore
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    United KingdomBritish158182830001
    WILLIAMS, Richard Stephen
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    Amministratore
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    EnglandBritish159819070001
    GOLDSTONE, David Lionel Alexander
    17 Clarence Road
    AL1 4NN St. Albans
    Hertfordshire
    Segretario
    17 Clarence Road
    AL1 4NN St. Albans
    Hertfordshire
    British79020680002
    HAMBLEY, Elizabeth
    7 Lancaster Lodge
    83 Lancaster Road
    W11 1QH London
    Segretario
    7 Lancaster Lodge
    83 Lancaster Road
    W11 1QH London
    British74202140001
    MACGREGOR, Donald Roy, Dr
    63 High Street
    Ashwell
    SG7 5NP Baldock
    Hertfordshire
    Segretario
    63 High Street
    Ashwell
    SG7 5NP Baldock
    Hertfordshire
    British125583770001
    WARD, Lesley Anne
    169 Acton Lane
    W4 5HN London
    Segretario
    169 Acton Lane
    W4 5HN London
    British28874470001
    WEBSTER, Paul Barnaby
    25 Leconfield Avenue
    Barnes
    SW13 0LD London
    Segretario
    25 Leconfield Avenue
    Barnes
    SW13 0LD London
    British119602340002
    WILSON, Rebecca Claire Hartle
    154 Compass House
    Smugglers Way Wandsworth
    SW18 1DB London
    Segretario
    154 Compass House
    Smugglers Way Wandsworth
    SW18 1DB London
    British117878590001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Segretario nominato
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900004680001
    ALEXANDER, Robert
    Villiers Avenue
    KT5 8BD Surbiton
    6
    England
    Amministratore
    Villiers Avenue
    KT5 8BD Surbiton
    6
    England
    EnglandBritish119811910001
    BACON, John William
    Ventnor Villas
    BN3 3DD Hove
    3
    East Sussex
    United Kingdom
    Amministratore
    Ventnor Villas
    BN3 3DD Hove
    3
    East Sussex
    United Kingdom
    EnglandBritish157812400001
    BALDWIN, Richard Keith, Dr
    The Shaugh
    TN7 4DP Upper Hartfield
    East Sussex
    Amministratore
    The Shaugh
    TN7 4DP Upper Hartfield
    East Sussex
    United KingdomBritish37207590001
    BEER, Nigel Jonathan
    Thames Road
    Goring
    RG8 9AL Reading
    Southdene
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Thames Road
    Goring
    RG8 9AL Reading
    Southdene
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish122862210002
    BEHAN, David, Sir
    39 Manor Road
    Rusthall
    TN4 8UD Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    39 Manor Road
    Rusthall
    TN4 8UD Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritish125810090001
    BELFIELD, Stuart Gary
    170 Maldon Road
    CO5 0PH Tiptree
    Essex
    Amministratore
    170 Maldon Road
    CO5 0PH Tiptree
    Essex
    British101630240001
    BICKNELL, Anthony Guy Kirsten
    9 Chelverton Road
    SW15 1RW London
    Amministratore
    9 Chelverton Road
    SW15 1RW London
    United KingdomBritish60914720001
    CLYNE, Patrick Joe
    Pinner View
    HA1 4QD Harrow
    70
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Pinner View
    HA1 4QD Harrow
    70
    Middlesex
    England
    EnglandBritish148568350001
    CLYNE, Patrick Joseph
    25 Brookfield Road
    Far Headingley
    LS6 4EJ Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    25 Brookfield Road
    Far Headingley
    LS6 4EJ Leeds
    West Yorkshire
    British87643340001
    COATES, Peter Alexander
    15 The Drive
    CR5 2BL Coulsdon
    Surrey
    Amministratore
    15 The Drive
    CR5 2BL Coulsdon
    Surrey
    EnglandBritish78007040001
    COATES, Peter Alexander
    15 The Drive
    CR5 2BL Coulsdon
    Surrey
    Amministratore
    15 The Drive
    CR5 2BL Coulsdon
    Surrey
    EnglandBritish78007040001
    COLIN THOME, David Geoffrey, Professor
    Higher View
    Newton By Frodsham
    WA6 6TN Kingsley
    Cheshire
    Amministratore
    Higher View
    Newton By Frodsham
    WA6 6TN Kingsley
    Cheshire
    British99313660001
    CONROY, Bernadette Sarah
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    Amministratore
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    EnglandBritish89070800002
    COOPER, Matthew James
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    Amministratore
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    United KingdomBritish331249000001
    DAY, Mark
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    Amministratore
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    EnglandBritish157242280003
    EVERINGTON, Anthony Herbert, Dr
    28 Rhondda Grove
    E3 5AP London
    Amministratore
    28 Rhondda Grove
    E3 5AP London
    United KingdomBritish20579120001
    EVERINGTON, Anthony Herbert, Dr
    28 Rhondda Grove
    E3 5AP London
    Amministratore
    28 Rhondda Grove
    E3 5AP London
    United KingdomBritish20579120001
    FARLEY, George Peter
    6 Meriton Rise
    Hadleigh
    IP7 5SB Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    6 Meriton Rise
    Hadleigh
    IP7 5SB Ipswich
    Suffolk
    EnglandBritish123834510001

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0