MSQ MARKETING LIMITED

MSQ MARKETING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMSQ MARKETING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04273580
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MSQ MARKETING LIMITED?

    • Ricerche di mercato e sondaggi d'opinione pubblica (73200) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova MSQ MARKETING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o MSQ PARTNERS LIMITED
    90 Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MSQ MARKETING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ILLUMINAS LIMITED21 feb 200621 feb 2006
    INCEPTA MARKETING INTELLIGENCE LIMITED16 lug 200316 lug 2003
    INCEPTA SERVICE COMPANY LIMITED 03 ott 200103 ott 2001
    INTERCEDE 1738 LIMITED20 ago 200120 ago 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di MSQ MARKETING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 feb 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per MSQ MARKETING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 ago 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed illuminas LIMITED\certificate issued on 28/01/16
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name28 gen 2016

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 16 dic 2015

    RES15

    Bilancio redatto al 28 feb 2015

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 ago 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 set 2015

    Stato del capitale al 09 set 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato C/O Browne Jacobson Llp 15th Floor 6 Bevis Marks London EC3A 7BA

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a C/O Browne Jacobson Llp 15th Floor 6 Bevis Marks London EC3A 7BA

    1 pagineAD02

    Bilancio redatto al 28 feb 2014

    18 pagineAA

    Memorandum e Statuto

    22 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzioni

    Various agreements as listed 16/07/2014
    RES13

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 042735800007 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 20 ago 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 ago 2014

    Stato del capitale al 20 ago 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Msq Partners Ltd 6 York Street London W1U 6PL England a C/O Msq Partners Limited 90 Tottenham Court Road London W1T 4TJ in data 13 ago 2014

    1 pagineAD01

    Iscrizione dell'ipoteca 042735800009, creata il 16 lug 2014

    59 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 042735800008, creata il 16 lug 2014

    55 pagineMR01

    Bilancio redatto al 28 feb 2013

    17 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 042735800007

    17 pagineMR01

    Bilancio annuale redatto al 20 ago 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 ago 2013

    Stato del capitale al 27 ago 2013

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O C/O Media Square Plc 6 York Street London W1U 6PL United Kingdom* in data 27 ago 2013

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Daniel Yardley come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di MSQ MARKETING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SHAH, Ashish
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    Segretario
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    164776410001
    REID, Peter David
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    Amministratore
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    EnglandBritish147274580002
    YARDLEY, Daniel John
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    Amministratore
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    EnglandBritish180507300001
    BRIGDEN, Colin John
    c/o C/O Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    Segretario
    c/o C/O Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    147343040001
    BUTTERWORTH, Michael Guy
    The Woodman,
    Howe Street, Great Waltham
    CM3 1BA Chelmsford
    Segretario
    The Woodman,
    Howe Street, Great Waltham
    CM3 1BA Chelmsford
    British76600500002
    CLARKE, Martin John
    105 Congleton Road
    SK11 7XD Macclesfield
    Cheshire
    Segretario
    105 Congleton Road
    SK11 7XD Macclesfield
    Cheshire
    British53461320002
    LEES, Jennifer Kathryn
    15-17 Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    Segretario
    15-17 Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    British24587010002
    WINFIELD, Bruce Malcolm
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    Segretario
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    British147948820001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Segretario nominato
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900004680001
    BODEN, Andrew
    86 Sedley Close
    Parkwood
    ME8 9QY Rainham
    Kent
    Amministratore
    86 Sedley Close
    Parkwood
    ME8 9QY Rainham
    Kent
    British78382060001
    BURNS, Graeme Ian, Mr.
    29 Moody Street
    CW12 4AN Congleton
    Cheshire
    Amministratore
    29 Moody Street
    CW12 4AN Congleton
    Cheshire
    United KingdomBritish75720570001
    BUTTERWORTH, Michael Guy
    The Woodman,
    Howe Street, Great Waltham
    CM3 1BA Chelmsford
    Amministratore
    The Woodman,
    Howe Street, Great Waltham
    CM3 1BA Chelmsford
    EnglandBritish76600500002
    NICHOLS, Richard Stephen
    15a Rothamsted Avenue
    AL5 2DD Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    15a Rothamsted Avenue
    AL5 2DD Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish54128690003
    RICH, Michael William
    Hillfield
    Gorse Hill Farningham
    DA4 0JU Dartford
    Kent
    Amministratore delegato nominato
    Hillfield
    Gorse Hill Farningham
    DA4 0JU Dartford
    Kent
    British900020860001
    SELMAN, Roger Malcolm
    5 Vineries Bank
    Milespit Hill Mill Hill
    NW7 2RP London
    Amministratore
    5 Vineries Bank
    Milespit Hill Mill Hill
    NW7 2RP London
    United KingdomBritish10691510002
    WARNER, William
    2 Honeysuckle Gardens
    CR0 8XU Croydon
    Amministratore delegato nominato
    2 Honeysuckle Gardens
    CR0 8XU Croydon
    British900019540001
    WINFIELD, Bruce Malcolm
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    Amministratore
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    United KingdomBritish147948820001
    WRIGHT, David Ernest
    The Priory
    23 Matham Road
    KT8 0SX East Molesey
    Surrey
    Amministratore
    The Priory
    23 Matham Road
    KT8 0SX East Molesey
    Surrey
    British14119160001
    WRIGHT, Dean Anthony
    c/o C/O Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o C/O Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    EnglandBritish159138180001

    Chi sono le persone con controllo significativo di MSQ MARKETING LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Msq Holdings Limited
    90 Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    C/O Msq Partners Limited
    England
    06 apr 2016
    90 Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    C/O Msq Partners Limited
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleUk (England And Wales)
    Luogo di registrazioneUk (England) - Companies House
    Numero di registrazione01382912
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    MSQ MARKETING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 16 lug 2014
    Consegnato il 21 lug 2014
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Nvm Private Equity Limited
    Transazioni
    • 21 lug 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 16 lug 2014
    Consegnato il 18 lug 2014
    In corso
    Breve descrizione
    Description of all registered intellectual property rights subject to this security can be found in schedule 5 of the debenture.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC Acting as Agent for National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 lug 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 27 set 2013
    Consegnato il 04 ott 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 04 ott 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 02 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental debenture
    Creato il 06 feb 2012
    Consegnato il 23 feb 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 23 feb 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 02 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 08 dic 2011
    Consegnato il 29 dic 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of an account whether in sterling or any other currency or currency unit and the debt from time to time owing by the bank represented by that sum see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 29 dic 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 02 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 08 dic 2011
    Consegnato il 20 dic 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 20 dic 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 02 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Accession deed
    Creato il 22 nov 2005
    Consegnato il 05 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 05 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18TH october 2004 and
    Creato il 12 ago 2005
    Consegnato il 26 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18 october 2004 and
    Creato il 27 lug 2005
    Consegnato il 04 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 04 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0