TARGETFOLLOW (NORTH) LIMITED

TARGETFOLLOW (NORTH) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTARGETFOLLOW (NORTH) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04387215
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TARGETFOLLOW (NORTH) LIMITED?

    • (7020) /

    Dove si trova TARGETFOLLOW (NORTH) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    BDO LLP
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TARGETFOLLOW (NORTH) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HALLCO 728 LIMITED05 mar 200205 mar 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di TARGETFOLLOW (NORTH) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2009

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per TARGETFOLLOW (NORTH) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per TARGETFOLLOW (NORTH) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 07 mag 2015

    11 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 07 mag 2015

    11 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 19 mar 2015

    11 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 19 set 2014

    11 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 19 mar 2014

    11 pagine2.24B

    Nomina di un curatore o di un gestore

    5 pagineRM01

    Nomina di un curatore o di un gestore

    5 pagineRM01

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 19 set 2013

    10 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 19 mar 2013

    11 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 19 set 2012

    11 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 19 mar 2012

    10 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 14 nov 2011

    11 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 14 mag 2011

    11 pagine2.24B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    2 pagineF2.18

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    42 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    17 pagine2.16B

    Indirizzo della sede legale modificato da * Riverside House 11-12 Riverside Road Norwich Norfolk NR1 1SQ* in data 24 nov 2010

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Cessazione della carica di Vanessa Fletcher come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 05 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 apr 2010

    Stato del capitale al 09 apr 2010

    • Capitale: GBP 2
    • Capitale: USD 100
    SH01

    Cessazione della carica di Ian Fox come amministratore

    2 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di TARGETFOLLOW (NORTH) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    NAGHSHINEH, Ardeshir
    Mergate Farmhouse
    Mergate Lane Bracon Ash
    NR14 8ER Norwich
    Norfolk
    Segretario
    Mergate Farmhouse
    Mergate Lane Bracon Ash
    NR14 8ER Norwich
    Norfolk
    British60588430004
    NAGHSHINEH, Ardeshir
    Mergate Farmhouse
    Mergate Lane Bracon Ash
    NR14 8ER Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    Mergate Farmhouse
    Mergate Lane Bracon Ash
    NR14 8ER Norwich
    Norfolk
    EnglandBritish60588430004
    NAGHSHINEH, Shapoor
    The Old Hall
    Church Lane Barford
    NR9 4AY Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    The Old Hall
    Church Lane Barford
    NR9 4AY Norwich
    Norfolk
    EnglandBritish52621450004
    FURNESS, Deborah Jane
    10 Springfield Road
    Droylsden
    M43 7RE Manchester
    Segretario
    10 Springfield Road
    Droylsden
    M43 7RE Manchester
    British70000190002
    HALLIWELLS SECRETARIES LIMITED
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    Segretario nominato
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    900013280001
    FLETCHER, Vanessa Anne
    Wrentham House
    86 Southwold Road, Wrentham
    NR34 7JF Beccles
    Amministratore
    Wrentham House
    86 Southwold Road, Wrentham
    NR34 7JF Beccles
    EnglandBritish101139900001
    FOX, Ian Stuart
    Dove Barn
    Queen's Road Hethersett
    NR9 3DB Norwich
    Amministratore
    Dove Barn
    Queen's Road Hethersett
    NR9 3DB Norwich
    EnglandBritish154671930001
    NAVIEDE, Justine Penrose
    Melilia House
    Mereside Road Mere
    WA16 6QW Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    Melilia House
    Mereside Road Mere
    WA16 6QW Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish36734870001
    SMITH, Warren James, Lord Lieutenant
    145 Old Hall Lane
    Fallowfield
    M14 6HJ Manchester
    Greater Manchester
    Amministratore
    145 Old Hall Lane
    Fallowfield
    M14 6HJ Manchester
    Greater Manchester
    EnglandBritish14246400001
    HALLIWELLS DIRECTORS LIMITED
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    Amministratore delegato nominato
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    900013270001

    TARGETFOLLOW (NORTH) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 22 dic 2006
    Consegnato il 09 gen 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from targetfollow (regional) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H 58-60 lime street liverpool t/no MS379776 and l/h longsight shopping centre stockport road manchester t/no GM303049 together with all buildings erections and fixtures and fittings (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant equipment and machinery. All monies deposited with the trustee. Floating charge the whole of the company's undertaking.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance LTD
    Transazioni
    • 09 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of assignment
    Creato il 22 dic 2006
    Consegnato il 09 gen 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from targetfollow (regional) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due to the company under the lease/s in respect of l/h 58-60 lime street liverpool t/no MS379776 and l/h longsight shopping centre stockport road manchester t/no GM303049. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance LTD
    Transazioni
    • 09 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge not registered at companies house
    Creato il 24 mag 2005
    In corso
    Transazioni
    • Nomina di un amministratore o gestore (RM01)
    • 207 dic 2013Nomina di un amministratore o gestore (RM01)
      • Numero di pratica 2
    Debenture
    Creato il 24 mag 2005
    Consegnato il 06 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H interest in 58/66 lime street liverpool t/no MS379776 and l/h interest in longsight shopping centre manchester t/no GM303049 and the ancillary rights. By way of fixed charge all plant machinery and chattels, all monies standing to the credit of each account, all rental income, its goodwill and uncalled capital. By way of assignment the benefit and rights under any agreement and all other contracts, the benefit and claims under or in respect of the specified insurances and rental income. By way of floating charge the undertaking property rights and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Security Trustee for the Financeparties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 06 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 ott 2002
    Consegnato il 05 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Freehold property being 70 church street runcorn title number CH394905 springfield garages woodhouse lane wigan title number GM233400 castle street shrewsbury title number SL36008 for further details of property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Security Trustee for the Financeparties
    Transazioni
    • 05 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 09 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent assignment deed
    Creato il 13 set 2002
    Consegnato il 01 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The benefit of all rent and other sums arrears value added tax interest and insurance monies arising from leases licences and other occupational arrangements in respect of the properties listed in the schedule attached to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 01 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 set 2002
    Consegnato il 25 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage the l/h property k/a longsight district shopping centre on the east side of stockport road, manchester t/n GM303049, assigns the rental income, the benefit of all guarantees warranties and representations, the benefit of all agreements for lease and all sums payable to the company under or in respect of any agreement for lease.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 25 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ott 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 13 set 2002
    Consegnato il 25 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 25 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ott 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Amending deed relating to the legal mortgage dated 18 december 1998
    Creato il 13 set 2002
    Consegnato il 25 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/Hold land and buildings known as longsight district shopping centre on the east side of stockport road,manchester; t/no gm 303049. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 25 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ott 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Amending deed relating to legal mortgage dated 24 february 1998
    Creato il 13 set 2002
    Consegnato il 25 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/Hold land and buildings known as 58/66 lime street,liverpool; t/no ms 379776; f/hold land and buildings known as 70 church street,runcorn; ch 384905. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 25 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ott 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Amending deed relating to the legal mortgage dated 26 october 1995
    Creato il 13 set 2002
    Consegnato il 25 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/Hold land with buildings thereon and known as 18-20 castle street,shrewsbury,shropshire; sl 36008. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 25 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ott 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Amending deed relating to the legal charge dated 27 january 2000
    Creato il 13 set 2002
    Consegnato il 25 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/Hold property land and buildings on the westerly side of woodhouse lane,wigan; t/no gm 233400; all rights,buildings,fixtures,fittings,plant and machinery thereon; all gross rents licence fees and other monies receivable at any time in respect of any lease of the property or any agreement for lease; the benefit of all guarantees warranties rights or remedies and all plant,machinery,fixtures,fittings and other items; the proceeds of any claim,benefit of any agreements and all sums paid thereunder and all right,title and interest in and to all payments made under any insurance policies in respect of all property assets debts rights and undertaking; the goodwill of business and all licences and all funds standing to the credit of the company on any account. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 25 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ott 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    TARGETFOLLOW (NORTH) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    15 nov 2010Inizio dell'amministrazione
    07 mag 2015Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    James Joseph Bannon
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praticante
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Sarah Megan Rayment
    55 Baker Street
    W14 7EU London
    Praticante
    55 Baker Street
    W14 7EU London
    2Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Richard James Stanley
    22 Hanover Square
    W1S 1JA London
    Ricevitore/gestore
    22 Hanover Square
    W1S 1JA London
    Jemma Kathleen Mcandrew
    22 Hanover Square
    W1S 1JA London
    Ricevitore/gestore
    22 Hanover Square
    W1S 1JA London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0