Deborah Jane MASON
Persona fisica
Titolo | |
---|---|
Nome | Deborah |
Secondo nome | Jane |
Cognome | MASON |
Data di nascita | |
È un dirigente societario | No |
Incarichi | |
Attivo | 1 |
Inattivo | 2 |
Dimesso | 22 |
Totale | 25 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPC SECRETARIES LIMITED | 31 ott 2007 | Attiva | Manager | Amministratore | Ainsworth Street BB1 6AY Blackburn Mentor House England | England | British | |
HALLCO 1241 LIMITED | 07 nov 2005 | Sciolta | Segretario | Oldham Broadway Business Park Chadderton OL9 9XA Oldham Canada House, Unit 3c, Broadgate England | British | |||
HALLCO 900 LIMITED | 31 lug 2002 | Sciolta | Segretario | 10 Springfield Road Droylsden M43 7RE Manchester | British | |||
DREAMSPACE CONSTRUCTION LIMITED | 31 ago 2007 | 08 apr 2025 | Attiva | Secretary | Segretario | Mentor House, Ainsworth Street Blackburn BB1 6AY Lancashire | British | |
HULTON SQUARE (ORDSALL) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 14 ago 2007 | 21 feb 2020 | Attiva | Secretary | Segretario | Essex Road EN11 0DR Hoddesdon Rmg House England | British | |
RARE DEVELOPMENTS LIMITED | 31 mar 2000 | 27 apr 2017 | Sciolta | Segretario | Optimum House Clippers Quay M50 3XP Salford Manchester | British | ||
LAKESIDE (BLACKLEY) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 11 giu 2004 | 11 dic 2014 | Attiva | Segretario | 45 Vivian Avenue NW4 3XA London Buckingham House England | British | ||
VIEW 146 MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 29 set 2003 | 22 ago 2013 | Attiva | Segretario | Optimum House Clippers Quay M50 3XP Salford Manchester | British | ||
CHAV COUTURE LIMITED | 18 mag 2005 | 01 mag 2011 | Sciolta | Secretary | Segretario | Optimum House Clippers Quay M50 3XP Salford Greater Manchester | British | |
QUAY 5 (SALFORD) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 27 feb 2005 | 16 feb 2010 | Attiva | Segretario | 729 Princess Road M20 2LT Manchester Southern Gate | British | ||
RADCLYFFE MEWS (ORDSALL) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 14 ago 2007 | 28 set 2009 | Attiva | Secretary | Segretario | 4 Birchwood Hollybank Chase M43 7ST Droylsden Manchester | British | |
SOUTHMOOR 23 MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 17 mar 2004 | 09 dic 2008 | Attiva | Segretario | 4 Birchwood Hollybank Chase M43 7ST Droylsden Manchester | British | ||
LPC AVIATION LIMITED | 08 giu 2005 | 01 mar 2008 | Sciolta | Secretary | Segretario | 4 Birchwood Hollybank Chase M43 7ST Droylsden Manchester | British | |
NW INVESTMENTS LIMITED | 31 lug 2002 | 01 mar 2008 | Sciolta | Segretario | 4 Birchwood Hollybank Chase M43 7ST Droylsden Manchester | British | ||
LPC LIVING LIMITED | 31 mar 2000 | 01 mar 2008 | Attiva | Segretario | 4 Birchwood Hollybank Chase M43 7ST Droylsden Manchester | British | ||
HALLCO 123 LIMITED | 31 mar 2000 | 01 mar 2008 | Sciolta | Segretario | 4 Birchwood Hollybank Chase M43 7ST Droylsden Manchester | British | ||
GRESHAM MILL MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 29 set 2003 | 01 mag 2007 | Attiva | Segretario | 4 Birchwood Hollybank Chase M43 7ST Droylsden Manchester | British | ||
STANLEY VILLA DEVELOPMENTS LIMITED | 18 gen 2002 | 24 mar 2007 | Attiva | Segretario | 4 Birchwood Hollybank Chase M43 7ST Droylsden Manchester | British | ||
RO REGIONAL PROPERTIES LIMITED | 31 lug 2002 | 08 nov 2002 | Attiva | Segretario | 10 Springfield Road Droylsden M43 7RE Manchester | British | ||
TARGETFOLLOW (CHADDERTON) LIMITED | 31 lug 2002 | 01 ott 2002 | Sciolta | Segretario | 10 Springfield Road Droylsden M43 7RE Manchester | British | ||
TARGETFOLLOW (NORTH) LIMITED | 31 lug 2002 | 01 ott 2002 | Sciolta | Segretario | 10 Springfield Road Droylsden M43 7RE Manchester | British | ||
TARGETFOLLOW (WEMBLEY) LIMITED | 31 lug 2002 | 01 ott 2002 | Sciolta | Segretario | 10 Springfield Road Droylsden M43 7RE Manchester | British | ||
TARGETFOLLOW (KIDLINGTON) LIMITED | 31 lug 2002 | 01 ott 2002 | Sciolta | Segretario | 10 Springfield Road Droylsden M43 7RE Manchester | British | ||
TARGETFOLLOW (RESIDENTIAL) LIMITED | 31 lug 2002 | 01 ott 2002 | Sciolta | Segretario | 10 Springfield Road Droylsden M43 7RE Manchester | British | ||
TARGETFOLLOW (PETERBOROUGH) LIMITED | 31 lug 2002 | 01 ott 2002 | Sciolta | Segretario | 10 Springfield Road Droylsden M43 7RE Manchester | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0