G2 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàG2 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04390861
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di G2 LIMITED?

    • (7415) /

    Dove si trova G2 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Davidson House
    Gadbrook Park
    CW9 7TW Northwich
    Cheshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di G2 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    AIRTIME GROUP HOLDINGS LIMITED20 mar 200220 mar 2002
    DIGAME LIMITED08 mar 200208 mar 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di G2 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per G2 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2010

    8 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 08 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Share premium account cancelled 23/02/2011
    RES13

    Stato del capitale al 14 mar 2011

    • Capitale: GBP 1.00
    6 pagineSH19

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2009

    11 pagineAA

    Cessazione della carica di Peter Smyth come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 08 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 set 2008

    13 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 30 set 2007

    13 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di G2 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HOGAN, Brenda Mary
    Sandyford View Simonsridge
    Blackglen Road Sandyford
    Dublin 18
    Apartment 55,
    Ireland
    Segretario
    Sandyford View Simonsridge
    Blackglen Road Sandyford
    Dublin 18
    Apartment 55,
    Ireland
    Other130814140001
    EDWARDS, Mark Simon
    2 Brook House Court
    Lakeside Road
    WA13 0GR Lymm
    Cheshire
    Amministratore
    2 Brook House Court
    Lakeside Road
    WA13 0GR Lymm
    Cheshire
    BritishFinance Director109659860001
    MALONEY, Michael John
    Beechwood Road
    Ranelagh
    8
    Dublin 6
    Ireland
    Amministratore
    Beechwood Road
    Ranelagh
    8
    Dublin 6
    Ireland
    IrelandIrishDirector161364970001
    GREGSON, Robin Anthony
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    Segretario
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    EnglishChartered Accountant107835250001
    KATZ, Peter David
    20 Tudor Close
    IG8 0LF Woodford Green
    Essex
    Segretario
    20 Tudor Close
    IG8 0LF Woodford Green
    Essex
    British64682050001
    LANIGAN, Philip Nicholas
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    Segretario
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    BritishDirector42734310002
    NEUBAUER, Eirion Andrew Charles
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    Segretario
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    BritishCompany Director116252510001
    THOMAS, Howard
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    Segretario nominato
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British900000900001
    ABERNETHY, Kieron Quinn
    2 Salisbury Place
    West Byfleet
    KT14 6SN London
    Amministratore
    2 Salisbury Place
    West Byfleet
    KT14 6SN London
    United KingdomBritishDirector200594530001
    BEERLING, Kevin
    14 Firside Grove
    DA15 8WB Sidcup
    Kent
    Amministratore
    14 Firside Grove
    DA15 8WB Sidcup
    Kent
    EnglandBritishDirector64677850002
    GREGSON, Robin Anthony
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    Amministratore
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    EnglandEnglishChartered Accountant107835250001
    LANIGAN, Philip Nicholas
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    EnglandBritishDirector42734310002
    MCNAIR, John
    7 Westcombe Park Road
    SE3 7RE London
    Amministratore
    7 Westcombe Park Road
    SE3 7RE London
    BritishCompany Director61297520001
    MCNAMARA, Peter Denis
    7 B Land Avenue
    AL5 4RG Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    7 B Land Avenue
    AL5 4RG Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector114555600001
    MILLS, Mark Richard
    55 Hove Road
    FY8 1XH Lytham St Annes
    Lancashire
    Amministratore
    55 Hove Road
    FY8 1XH Lytham St Annes
    Lancashire
    BritishDirector10402540005
    MURPHY, James Timmerman
    Park Ave #10c
    Nyc
    1120
    10728 New York
    Usa
    Amministratore
    Park Ave #10c
    Nyc
    1120
    10728 New York
    Usa
    AmericanDirector130237490001
    NEUBAUER, Eirion Andrew Charles
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    Amministratore
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    EnglandBritishCompany Director116252510001
    SAXTON, Paul
    19 Ashdale Close
    ST7 2EN Alsager
    Staffordshire
    Amministratore
    19 Ashdale Close
    ST7 2EN Alsager
    Staffordshire
    BritishDirector121726830001
    SMYTH, Peter Francis
    Flat 2 62 Queens Gate
    SW7 5JP London
    Amministratore
    Flat 2 62 Queens Gate
    SW7 5JP London
    IrishDirector63863190002
    STANLEY, Paul Robert
    70 Wolmer Gardens
    HA8 8DQ Edgware
    Middlesex
    Amministratore
    70 Wolmer Gardens
    HA8 8DQ Edgware
    Middlesex
    BritishDirector58251370003
    TESTER, William Andrew Joseph
    4 Geary House
    Georges Road
    N7 8EZ London
    Amministratore delegato nominato
    4 Geary House
    Georges Road
    N7 8EZ London
    United KingdomBritish900000890001
    TURRELL, Mary Margaret
    1 St Catherine Drive
    Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    Amministratore
    1 St Catherine Drive
    Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    EnglandBritishFinance Director92654710001

    G2 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Accession deed to an intercreditor deed dated 25 august 2005 and
    Creato il 19 dic 2005
    Consegnato il 06 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any member of the group to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Until after the discharge date if the additional obligor receives or recovers any intra-group recoveries except for any permitted intra-group payments it shall pay all such assets and monies received or recovered by it (the turnover receipts) to the security trustee for application in accordance with clause 10 (application of recoveries) of the deed. Pending such payment to the security trustee the additional obligor shall hold on trust for application by the security trustee in accordance with clause 10 (application of recoveries) of the deed. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 06 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Syndicated debenture
    Creato il 19 dic 2005
    Consegnato il 06 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 06 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 lug 2005
    Consegnato il 15 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All land (other than the short l/h land) rights in atm equipment, all other plant, machinery, vehicles and other equipment used in a business, investments; any contract entered into after the date of the debenture which is designated as a key contract by moneybox PLC and the chargee, any account, all copyright, any monetary claim of any kind and goodwill and uncalled capital, floating charge the company's undertaking and all its present and future assets;. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 15 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Memorandum of deposit and charge
    Creato il 02 ago 2002
    Consegnato il 21 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The stocks shares bonds debentures or other securities deposited with or transferred to the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 02 ago 2002
    Consegnato il 13 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or airtime interactive marketing LTD to the chargee on account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0