G2 LIMITED
Panoramica
Nome della società | G2 LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 04390861 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di G2 LIMITED?
- (7415) /
Dove si trova G2 LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Davidson House Gadbrook Park CW9 7TW Northwich Cheshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di G2 LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
AIRTIME GROUP HOLDINGS LIMITED | 20 mar 2002 | 20 mar 2002 |
DIGAME LIMITED | 08 mar 2002 | 08 mar 2002 |
Quali sono gli ultimi bilanci di G2 LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2010 |
Quali sono le ultime deposizioni per G2 LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2010 | 8 pagine | AA | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 08 mar 2011 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Stato del capitale al 14 mar 2011
| 6 pagine | SH19 | ||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2009 | 11 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Peter Smyth come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 08 mar 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2008 | 13 pagine | AA | ||||||||||||||
legacy | 2 pagine | 288a | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||||||
legacy | 3 pagine | 288a | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2007 | 13 pagine | AA | ||||||||||||||
legacy | 2 pagine | 288a | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | 288a | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | 288a | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | 287 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||||||
legacy | 3 pagine | 363a | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di G2 LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOGAN, Brenda Mary | Segretario | Sandyford View Simonsridge Blackglen Road Sandyford Dublin 18 Apartment 55, Ireland | Other | 130814140001 | ||||||
EDWARDS, Mark Simon | Amministratore | 2 Brook House Court Lakeside Road WA13 0GR Lymm Cheshire | British | Finance Director | 109659860001 | |||||
MALONEY, Michael John | Amministratore | Beechwood Road Ranelagh 8 Dublin 6 Ireland | Ireland | Irish | Director | 161364970001 | ||||
GREGSON, Robin Anthony | Segretario | 2 Lakeside East Morton BD20 5UY Keighley West Yorkshire | English | Chartered Accountant | 107835250001 | |||||
KATZ, Peter David | Segretario | 20 Tudor Close IG8 0LF Woodford Green Essex | British | 64682050001 | ||||||
LANIGAN, Philip Nicholas | Segretario | 120 Buckingham Road SK4 4RG Stockport Cheshire | British | Director | 42734310002 | |||||
NEUBAUER, Eirion Andrew Charles | Segretario | Flat 11 Kingsley Lodge 13 New Cavendish Street W1G 9UG London | British | Company Director | 116252510001 | |||||
THOMAS, Howard | Segretario nominato | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | 900000900001 | ||||||
ABERNETHY, Kieron Quinn | Amministratore | 2 Salisbury Place West Byfleet KT14 6SN London | United Kingdom | British | Director | 200594530001 | ||||
BEERLING, Kevin | Amministratore | 14 Firside Grove DA15 8WB Sidcup Kent | England | British | Director | 64677850002 | ||||
GREGSON, Robin Anthony | Amministratore | 2 Lakeside East Morton BD20 5UY Keighley West Yorkshire | England | English | Chartered Accountant | 107835250001 | ||||
LANIGAN, Philip Nicholas | Amministratore | 120 Buckingham Road SK4 4RG Stockport Cheshire | England | British | Director | 42734310002 | ||||
MCNAIR, John | Amministratore | 7 Westcombe Park Road SE3 7RE London | British | Company Director | 61297520001 | |||||
MCNAMARA, Peter Denis | Amministratore | 7 B Land Avenue AL5 4RG Harpenden Hertfordshire | United Kingdom | British | Director | 114555600001 | ||||
MILLS, Mark Richard | Amministratore | 55 Hove Road FY8 1XH Lytham St Annes Lancashire | British | Director | 10402540005 | |||||
MURPHY, James Timmerman | Amministratore | Park Ave #10c Nyc 1120 10728 New York Usa | American | Director | 130237490001 | |||||
NEUBAUER, Eirion Andrew Charles | Amministratore | Flat 11 Kingsley Lodge 13 New Cavendish Street W1G 9UG London | England | British | Company Director | 116252510001 | ||||
SAXTON, Paul | Amministratore | 19 Ashdale Close ST7 2EN Alsager Staffordshire | British | Director | 121726830001 | |||||
SMYTH, Peter Francis | Amministratore | Flat 2 62 Queens Gate SW7 5JP London | Irish | Director | 63863190002 | |||||
STANLEY, Paul Robert | Amministratore | 70 Wolmer Gardens HA8 8DQ Edgware Middlesex | British | Director | 58251370003 | |||||
TESTER, William Andrew Joseph | Amministratore delegato nominato | 4 Geary House Georges Road N7 8EZ London | United Kingdom | British | 900000890001 | |||||
TURRELL, Mary Margaret | Amministratore | 1 St Catherine Drive Hartford CW8 2FE Northwich Cheshire | England | British | Finance Director | 92654710001 |
G2 LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Accession deed to an intercreditor deed dated 25 august 2005 and | Creato il 19 dic 2005 Consegnato il 06 gen 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any member of the group to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Until after the discharge date if the additional obligor receives or recovers any intra-group recoveries except for any permitted intra-group payments it shall pay all such assets and monies received or recovered by it (the turnover receipts) to the security trustee for application in accordance with clause 10 (application of recoveries) of the deed. Pending such payment to the security trustee the additional obligor shall hold on trust for application by the security trustee in accordance with clause 10 (application of recoveries) of the deed. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Syndicated debenture | Creato il 19 dic 2005 Consegnato il 06 gen 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 12 lug 2005 Consegnato il 15 lug 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All land (other than the short l/h land) rights in atm equipment, all other plant, machinery, vehicles and other equipment used in a business, investments; any contract entered into after the date of the debenture which is designated as a key contract by moneybox PLC and the chargee, any account, all copyright, any monetary claim of any kind and goodwill and uncalled capital, floating charge the company's undertaking and all its present and future assets;. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Memorandum of deposit and charge | Creato il 02 ago 2002 Consegnato il 21 ago 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The stocks shares bonds debentures or other securities deposited with or transferred to the bank. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 02 ago 2002 Consegnato il 13 ago 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or airtime interactive marketing LTD to the chargee on account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0