ST. ALDATES (98)(NO. 1) LIMITED
Panoramica
Nome della società | ST. ALDATES (98)(NO. 1) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 04413579 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ST. ALDATES (98)(NO. 1) LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova ST. ALDATES (98)(NO. 1) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 7th Floor 9 Berkeley Street W1J 8DW London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di ST. ALDATES (98)(NO. 1) LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per ST. ALDATES (98)(NO. 1) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 1 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 3500 Parkway Whiteley Fareham Hampshire PO15 7AL a 7th Floor 9 Berkeley Street London W1J 8DW in data 07 lug 2016 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 giu 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Jtc Cjersey) Limited il 16 giu 2016 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 giu 2015 | 14 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 lug 2014 | 15 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * 3Rd Floor 22 Grafton Street London W1S 4EX United Kingdom* in data 23 gen 2014 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 giu 2013 con elenco completo degli azionisti | 15 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Sixth Floor 63 Curzon Street London W1J 8PD* in data 22 nov 2012 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Martin Gordon Cudlipp come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Castle Directors Limited come amministratore | 3 pagine | AP02 | ||||||||||
Nomina di Jtc Directors Limited come amministratore | 3 pagine | AP02 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Jtc Management Limited il 21 mag 2012 | 3 pagine | CH04 | ||||||||||
Cessazione della carica di Nigel Le Quesne come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Roberto Monticelli come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Saffron Harrop come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Miranda Lansdowne come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ST. ALDATES (98)(NO. 1) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTC (JERSEY) LIMITED | Segretario | Elizabeth House 9 Castle Street JE4 2QP St Helier PO BOX 1075 Jersey Channel Islands |
| 160245490003 | ||||||||||
CUDLIPP, Martin Gordon | Amministratore | c/o Jtc Group Limited 1-5 Castle Street St. Helier JE2 4QP Jersey Elizabeth House PO BOX 1075 Channel Isles | Jersey | British | Director | 172570330001 | ||||||||
CASTLE DIRECTORS LIMITED | Amministratore | 9 Castle Street JE2 3RT St Helier Elizabeth House Jersey |
| 170374650001 | ||||||||||
JTC DIRECTORS LIMITED | Amministratore | 9 Castle Street JE2 3RT St Helier Elizabeth House Jersey |
| 170374460001 | ||||||||||
FRY, Anthony Neville | Segretario | 2 Redwood Drive Writtle CM1 3LY Chelmsford Essex | British | 79102820001 | ||||||||||
THOMAS, Howard | Segretario nominato | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | 900000900001 | ||||||||||
AIBJERSEYTRUST LIMITED | Segretario | 25 Esplanade JE1 2AB St Helier Aib House Jersey Channel Islands | 85248580005 | |||||||||||
BARRETT, Linda Jane | Amministratore | La Rue De Carteret Rue Des Pres St. Saviour JE2 7RA Jersey 4 | British | Company Director | 135027860001 | |||||||||
BLAMPIED, Michael Norman | Amministratore | Rue De Guilleaume Et D'Anneville St.Martin JE3 6DP Jersey Perinne Channel Islands | Uk | British | Trust Company Director | 150439570001 | ||||||||
BOUDAINS, James Kenneth | Amministratore | La Rue Mathurin Grouville JE3 9GL Jersey Springvale Channel Isles | British | Managing Director | 135028110001 | |||||||||
BURGIN, Philip Henry | Amministratore | 9 Castle Street JE4 2QP St Helier PO BOX 1075 Elizabeth House Jersey Channel Islands | Jersey | English | Director | 120326900007 | ||||||||
CROWE, Anthony Charles | Amministratore | La Cache De La Ronde Seapoint Le Grande Route De La Cote JE2 6BR St. Clement 6 Jersey | British | Company Director | 135028380001 | |||||||||
CROWE, Anthony Charles | Amministratore | 2 Seafield Avenue La Grande Route De La Cote JE2 6ND St Clements Jersey | British | Director | 78123030001 | |||||||||
FRY, Chrispian Francis Anstee | Amministratore | Woodville Avenue St. Helier JE2 4AP Jersey 40 Woodville Apartments Channel Isles | Jersey | British | Company Director | 191605130001 | ||||||||
GORROD, Joanne Louise | Amministratore | Upper Kings Cliff St. Helier JE2 3GP Jersey 2 Thornton Hall Channel Isles | Jersey, Channel Islands | British | Company Director | 175845830001 | ||||||||
HARROP, Saffron Louise | Amministratore | 9 Castle Street JE4 2QP St Helier PO BOX 1075 Elizabeth House Jersey Channel Islands | Jersey | British, | Director | 120408490001 | ||||||||
LANSDOWNE, Miranda Suzanne Helen | Amministratore | 9 Castle Street JE4 2QP St Helier PO BOX 1075 Elizabeth House Jersey Channel Islands | Jersey Channel Islands | British | Director | 160253960001 | ||||||||
LE COUILLIARD, David Philip | Amministratore | La Rue Des Pallieres St. Ouen JE3 2BB Jersey Le Passage Channel Isles | Jersey Channel Isles | British | Company Director | 135028580001 | ||||||||
LE QUESNE, Nigel Anthony | Amministratore | 9 Castle Street JE4 2QP St Helier PO BOX 1075 Elizabeth House Jersey Channel Islands | Jersey | British | Managing Director | 71675010004 | ||||||||
MONTICELLI, Roberto | Amministratore | 9 Castle Street JE4 2QP St Helier PO BOX 1075 Elizabeth House Jersey Channel Islands | Jersey | British | Director | 148791260001 | ||||||||
MONTICELLI, Roberto | Amministratore | 7 Orchard Mews Tower Road, St Helier JE2 3LX Jersey Channel Islands | Jersey | British | Director | 148791260001 | ||||||||
RUSBY, Geoffrey Lloyd | Amministratore | Beam End Duck Street, Wendens Ambo CB11 4JU Saffron Walden Essex | United Kingdom | British | Co Director | 16427110003 | ||||||||
STAPLES, Anthony John | Amministratore | Adison, Le Jardin De Lest La Rue De La Rosiere St. Mary JE3 3DG Jersey Channel Islands | British | Director | 73941150001 | |||||||||
TESTER, William Andrew Joseph | Amministratore delegato nominato | 4 Geary House Georges Road N7 8EZ London | United Kingdom | British | 900000890001 | |||||||||
UNDERWOOD-WHITNEY, Anthony James | Amministratore | 9 Castle Street JE4 2QP St Helier PO BOX 1075 Elizabeth House Jersey Channel Islands | Jersey | British | Director | 160254210001 | ||||||||
WHEELER, Lorraine Fay | Amministratore | La Rue Des Vignes St. Peter JE3 7YL Jersey L'Ailette Channel Isles | Channel Islands | British | Trust Company Director | 100921140001 | ||||||||
AIBJT CORPORATE LIMITED | Amministratore | 25 Esplanande JE1 2AB St Helier Aib House Jersey | 92635870004 |
ST. ALDATES (98)(NO. 1) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Mortgage | Creato il 11 dic 2002 Consegnato il 20 dic 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the chargors to the chargee and/or the lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari L/H property k/a 58-60 (formerly 57-60) st aldates oxford oxfordshire t/n ON125710 and f/h property situate at the rear of st aldates tavern st aldates oxford oxfordshire t/n ON194922 and the proceeds of sale thereof and all buildings and trade and other fixtures on any such property belongong to or charged to the second chargor or the third chargor. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0