HOMEFLAG LIMITED
Panoramica
| Nome della società | HOMEFLAG LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04439855 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di HOMEFLAG LIMITED?
- Operazione di taxi (49320) / Trasporto e stoccaggio
- Altri trasporti passeggeri via terra (49390) / Trasporto e stoccaggio
- Trasportatori autorizzati (53201) / Trasporto e stoccaggio
Dove si trova HOMEFLAG LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 35-37 William Road NW1 3ER London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di HOMEFLAG LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| BLUEBACK LIMITED | 16 apr 2003 | 16 apr 2003 |
| VERYNOON LIMITED | 15 mag 2002 | 15 mag 2002 |
Quali sono gli ultimi bilanci di HOMEFLAG LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 ago 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per HOMEFLAG LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 ago 2016 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr David George Stickland come amministratore in data 01 lug 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 mag 2016 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 ago 2015 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Kenneth Boland come segretario in data 04 gen 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mr Lee Gage come segretario in data 04 gen 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Nomina di Andrew Kenneth Boland come segretario in data 24 ago 2015 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Gary Cust come segretario in data 24 ago 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Gary Cust come amministratore in data 24 ago 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 mag 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Chief Financial Officer Andrew Kenneth Boland come amministratore in data 03 mar 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 ago 2014 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Gary Cust come amministratore in data 28 nov 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Matthew James Barbrook come amministratore in data 28 nov 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Matthew James Barbrook come segretario in data 25 apr 2014 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 mag 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2013 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Gary Cust come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 mag 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli della variazione dei diritti legati alle azioni | 2 pagine | SH10 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 29 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Liam Griffin il 17 mag 2013 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di HOMEFLAG LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAGE, Lee | Segretario | 9 Boyd Street E1 1NH London Flat 9 Victoria Mills United Kingdom | 207449740001 | |||||||
| BOLAND, Andrew Kenneth | Amministratore | William Road NW1 3ER London 35-37 England England | United Kingdom | British | 71264540006 | |||||
| GRIFFIN, Liam | Amministratore | William Road NW1 3ER London 35-37 England | England | British | 146320180001 | |||||
| STICKLAND, David George | Amministratore | William Road NW1 3ER London 35-37 United Kingdom | United Kingdom | British | 130704670001 | |||||
| BARBROOK, Matthew James | Segretario | William Road NW1 3ER London 35-37 England | British | 79274880001 | ||||||
| BOLAND, Andrew Kenneth | Segretario | William Road NW1 3ER London 35-37 England England | 200421510001 | |||||||
| CUST, Gary | Segretario | William Road NW1 3ER London 35-37 England | 187183860001 | |||||||
| FOSTER, Daryl | Segretario | Yoo Building 17 Hall Road NW8 9RF London Flat 45 | British | 43291390002 | ||||||
| KERR, Darren Mark, Mr. | Segretario | Christchurch Crescent WD7 8AU Radlett 20a Hertfordshire | British | 140334370001 | ||||||
| PIELSTICKER, Charles Albert | Segretario | 18 Hillhurst Blvd M4R 1K4 Toronto Ontario Canada | British | 82639410001 | ||||||
| PIELSTICKER, Scott William | Segretario | Flat 2 39 St Luke`S Road W11 1DD London | Canadian | 82639190003 | ||||||
| THOMAS, Howard | Segretario nominato | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | 900000900001 | ||||||
| DORSEYLAW SECRETARIES LIMITED | Segretario | 21 Wilson Street EC2M 2TD London | 74615640001 | |||||||
| BAILLIE, Aubrey | Amministratore | 90 St. Leonards Ave. Toronto Ontario M4n 1k5 | Canadian | 109409880001 | ||||||
| BANKS, Joseph Robert | Amministratore | 2 Albert Place W8 5PD London | United Kingdom | American | 97950200001 | |||||
| BARBROOK, Matthew James | Amministratore | William Road NW1 3ER London 35-37 England | United Kingdom | British | 79274880001 | |||||
| BUTCHER, Nicholas Terence | Amministratore | Moorcroft Abinger Lane Abinger Common RH5 6HZ Dorking Surrey | England | British | 18037300001 | |||||
| CUST, Gary William | Amministratore | William Road NW1 3ER London 35-37 | England | British | 193071220001 | |||||
| DARLING, Peter John | Amministratore | Chandlers House Fenwick Place SW9 9NW London | British | 91106210001 | ||||||
| FOSTER, Daryl | Amministratore | Yoo Building 17 Hall Road NW8 9RF London Flat 45 United Kingdom | United Kingdom | British | 43291390003 | |||||
| GRIFFIN, John Patrick | Amministratore | 23 The Avenue EN6 1EG Potters Bar Hertfordshire | United Kingdom | British,Irish | 43291450001 | |||||
| GRIFFIN, Kieran | Amministratore | Bedwell Park, Cucumber Lane Essendon AL9 6GJ Hatfield Pulham House Hertfordshire | United Kingdom | British | 82674390003 | |||||
| JOHNSON, Donald Kenneth | Amministratore | 287 Oriole Parkway MSP 2H4 Toronto Ontario Ms9 2h4 Canada | Canadian | 109607400001 | ||||||
| KENNEDY, Andrew James | Amministratore | 2 Edgarley Terrace SW6 6QF London | United Kingdom | Canadian | 101185570001 | |||||
| L'HEUREUX, Willard John | Amministratore | Eotvos U 47 FOREIGN Budapest 1067 Hungary | Canadian | 91989750001 | ||||||
| PEARCE, Colin Leighton | Amministratore | Lamorna 38 Denham Lane SL9 0ET Chalfont St Peter Buckinghamshire | United Kingdom | British | 169666820001 | |||||
| PIELSTICKER, Scott William | Amministratore | Flat 2 39 St Luke`S Road W11 1DD London | Canadian | 82639190003 | ||||||
| SCHWARZ, Steve | Amministratore | 12 Measham Road LE65 2PF Ashby De La Zouch Leicestershire | England | British | 109410140001 | |||||
| TESTER, William Andrew Joseph | Amministratore delegato nominato | 4 Geary House Georges Road N7 8EZ London | United Kingdom | British | 900000890001 | |||||
| HELKON SK LIMITED | Amministratore | 74a Charlotte Street W1T 4QJ London | 91989880001 |
HOMEFLAG LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture without written instrument | Creato il 02 mag 2007 Consegnato il 22 mag 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £300,000.00 due or to become due from the company to | |
Brevi particolari All company assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 21 gen 2007 Consegnato il 07 feb 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £300,000 and all other monies due or to become due | |
Brevi particolari Fixed & floating charge over all assets of the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 08 nov 2006 Consegnato il 29 nov 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £250,000 due or to become due from the company to the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 06 giu 2006 Consegnato il 26 giu 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £500,000 and all other monies due or to become due | |
Brevi particolari Fixed charge over the chattels and equipment, book debts, goodwill and uncalled capital and floating charge, all the undertaking. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture without written instrument | Creato il 23 nov 2005 Consegnato il 07 dic 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £1,542,200 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Fixed and floating over all the assets of the company (including, for the avoidance of doubt, book debts). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture without written instrument | Creato il 22 nov 2005 Consegnato il 02 dic 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £40,000 and us$80,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Fixed and floating over all the assets of the company (including, for the avoidance of doubt, book debts). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge | Creato il 29 giu 2004 Consegnato il 05 lug 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 30 nov 2003 Consegnato il 19 dic 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0