HOMEFLAG LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHOMEFLAG LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04439855
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HOMEFLAG LIMITED?

    • Operazione di taxi (49320) / Trasporto e stoccaggio
    • Altri trasporti passeggeri via terra (49390) / Trasporto e stoccaggio
    • Trasportatori autorizzati (53201) / Trasporto e stoccaggio

    Dove si trova HOMEFLAG LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    35-37 William Road
    NW1 3ER London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HOMEFLAG LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BLUEBACK LIMITED16 apr 200316 apr 2003
    VERYNOON LIMITED15 mag 200215 mag 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di HOMEFLAG LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ago 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per HOMEFLAG LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ago 2016

    6 pagineAA

    Nomina di Mr David George Stickland come amministratore in data 01 lug 2016

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 15 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 ago 2016

    Stato del capitale al 09 ago 2016

    • Capitale: GBP 2,023.81
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ago 2015

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Andrew Kenneth Boland come segretario in data 04 gen 2016

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Lee Gage come segretario in data 04 gen 2016

    2 pagineAP03

    Nomina di Andrew Kenneth Boland come segretario in data 24 ago 2015

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Gary Cust come segretario in data 24 ago 2015

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Gary Cust come amministratore in data 24 ago 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 15 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 lug 2015

    Stato del capitale al 03 lug 2015

    • Capitale: GBP 2,023.81
    SH01

    Nomina di Chief Financial Officer Andrew Kenneth Boland come amministratore in data 03 mar 2015

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ago 2014

    5 pagineAA

    Nomina di Mr Gary Cust come amministratore in data 28 nov 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Matthew James Barbrook come amministratore in data 28 nov 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Matthew James Barbrook come segretario in data 25 apr 2014

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 15 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 mag 2014

    Stato del capitale al 20 mag 2014

    • Capitale: GBP 2,023.81
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2013

    3 pagineAA

    Nomina di Mr Gary Cust come segretario

    2 pagineAP03

    Bilancio annuale redatto al 15 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli della variazione dei diritti legati alle azioni

    2 pagineSH10

    Risoluzioni

    Resolutions
    29 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Liam Griffin il 17 mag 2013

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di HOMEFLAG LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GAGE, Lee
    9 Boyd Street
    E1 1NH London
    Flat 9 Victoria Mills
    United Kingdom
    Segretario
    9 Boyd Street
    E1 1NH London
    Flat 9 Victoria Mills
    United Kingdom
    207449740001
    BOLAND, Andrew Kenneth
    William Road
    NW1 3ER London
    35-37
    England
    England
    Amministratore
    William Road
    NW1 3ER London
    35-37
    England
    England
    United KingdomBritish71264540006
    GRIFFIN, Liam
    William Road
    NW1 3ER London
    35-37
    England
    Amministratore
    William Road
    NW1 3ER London
    35-37
    England
    EnglandBritish146320180001
    STICKLAND, David George
    William Road
    NW1 3ER London
    35-37
    United Kingdom
    Amministratore
    William Road
    NW1 3ER London
    35-37
    United Kingdom
    United KingdomBritish130704670001
    BARBROOK, Matthew James
    William Road
    NW1 3ER London
    35-37
    England
    Segretario
    William Road
    NW1 3ER London
    35-37
    England
    British79274880001
    BOLAND, Andrew Kenneth
    William Road
    NW1 3ER London
    35-37
    England
    England
    Segretario
    William Road
    NW1 3ER London
    35-37
    England
    England
    200421510001
    CUST, Gary
    William Road
    NW1 3ER London
    35-37
    England
    Segretario
    William Road
    NW1 3ER London
    35-37
    England
    187183860001
    FOSTER, Daryl
    Yoo Building
    17 Hall Road
    NW8 9RF London
    Flat 45
    Segretario
    Yoo Building
    17 Hall Road
    NW8 9RF London
    Flat 45
    British43291390002
    KERR, Darren Mark, Mr.
    Christchurch Crescent
    WD7 8AU Radlett
    20a
    Hertfordshire
    Segretario
    Christchurch Crescent
    WD7 8AU Radlett
    20a
    Hertfordshire
    British140334370001
    PIELSTICKER, Charles Albert
    18 Hillhurst Blvd
    M4R 1K4 Toronto
    Ontario
    Canada
    Segretario
    18 Hillhurst Blvd
    M4R 1K4 Toronto
    Ontario
    Canada
    British82639410001
    PIELSTICKER, Scott William
    Flat 2
    39 St Luke`S Road
    W11 1DD London
    Segretario
    Flat 2
    39 St Luke`S Road
    W11 1DD London
    Canadian82639190003
    THOMAS, Howard
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    Segretario nominato
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British900000900001
    DORSEYLAW SECRETARIES LIMITED
    21 Wilson Street
    EC2M 2TD London
    Segretario
    21 Wilson Street
    EC2M 2TD London
    74615640001
    BAILLIE, Aubrey
    90 St. Leonards Ave.
    Toronto
    Ontario M4n 1k5
    Amministratore
    90 St. Leonards Ave.
    Toronto
    Ontario M4n 1k5
    Canadian109409880001
    BANKS, Joseph Robert
    2 Albert Place
    W8 5PD London
    Amministratore
    2 Albert Place
    W8 5PD London
    United KingdomAmerican97950200001
    BARBROOK, Matthew James
    William Road
    NW1 3ER London
    35-37
    England
    Amministratore
    William Road
    NW1 3ER London
    35-37
    England
    United KingdomBritish79274880001
    BUTCHER, Nicholas Terence
    Moorcroft Abinger Lane
    Abinger Common
    RH5 6HZ Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Moorcroft Abinger Lane
    Abinger Common
    RH5 6HZ Dorking
    Surrey
    EnglandBritish18037300001
    CUST, Gary William
    William Road
    NW1 3ER London
    35-37
    Amministratore
    William Road
    NW1 3ER London
    35-37
    EnglandBritish193071220001
    DARLING, Peter John
    Chandlers House
    Fenwick Place
    SW9 9NW London
    Amministratore
    Chandlers House
    Fenwick Place
    SW9 9NW London
    British91106210001
    FOSTER, Daryl
    Yoo Building
    17 Hall Road
    NW8 9RF London
    Flat 45
    United Kingdom
    Amministratore
    Yoo Building
    17 Hall Road
    NW8 9RF London
    Flat 45
    United Kingdom
    United KingdomBritish43291390003
    GRIFFIN, John Patrick
    23 The Avenue
    EN6 1EG Potters Bar
    Hertfordshire
    Amministratore
    23 The Avenue
    EN6 1EG Potters Bar
    Hertfordshire
    United KingdomBritish,Irish43291450001
    GRIFFIN, Kieran
    Bedwell Park, Cucumber Lane
    Essendon
    AL9 6GJ Hatfield
    Pulham House
    Hertfordshire
    Amministratore
    Bedwell Park, Cucumber Lane
    Essendon
    AL9 6GJ Hatfield
    Pulham House
    Hertfordshire
    United KingdomBritish82674390003
    JOHNSON, Donald Kenneth
    287 Oriole Parkway
    MSP 2H4 Toronto
    Ontario Ms9 2h4
    Canada
    Amministratore
    287 Oriole Parkway
    MSP 2H4 Toronto
    Ontario Ms9 2h4
    Canada
    Canadian109607400001
    KENNEDY, Andrew James
    2 Edgarley Terrace
    SW6 6QF London
    Amministratore
    2 Edgarley Terrace
    SW6 6QF London
    United KingdomCanadian101185570001
    L'HEUREUX, Willard John
    Eotvos U 47
    FOREIGN Budapest
    1067
    Hungary
    Amministratore
    Eotvos U 47
    FOREIGN Budapest
    1067
    Hungary
    Canadian91989750001
    PEARCE, Colin Leighton
    Lamorna 38 Denham Lane
    SL9 0ET Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Lamorna 38 Denham Lane
    SL9 0ET Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish169666820001
    PIELSTICKER, Scott William
    Flat 2
    39 St Luke`S Road
    W11 1DD London
    Amministratore
    Flat 2
    39 St Luke`S Road
    W11 1DD London
    Canadian82639190003
    SCHWARZ, Steve
    12 Measham Road
    LE65 2PF Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Amministratore
    12 Measham Road
    LE65 2PF Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    EnglandBritish109410140001
    TESTER, William Andrew Joseph
    4 Geary House
    Georges Road
    N7 8EZ London
    Amministratore delegato nominato
    4 Geary House
    Georges Road
    N7 8EZ London
    United KingdomBritish900000890001
    HELKON SK LIMITED
    74a Charlotte Street
    W1T 4QJ London
    Amministratore
    74a Charlotte Street
    W1T 4QJ London
    91989880001

    HOMEFLAG LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture without written instrument
    Creato il 02 mag 2007
    Consegnato il 22 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £300,000.00 due or to become due from the company to
    Brevi particolari
    All company assets.
    Persone aventi diritto
    • A. Baillie - Vyco LTD
    Transazioni
    • 22 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 gen 2007
    Consegnato il 07 feb 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £300,000 and all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over all assets of the company.
    Persone aventi diritto
    • A Baillie, Vyco LTD
    Transazioni
    • 07 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 nov 2006
    Consegnato il 29 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £250,000 due or to become due from the company to the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • A Baillie Vyco LTD Bmc Capital for Details of Further Chargees Please Refer to Form 395
    Transazioni
    • 29 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 giu 2006
    Consegnato il 26 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £500,000 and all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    Fixed charge over the chattels and equipment, book debts, goodwill and uncalled capital and floating charge, all the undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ausnoram Holdings, a Baillie, Pf Little for Further Names of the Mortgages or Persons Entitledto the Charge Please Refer to the Form 395
    Transazioni
    • 26 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture without written instrument
    Creato il 23 nov 2005
    Consegnato il 07 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,542,200 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating over all the assets of the company (including, for the avoidance of doubt, book debts).
    Persone aventi diritto
    • Scott Pielsticker, Ausnoram Holdings, a Baillie for Further Details of Names of the Mortgageesor Persons Entitled Please Refer to the Form 395
    Transazioni
    • 07 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture without written instrument
    Creato il 22 nov 2005
    Consegnato il 02 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £40,000 and us$80,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating over all the assets of the company (including, for the avoidance of doubt, book debts).
    Persone aventi diritto
    • Mr J Konken and Mr C Webster
    Transazioni
    • 02 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 29 giu 2004
    Consegnato il 05 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 05 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 nov 2003
    Consegnato il 19 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 19 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0