WHITE CORN LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWHITE CORN LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04542352
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WHITE CORN LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova WHITE CORN LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Rsm Restructuring Llp 25
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WHITE CORN LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    EWM (TOPCO) LIMITED07 nov 200607 nov 2006
    THE EDINBURGH WOOLLEN MILL (GROUP) LIMITED26 feb 200326 feb 2003
    EWM TOPCO LIMITED11 nov 200211 nov 2002
    INTERCEDE 1816 LIMITED23 set 200223 set 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di WHITE CORN LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al02 mar 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per WHITE CORN LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    15 pagineLIQ14

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 19 lug 2021

    LRESEX

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Fleet Place Farringdon London EC4M 7WS United Kingdom a C/O Rsm Restructuring Llp 25 Farringdon Street London EC4A 4AB in data 04 ago 2021

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività

    10 pagineLIQ02

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Cessazione della carica di Carmel Leigh come amministratore in data 30 giu 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di John Anthony Herring come amministratore in data 30 giu 2021

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 045423520009 in pieno

    1 pagineMR04

    Indirizzo della sede legale modificato da Global House 5 Castle Street Carlisle Cumbria CA3 8SY England a 1 Fleet Place Farringdon London EC4M 7WS in data 18 giu 2021

    1 pagineAD01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name14 giu 2021

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 10 giu 2021

    RES15

    Cessazione della carica di Daniel Philip Day come amministratore in data 27 apr 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Lauren Sarah Day come amministratore in data 27 apr 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Philip Edward Day come amministratore in data 27 apr 2021

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 mar 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di David Oliver Houston come amministratore in data 16 ott 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Daniel Philip Day come amministratore in data 15 set 2020

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr John Robert Jackson come amministratore in data 15 set 2020

    2 pagineAP01

    Iscrizione dell'ipoteca 045423520009, creata il 24 ago 2020

    19 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 045423520008, creata il 17 mar 2020

    26 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 mar 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio consolidato redatto al 02 mar 2019

    68 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Miss Lauren Sarah Day il 01 nov 2018

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Miss Lauren Sarah Day il 24 giu 2016

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Robert Neil Edmonds come amministratore in data 07 giu 2019

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di WHITE CORN LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CARRUTHERS, June
    Burnside House Maxwell Place
    DG13 0DY Langholm
    Dumfriesshire
    Segretario
    Burnside House Maxwell Place
    DG13 0DY Langholm
    Dumfriesshire
    British50519150001
    JACKSON, John Robert
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    C/O Rsm Restructuring Llp 25
    Amministratore
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    C/O Rsm Restructuring Llp 25
    WalesBritish274337670001
    SIMPSON, Stephen Robert
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    C/O Rsm Restructuring Llp 25
    Amministratore
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    C/O Rsm Restructuring Llp 25
    United KingdomBritish166820010002
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Segretario nominato
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900004680001
    DAY, Daniel Philip
    5 Castle Street
    CA3 8SY Carlisle
    Global House
    Cumbria
    England
    Amministratore
    5 Castle Street
    CA3 8SY Carlisle
    Global House
    Cumbria
    England
    WalesBritish226073480001
    DAY, Lauren Sarah
    5 Castle Street
    CA3 8SY Carlisle
    Global House
    Cumbria
    England
    Amministratore
    5 Castle Street
    CA3 8SY Carlisle
    Global House
    Cumbria
    England
    WalesBritish209763710001
    DAY, Philip Edward
    5 Castle Street
    CA3 8SY Carlisle
    Global House
    Cumbria
    England
    Amministratore
    5 Castle Street
    CA3 8SY Carlisle
    Global House
    Cumbria
    England
    SwitzerlandBritish46992150038
    EDMONDS, Robert Neil
    5 Castle Street
    CA3 8SY Carlisle
    Global House
    Cumbria
    England
    Amministratore
    5 Castle Street
    CA3 8SY Carlisle
    Global House
    Cumbria
    England
    EnglandBritish206608930001
    GERRARD, Paul John
    Beech House
    No 1 The Woodlands
    CA8 9HZ Hayton
    Cumbria
    Amministratore
    Beech House
    No 1 The Woodlands
    CA8 9HZ Hayton
    Cumbria
    UkBritish159694080001
    HERRING, John Anthony
    Fleet Place
    Farringdon
    EC4M 7WS London
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Fleet Place
    Farringdon
    EC4M 7WS London
    1
    United Kingdom
    EnglandBritish151442360001
    HERRING, John Anthony
    Borough Farm
    GU8 5JY Godalming
    Surrey
    Amministratore
    Borough Farm
    GU8 5JY Godalming
    Surrey
    EnglandBritish151442360001
    HODKINSON, James Clifford
    29b Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    Amministratore
    29b Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    EnglandBritish606430001
    HOUSTON, David Oliver
    5 Castle Street
    CA3 8SY Carlisle
    Global House
    Cumbria
    England
    Amministratore
    5 Castle Street
    CA3 8SY Carlisle
    Global House
    Cumbria
    England
    ScotlandBritish75910100005
    HOUSTON, David Oliver
    72 Royal Gardens, Sovereigns Gate
    Bothwell
    G71 8SY Glasgow
    Amministratore
    72 Royal Gardens, Sovereigns Gate
    Bothwell
    G71 8SY Glasgow
    ScotlandBritish75910100005
    LEE, Kristian Brian
    Waverley Mills
    DG13 0EB Langholm
    The Edinburgh Woollen Mill Ltd
    Dumfriesshire
    Scotland
    Amministratore
    Waverley Mills
    DG13 0EB Langholm
    The Edinburgh Woollen Mill Ltd
    Dumfriesshire
    Scotland
    EnglandBritish160887440001
    LEIGH, Carmel
    Fleet Place
    Farringdon
    EC4M 7WS London
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Fleet Place
    Farringdon
    EC4M 7WS London
    1
    United Kingdom
    EnglandBritish104858030003
    LIGHT, David Arthur
    Lightcroft House Caldy Road
    Caldy
    CH48 1LW Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    Lightcroft House Caldy Road
    Caldy
    CH48 1LW Wirral
    Merseyside
    United KingdomBritish45750750003
    WHITAKER, Alec
    Batt House
    Crosby On Eden
    CA6 4RA Carlisle
    Amministratore
    Batt House
    Crosby On Eden
    CA6 4RA Carlisle
    EnglandBritish60593850003
    MITRE DIRECTORS LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Amministratore delegato nominato
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900024450001

    Chi sono le persone con controllo significativo di WHITE CORN LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    DG13 0EB Langholm
    Waverley Mills
    Dumfriesshire
    Scotland
    06 apr 2016
    DG13 0EB Langholm
    Waverley Mills
    Dumfriesshire
    Scotland
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleScottish Law
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazioneSc307281
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) possiedono, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) detengono, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    WHITE CORN LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 24 ago 2020
    Consegnato il 26 ago 2020
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Not applicable.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC
    Transazioni
    • 26 ago 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 05 lug 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 17 mar 2020
    Consegnato il 17 mar 2020
    In corso
    Breve descrizione
    The chargor charges by way of fixed charge any right, title or interest which it has now or may subsequently acquire to or in any other land, investments, equipment, intellectual property, goodwill, uncalled capital, authorisations, insurances it holds in relation to any security asset.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Edinburgh Woollen Mill (Group) Limited
    Transazioni
    • 17 mar 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 11 mar 2019
    Consegnato il 14 mar 2019
    In corso
    Breve descrizione
    Not applicable.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Agent for the Secured Parties
    Transazioni
    • 14 mar 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Debenture
    Creato il 25 lug 2011
    Consegnato il 29 lug 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) and each bilateral lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    (For details of all trade marks charged, please refer to the MG01 document) fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (Security Trustee)
    Transazioni
    • 29 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 29 mar 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating security document
    Creato il 31 ott 2006
    Consegnato il 08 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as the edinburgh wollen mill (group) limited to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transazioni
    • 08 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating security document
    Creato il 25 feb 2005
    Consegnato il 04 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transazioni
    • 04 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Insurance assignment
    Creato il 14 mag 2003
    Consegnato il 16 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of its right title and interest present and future in and to the policies and all monies including bonuses accrued. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland, in Its Capacity as Security Trustee for Thesecurity Beneficiaries (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 16 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Insurance assignment
    Creato il 15 apr 2003
    Consegnato il 19 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The policies being 5 year bassett life policy number ASL19086 in the name of philip day for the sum of £1,000,000 commencement date 01/03/03, 5 year legal & general policy number 0088395306 in the name of alec whitaker for the sum of £250,000 commencement date 01/03/03. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as Security Trustee for Thesecurity Beneficiaries
    Transazioni
    • 19 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 nov 2002
    Consegnato il 20 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 20 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    WHITE CORN LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    19 lug 2021Inizio della liquidazione
    08 apr 2022Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Gordon Thomson
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Praticante
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Damian Webb
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Praticante
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0