D1 OILS TRADING LIMITED
Panoramica
Nome della società | D1 OILS TRADING LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 04645184 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di D1 OILS TRADING LIMITED?
- Commercio all'ingrosso di altri combustibili e prodotti connessi (46719) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
Dove si trova D1 OILS TRADING LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Unit C, 2nd Floor 16 Dufferin Street EC1Y 8PD London England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di D1 OILS TRADING LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
D1 OILS LTD | 22 gen 2003 | 22 gen 2003 |
Quali sono gli ultimi bilanci di D1 OILS TRADING LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per D1 OILS TRADING LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2021 | 21 pagine | AA | ||||||||||||||
Stato del capitale al 29 mar 2022
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 pagine | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 2 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 giu 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2020 | 21 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2019 | 20 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 giu 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 giu 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2018 | 20 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 giu 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Modifica dei dettagli di Starsupply Renewables Sa come persona con controllo significativo il 04 dic 2017 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 19 pagine | AA | ||||||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 giu 2017 al 31 dic 2017 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||||||
Notifica di Starsupply Renewables Sa come persona con controllo significativo il 12 set 2017 | 1 pagine | PSC02 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 mag 2017 con aggiornamenti | 8 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Unit C, 2nd Floor Unit C, 2nd Floor 16 Dufferin Street London EC1Y 8PD England a Unit C, 2nd Floor 16 Dufferin Street London EC1Y 8PD in data 09 mag 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 16 16 Dufferin Street London EC1Y 8PD Great Britain a Unit C, 2nd Floor Unit C, 2nd Floor 16 Dufferin Street London EC1Y 8PD in data 05 mag 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 55 Gower Street London WC1E 6HQ a 16 16 Dufferin Street London EC1Y 8PD in data 06 apr 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Gordon Richard Tainton come amministratore in data 31 mar 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Russel William Thomson come amministratore in data 20 mar 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di D1 OILS TRADING LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMANUELSSON, Per Joachim | Amministratore | Route De Chanivaz Buchillon 4b Vaud Switzerland | Switzerland | Swedish | Chief Operating Officer | 208033180001 | ||||
MCGEENEY, Kevin Connal | Amministratore | Chemin De La Croix Le Mont Sur Lausanne 24 Vaud Switzerland | Switzerland | Irish | Chief Executive Officer | 199915660001 | ||||
DEANE, Timothy William Melford | Segretario | 22 Gleeson Mews KT15 2BG Addlestone Surrey | British | Company Secretary | 118833080001 | |||||
EDWARDS, Marie Elizabeth | Segretario | 1 Woodlands AL5 3BY Harpenden Hertfordshire | British | 122911720001 | ||||||
GUDGEON, Richard Keith | Segretario | 26 Bernica Grove TS17 0FR Ingleby Barwick Cleveland | British | 110379200001 | ||||||
HAMLIN, Neville Peter | Segretario | 327 Salters Road NE3 4HN Gosforth Newcastle Upon Tyne | British | Accountant | 87853750001 | |||||
MANNIS, Elliott Michael | Segretario | 63 Station Road PE28 0PE Catworth Hunters Drift Huntingdon Uk | British | Finance Director | 139879240001 | |||||
STEWART, Olwen | Segretario | 42 Ambleside Avenue TS10 4JW Redcar Cleveland | British | 83277140001 | ||||||
WORRALL, Alex David | Segretario | Low Walworth Hall Walworth DL2 2NA Darlington County Durham | British | Accountant | 44246150001 | |||||
@UKPLC CLIENT SECRETARY LTD | Segretario nominato | 5, Jupiter House Calleva Park, Aldermaston RG7 8NN Reading | 900025730001 | |||||||
PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Segretario | 1 Park Row LS1 5AB Leeds West Yorkshire | 76579530001 | |||||||
CAMPBELL, William Peter | Amministratore | Norwood House 76 Abbey Road DL3 8NN Darlington County Durham | United Kingdom | British | Director | 100508560001 | ||||
DAVIS, Stephen John | Amministratore | Park House Guisborough Lane, Skelton TS12 2HL Saltburn By The Sea Cleveland | United Kingdom | British | Director | 47053590002 | ||||
DOUTY, Stephen Peter | Amministratore | Turftide Icehouse Wood RH8 9DN Oxted Surrey | England | British | Regional Director | 68353760001 | ||||
GOOD, Benjamin Richard | Amministratore | Granhams Road CB22 5JX Great Shelford Shepherds Cottage 26 Cambridgeshire | United Kingdom | British | Finance And Commercial Director | 130903800001 | ||||
GRAYSTON, Andrew John | Amministratore | Mill House Churchtown PR3 0HQ Preston Lancashire | United Kingdom | British | Director | 80187340001 | ||||
GUDGEON, Richard Keith | Amministratore | 26 Bernica Grove TS17 0FR Ingleby Barwick Cleveland | England | British | Acting Cfo/Cs | 110379200001 | ||||
HAMLIN, Neville Peter | Amministratore | 327 Salters Road NE3 4HN Gosforth Newcastle Upon Tyne | British | Accountant | 87853750001 | |||||
JARVIS, Martin John | Amministratore | The Street Ulcombe ME17 1DP Maidstone Candle Cottage Kent United Kingdom | England | British | Operations And Supply Chain Management | 124386950001 | ||||
MANNIS, Elliott Michael | Amministratore | 63 Station Road PE28 0PE Catworth Hunters Drift Huntingdon Uk | United Kingdom | British | Finance Director | 139879240001 | ||||
MYERSON, Nicholas Paul | Amministratore | 28 Chemin De La Tinte 1936 Verbier Apartment 17 Switzerland | Switzerland | South African | Commodities Analyst And Director | 165887760003 | ||||
QUINN, Mark Lockhart Muir | Amministratore | 1 St Botolphs Court St Botolphs Road TN13 3AS Sevenoaks Kent | British | Business Development | 79406570004 | |||||
RUDOFSKY, Steven Zachariah | Amministratore | Ranulf Road NW2 2BT London 11 United Kingdom | United Kingdom | British | Lawyer And Director | 53323380002 | ||||
SONNENBURG, David Stanley | Amministratore | 10486 Fourwayseast 2056 Johannesburg 2056 South Africa | South African | Director | 97469070001 | |||||
TAINTON, Gordon Richard | Amministratore | Ch-1162 1162 St Prex Ch. De Senaugin 11 Switzerland | Switzerland | Swiss | Director | 183330460002 | ||||
TAWNEY, Christopher | Amministratore | The White House Easton Royal SN9 5LY Pewsey Wiltshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 73572700001 | ||||
THOMSON, Russel William | Amministratore | Gower Street WC1E 6HQ London 55 | Australia | Australian | Director | 191231330001 | ||||
WATKIN, Karl Eric | Amministratore | Ghylleheugh Longhorsley NE65 8RF Morpeth Northumberland | United Kingdom | British | Director | 36688560001 | ||||
WOOD, Philip Kenneth | Amministratore | 4 Middlings Wood Kippington Road TN13 2LF Sevenoaks Kent | England | British | Company Director | 8259380001 | ||||
WORRALL, Alex David | Amministratore | Low Walworth Hall Walworth DL2 2NA Darlington County Durham | United Kingdom | British | Accountant | 44246150001 | ||||
@UKPLC CLIENT DIRECTOR LTD | Amministratore delegato nominato | 5, Jupiter House Calleva Park, Aldermaston RG7 8NN Reading | 900025720001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di D1 OILS TRADING LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scb Brokers Sa | 12 set 2017 | Avenue De Perdtemps Nyon 17 Switzerland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Scb & Associates Limited | 28 mar 2017 | Dufferin Street EC1Y 8PD London 16 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Neos Resources Plc | 06 apr 2016 | Gower Street WC1E 6HQ London 55 United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Mr Kevin Connal Mcgeeney | 06 apr 2016 | 16 Dufferin Street EC1Y 8PD London Unit C, 2nd Floor England | No | ||||||||||
Nazionalità: Irish Paese di residenza: Switzerland | |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Mr Per Joachim Emanuelsson | 06 apr 2016 | 16 Dufferin Street EC1Y 8PD London Unit C, 2nd Floor England | No | ||||||||||
Nazionalità: Swedish Paese di residenza: Switzerland | |||||||||||||
Natura del controllo
|
D1 OILS TRADING LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Floating charge | Creato il 10 mar 2010 Consegnato il 19 mar 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Floating charge over the undertaking and all property and assets present and future. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 23 dic 2005 Consegnato il 05 gen 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a 1, 2 & 4 forty foot road, middlesbrough t/no CE87957; CE92776; CE116227 and CE88429. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 20 dic 2005 Consegnato il 04 gen 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0