FREEHEART LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFREEHEART LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04660995
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FREEHEART LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova FREEHEART LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Gladstone Place
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St Albans
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di FREEHEART LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per FREEHEART LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 feb 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr William Bahlsen Bannister il 06 dic 2018

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr William Bahlsen Bannister il 06 dic 2018

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Building 2 Abbey View Everard Close St Albans Hertfordshire AL1 2QU United Kingdom a Gladstone Place 36-38 Upper Marlborough Road St Albans Hertfordshire AL1 3UU in data 10 lug 2018

    1 pagineAD01

    Modifica dei dettagli di Thames Rico Service Stations Limited come persona con controllo significativo il 02 lug 2018

    2 paginePSC05

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2017

    19 pagineAA

    legacy

    52 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 feb 2018 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    legacy

    3 pagineSH20

    Stato del capitale al 24 nov 2017

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    3 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduction of share premium account 24/11/2017
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2016

    20 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 046609950011, creata il 19 giu 2017

    116 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 feb 2017 con aggiornamenti

    7 pagineCS01

    Iscrizione dell'ipoteca 046609950010, creata il 22 dic 2016

    101 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 046609950009, creata il 07 nov 2016

    98 pagineMR01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2015

    22 pagineAA

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 1 Park Row Leeds LS1 5AB

    1 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Park Row Leeds LS1 5AB United Kingdom a Building 2 Abbey View Everard Close St Albans Hertfordshire AL1 2QU in data 01 lug 2016

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di FREEHEART LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Segretario
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione02318923
    76579530001
    ALLAN, Timothy Edward Douglas
    Drumburn Farm
    FK14 7JW Muckhart
    Clackmannanshire
    Amministratore
    Drumburn Farm
    FK14 7JW Muckhart
    Clackmannanshire
    United KingdomBritish108784910001
    BANNISTER, William Bahlsen
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish54266450004
    BIGGART, Thomas Mckenzie
    By Dollar
    FK14 7PL Dollar
    Castleton Farm
    Clackmannanshire
    Scotland
    Amministratore
    By Dollar
    FK14 7PL Dollar
    Castleton Farm
    Clackmannanshire
    Scotland
    ScotlandBritish82724480005
    GILMORE, Lisa Joanne
    La Combe A Ginon
    Chanaz 73310
    Savoie
    France
    Segretario
    La Combe A Ginon
    Chanaz 73310
    Savoie
    France
    British93998550001
    PAMELY, Philip
    11 Pages Croft
    RG40 2HN Wokingham
    Berkshire
    Segretario
    11 Pages Croft
    RG40 2HN Wokingham
    Berkshire
    British36775580002
    FORBES SECRETARIES LIMITED
    New City House 71 Rivington Street
    EC2A 3AY London
    Segretario
    New City House 71 Rivington Street
    EC2A 3AY London
    67773790001
    INTERVECT INC
    2711 Centerville Road
    Suite 400
    Wilmington
    Delaware De19808
    U S A
    Segretario
    2711 Centerville Road
    Suite 400
    Wilmington
    Delaware De19808
    U S A
    88446840001
    DAWSON, Allan George
    Nether Brotherstone House
    EH38 5YS Heriot
    Amministratore
    Nether Brotherstone House
    EH38 5YS Heriot
    ScotlandBritish93178680001
    FORSYTH, Angus Alpin
    Waughton House
    EH40 3DY East Linton
    East Lothian
    Amministratore
    Waughton House
    EH40 3DY East Linton
    East Lothian
    ScotlandBritish81456550001
    GARRY, Steven Bernard
    Lawhill
    FK14 7PN Dollar
    Lawhill House
    Clackmannanshire
    Amministratore
    Lawhill
    FK14 7PN Dollar
    Lawhill House
    Clackmannanshire
    United KingdomIrish132867110001
    GILMORE, Lisa Joanne
    La Combe A Ginon
    Chanaz 73310
    Savoie
    France
    Amministratore
    La Combe A Ginon
    Chanaz 73310
    Savoie
    France
    FranceBritish93998550001
    HAACKE, Ronald John
    45 Shepherds Way
    WD3 7NW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    45 Shepherds Way
    WD3 7NW Rickmansworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritish26165300002
    HOOKHAM, Peter
    St Ronan's Drive
    KY13 8AF Perth & Kinross
    St Ronan's
    Amministratore
    St Ronan's Drive
    KY13 8AF Perth & Kinross
    St Ronan's
    UkBritish65880590006
    WOODS, Dennis Laurence
    Birch Hall
    Church Road
    GU20 6BN Windlesham
    Surrey
    Amministratore
    Birch Hall
    Church Road
    GU20 6BN Windlesham
    Surrey
    EnglandEnglish19765000002
    FORBES NOMINEES LIMITED
    New City House 71 Rivington Street
    EC2A 3AY London
    Amministratore
    New City House 71 Rivington Street
    EC2A 3AY London
    67773780001
    INTERVECT INC
    2711 Centerville Road
    Suite 400
    Wilmington
    Delaware De19808
    U S A
    Amministratore
    2711 Centerville Road
    Suite 400
    Wilmington
    Delaware De19808
    U S A
    88446840001

    Chi sono le persone con controllo significativo di FREEHEART LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione00477257
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    FREEHEART LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 19 giu 2017
    Consegnato il 23 giu 2017
    In corso
    Breve descrizione
    Bearwood service station, sandon road, bearwood, west midlands, B66 4AB (WM454249); overend service station, congreaves road, cradley heath, warley, birmingham, B64 7EA (WM305182); and tipton service station, bloomfield road, tipton, west midlands, DY4 9EB (SF112790).
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bnp Paribas, London Branch
    Transazioni
    • 23 giu 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 22 dic 2016
    Consegnato il 23 dic 2016
    In corso
    Breve descrizione
    Land at sandon road, bearwood, west midlands, B66 4AB - bearwood service station, sandon road, bearwood, birmingham, B66 4AB; land at congreaves road, cradley heath, warley, birmingham, B64 7EA - overend service station, congreaves road, cradley heath B64 7EA; land at bloomfield road, tipton, west midlands, DY4 9EB - tipton service station, bloomfield road, tipton DY4 9EB.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bnp Paribas, London Branch
    Transazioni
    • 23 dic 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 07 nov 2016
    Consegnato il 16 nov 2016
    In corso
    Breve descrizione
    Land at sandon road, bearwood, west midlands, B66 4AB - bearwood service station, sandon road, bearwood, birmingham, B66 4AB; land at congreaves road, cradley heath, warley, birmingham, B64 7EA - overend service station, congreaves road, cradley heath B64 7EA; land at hagley road, old swinford, stourbridge, DY8 2JJ - stourbridge service station, hagley road, stourbridge DY8 2JL; land at bloomfield road, tipton, west midlands, DY4 9EB - tipton service station, bloomfield road, tipton DY4 9EB.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bnp Paribas, London Branch
    Transazioni
    • 16 nov 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 03 set 2015
    Consegnato il 04 set 2015
    In corso
    Breve descrizione
    Sandon road bearwood west midlands and bearwood service station sandon road bearwood birmingham t/no WM454249.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bnp Paribas, London Branch as Security Agent (As Trustee for the Secured Creditors)
    Transazioni
    • 04 set 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 12 lug 2013
    Consegnato il 23 lug 2013
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Security Trustee for Each of the Secured Parties (As Defined in the Instrument Evidencing the Charge Accompanying This Form MR01)
    Transazioni
    • 23 lug 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 25 lug 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 12 lug 2013
    Consegnato il 23 lug 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    All the company’s estates or interests in any real property (as defined in the instrument. Evidencing the charge accompanying this form MR01) now or hereafter belonging to. It, including:. (One) the freehold interest in the property known as bearwood service station, sandon road, birmingham registered in the land registry under title number WM454249;. (Two) the freehold interest in the property known as overend service station, corngreaves road, cradley heath, west midlands, B64 7EA registered in the land registry under title number WM305182;. (Three) the freehold interest in the property known as overend service station, hagley road, stourbridge, DY8 2JJ registered in the land registry under title number WM377700; and. (Four) the freehold interest in the property known as tipton service station, bloomfield road, tipton, DY4 9EB registered in the land registry under title number SF112790.. All the company’s rights under any agreement relating to the purchase of any. Freehold or leasehold property.. All the company's rights under any occupational lease, licence or other right of. Occupation.. All its right, title and interest in any intellectual property rights belonging to it or. (To the extent of its interest) in which it has an interest.. Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Security Trustee for Each of the Secured Parties (As Defined in the Instrument Evidencing the Charge Accompanying This Form MR01)
    Transazioni
    • 23 lug 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 25 lug 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 29 ott 2008
    Consegnato il 01 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a overend service station, corngreaves road, cradley heath, west midlands t/no WM305182, bearwood service station, sandon road, birmingham t/no WM454249, stourbridge (carls) service station, hagley road, stourbridge t/no WM377700, for details of further properties charged please refer to form 395 by way of fixed charge, all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 01 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 29 ott 2008
    Consegnato il 01 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 01 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 31 gen 2008
    Acquisito il 16 set 2008
    Consegnato il 30 set 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Sandon road service station sandon road bearwood smethwick birmingham t/no WM454249 overend service station congreaves road cradley heath warley west midlands t/no WM305182 oldswinford service station 127 hagley road oldwinford stourbridge west midlands t/no WM377700 and bloomfield service station bloomfield road tipton west midlands t/no SF112790.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 set 2008Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 11 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 20 mar 2003
    Acquisito il 16 set 2008
    Consegnato il 30 set 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Sandon road service station sandon road bearwood birmingham t/no WM454249 overend service station congreaves road cradley heath warley west midlands t/no WM305182 oldswinford service station hagley road oldswinford stourbridge west midlands t/no WM377700 and bloomfield service station bloomfield road tipton west midlands t/no SF112790.
    Persone aventi diritto
    • Texaco Limited
    Transazioni
    • 30 set 2008Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 11 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 20 mar 2003
    Consegnato il 29 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Sandown road service station sandon road bearwood birmingham title number WM454249, overend service station congreaves road cradley heath warley west midlands title number WM305182, oldswinford service station hagley road oldswinford stourbridge title number WM377700. For further details of property charged please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Texaco Limited
    Transazioni
    • 29 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0