THAME ENERGY SYSTEMS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | THAME ENERGY SYSTEMS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04886028 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di THAME ENERGY SYSTEMS LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova THAME ENERGY SYSTEMS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Sterling Thermal Technology South Building Brunel Road Rabans Lane Industrial Area HP19 8TD Aylesbury Buckinghamshire England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di THAME ENERGY SYSTEMS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| APPLIED COOLING TECHNOLOGY LIMITED | 03 set 2003 | 03 set 2003 |
Quali sono gli ultimi bilanci di THAME ENERGY SYSTEMS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per THAME ENERGY SYSTEMS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 lug 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 26 apr 2018
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Michael Paver come amministratore in data 31 mar 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Stephen David Williams come amministratore in data 22 mar 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Graham John Roberts come amministratore in data 21 feb 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Sandra Joy Saganowski come amministratore in data 21 feb 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Kathryn Elizabeth Tackley come segretario in data 31 gen 2018 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael Paver come segretario in data 31 gen 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Sterling Industries Plc Sterling House Brunel Road Aylesbury Buckinghamshire HP19 8SS a Sterling Thermal Technology South Building Brunel Road Rabans Lane Industrial Area Aylesbury Buckinghamshire HP19 8TD in data 03 ago 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 lug 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 lug 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Sandra Joy Saganowski come amministratore in data 07 gen 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Gordon Hussey come amministratore in data 07 gen 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Gordon Hussey come amministratore in data 09 dic 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher Robert Armitage come amministratore in data 30 ott 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di THAME ENERGY SYSTEMS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TACKLEY, Kathryn Elizabeth | Segretario | Brunel Road Rabans Lane Industrial Area HP19 8TD Aylesbury Sterling Thermal Technology South Building Buckinghamshire England | 242672370001 | |||||||
| ROBERTS, Graham John | Amministratore | Brunel Road Rabans Lane Industrial Area HP19 8TD Aylesbury Sterling Thermal Technology South Building Buckinghamshire England | England | British | 81929310001 | |||||
| WILLIAMS, Stephen David | Amministratore | Brunel Road Rabans Lane Industrial Area HP19 8TD Aylesbury Sterling Thermal Technology South Building Buckinghamshire England | England | British | 244487000001 | |||||
| BLUNN, David Howard | Segretario | c/o Sterling Industries Plc Brunel Road HP19 8SS Aylesbury Sterling House Buckinghamshire England | 168883470001 | |||||||
| PAVER, Michael | Segretario | Brunel Road Rabans Lane Industrial Area HP19 8TD Aylesbury Sterling Thermal Technology South Building Buckinghamshire England | 182799600001 | |||||||
| PIERCE, David Bland | Segretario | 24 Dorsington Close Hatton Park CV35 7TH Warwick Warwickshire | British | 6199660002 | ||||||
| PIERCE, Gerrard Mark | Segretario | 6 Monks Field Close Templars Grange CV4 9XW Coventry Warwickshire England | British | 68292680001 | ||||||
| SAGANOWSKI, Sandra Joy | Segretario | Brunel Road Rabans Lane HP19 8TD Aylesbury Applied Cooling Technology Limited Buckinghamshire | British | 161003960001 | ||||||
| THOMAS, Howard | Segretario nominato | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | 900000900001 | ||||||
| ARMITAGE, Christopher Robert | Amministratore | c/o Sterling Industries Plc Brunel Road HP19 8SS Aylesbury Sterling House Buckinghamshire England | United Kingdom | British | 62637840002 | |||||
| BLUNN, David Howard | Amministratore | c/o Sterling Industries Plc Brunel Road HP19 8SS Aylesbury Sterling House Buckinghamshire England | England | British | 160982330001 | |||||
| HUSSEY, David Gordon | Amministratore | c/o Sterling Industries Plc Brunel Road HP19 8SS Aylesbury Sterling House Buckinghamshire | England | British | 131639570002 | |||||
| MICHALUK, Peter Gregory | Amministratore | Brunel Road Rabans Lane HP19 8TD Aylesbury Applied Cooling Technology Limited Buckinghamshire | United Kingdom | British | 67772880002 | |||||
| PAVER, Michael | Amministratore | Brunel Road Rabans Lane Industrial Area HP19 8TD Aylesbury Sterling Thermal Technology South Building Buckinghamshire England | United Kingdom | British | 10035580002 | |||||
| PIERCE, David Bland | Amministratore | 24 Dorsington Close Hatton Park CV35 7TH Warwick Warwickshire | England | British | 6199660002 | |||||
| PIERCE, Lynnda | Amministratore | 24 Dorsington Close Hatton Park CV35 7TH Warwick Warwickshire | United Kingdom | British | 6199670002 | |||||
| SAGANOWSKI, Sandra Joy | Amministratore | Brunel Road Rabans Lane Industrial Area HP19 8TD Aylesbury Sterling Thermal Technology South Building Buckinghamshire England | England | British | 102005730001 | |||||
| SAGANOWSKI, Sandra Joy | Amministratore | Brunel Road Rabans Lane HP19 8TD Aylesbury Applied Cooling Technology Limited Buckinghamshire | England | British | 102005730001 | |||||
| TESTER, William Andrew Joseph | Amministratore delegato nominato | 4 Geary House Georges Road N7 8EZ London | United Kingdom | British | 900000890001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di THAME ENERGY SYSTEMS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sterling Thermal Technology Limited | 06 apr 2016 | Brunel Road Aylesbury Sterling Thermal Technology United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
THAME ENERGY SYSTEMS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental chattel mortgage | Creato il 21 ott 2005 Consegnato il 25 ott 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All right title and interest in the assets being 1 x elfinmaster lx double ended 5KN fin making and swaging machine s/no LDR6KSHP, 1 x elfinmaster ml 5KN fin making and swaging machine s/no LSR3KRSHA, 1 x elfinmaster jm cnc control unit s/no LDR12KDHP,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 17 set 2003 Consegnato il 23 set 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £263,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee and a further advance of £52,000.00 | |
Brevi particolari Floating charge the whole of the chargor's undertaking and all its property, assets and rights, present and future. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0