CHADWICK HOMES LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCHADWICK HOMES LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04969446
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CHADWICK HOMES LTD?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova CHADWICK HOMES LTD?

    Indirizzo della sede legale
    Greg`S Building 1
    Booth Street
    M2 4DU Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CHADWICK HOMES LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    INVESTORS IN CARE LIMITED19 nov 200319 nov 2003

    Quali sono gli ultimi bilanci di CHADWICK HOMES LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 nov 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per CHADWICK HOMES LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    20 pagineLIQ14
    YC8J6L0Q

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 19 ott 2022

    14 pagineLIQ03
    YBJBVKDE

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 19 ott 2021

    15 pagineLIQ03
    AAJF3R5E

    Indirizzo della sede legale modificato da 45 City Road Chester CH1 3AE a Greg`S Building 1 Booth Street Manchester M2 4DU in data 23 nov 2020

    2 pagineAD01
    A9I3RIQX

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600
    A9GMH9OR

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 20 ott 2020

    LRESEX

    Dichiarazione delle attività

    10 pagineLIQ02
    A9GMH9P7

    Cessazione della carica di Deborah Grace Chadwick come amministratore in data 30 giu 2020

    1 pagineTM01
    X99P2HS0

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 nov 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    X8KPLDU3

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 nov 2018

    12 pagineAA
    X8CVL5J7

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 nov 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    X7J6IIBN

    Notifica di Deborah Grace Chadwick come persona con controllo significativo il 20 nov 2018

    2 paginePSC01
    X7J6I80B

    Notifica di Jonathan Peter Chadwick come persona con controllo significativo il 20 nov 2018

    2 paginePSC01
    X7J6I6Q8

    Cessazione di Jonathan Peter Chadwick come persona con controllo significativo il 20 nov 2018

    1 paginePSC07
    X7J3XG7T

    Cessazione di Deborah Grace Chadwick come persona con controllo significativo il 20 nov 2018

    1 paginePSC07
    X7J3XFWJ

    Iscrizione dell'ipoteca 049694460017, creata il 09 nov 2018

    22 pagineMR01
    X7IMN69K

    Iscrizione dell'ipoteca 049694460018, creata il 09 nov 2018

    23 pagineMR01
    X7IMN6P6

    Soddisfazione dell'onere 049694460015 in pieno

    4 pagineMR04
    A7HRRKA8

    Soddisfazione dell'onere 049694460016 in pieno

    4 pagineMR04
    A7HRRKBS

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 nov 2017

    13 pagineAA
    X7DDSB7U

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 nov 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    X6KPA71M

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    4 pagineMR04
    A66R76WZ

    Iscrizione dell'ipoteca 049694460015, creata il 03 mag 2017

    43 pagineMR01
    X661TITM

    Iscrizione dell'ipoteca 049694460016, creata il 03 mag 2017

    35 pagineMR01
    X661TIXD

    Chi sono gli amministratori di CHADWICK HOMES LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CHADWICK, Jonathan Peter
    Reflections
    Fir Tree Lane
    RH20 2RA West Chiltington
    West Sussex
    Segretario
    Reflections
    Fir Tree Lane
    RH20 2RA West Chiltington
    West Sussex
    BritishDirector94561910001
    CHADWICK, Jonathan Peter
    Reflections
    Fir Tree Lane
    RH20 2RA West Chiltington
    West Sussex
    Amministratore
    Reflections
    Fir Tree Lane
    RH20 2RA West Chiltington
    West Sussex
    United KingdomBritishDirector94561910001
    THOMAS, Howard
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    Segretario nominato
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British900000900001
    CHADWICK, Deborah Grace
    Reflections
    Fir Tree Lane
    RH20 2RA West Chiltington
    West Sussex
    Amministratore
    Reflections
    Fir Tree Lane
    RH20 2RA West Chiltington
    West Sussex
    United KingdomBritishDirector94561930001
    TESTER, William Andrew Joseph
    4 Geary House
    Georges Road
    N7 8EZ London
    Amministratore delegato nominato
    4 Geary House
    Georges Road
    N7 8EZ London
    United KingdomBritish900000890001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CHADWICK HOMES LTD?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mrs Deborah Grace Chadwick
    Fir Tree Lane
    West Chiltington
    RH20 2RA Pulborough
    Relections
    England
    20 nov 2018
    Fir Tree Lane
    West Chiltington
    RH20 2RA Pulborough
    Relections
    England
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    Mr Jonathan Peter Chadwick
    Fir Tree Lane
    West Chiltington
    RH20 2RA Pulborough
    Relections
    England
    20 nov 2018
    Fir Tree Lane
    West Chiltington
    RH20 2RA Pulborough
    Relections
    England
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    Mr Jonathan Peter Chadwick
    City Road
    CH1 3AE Chester
    45
    06 apr 2016
    City Road
    CH1 3AE Chester
    45
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    Mrs Deborah Grace Chadwick
    City Road
    CH1 3AE Chester
    45
    06 apr 2016
    City Road
    CH1 3AE Chester
    45
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.

    CHADWICK HOMES LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 09 nov 2018
    Consegnato il 13 nov 2018
    In corso
    Breve descrizione
    As a continuing security for the payment and discharge of the secured liabilities, the mortgagor with full title guarantee charges to the lender a first legal mortgage over land at 1 ashurst avenue, saltdean, brighton, BN2 8DR, as registered under title ESX237267 and a first fixed charge. For more details please refer to the instrument.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Assetz Capital Trust Company Limited
    Transazioni
    • 13 nov 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 09 nov 2018
    Consegnato il 13 nov 2018
    In corso
    Breve descrizione
    As a continuing security for the payment of the secured obligations, by way of first legal mortgage all properties owned by the company; and a fixed charge. For more details please refer to the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Assetz Capital Trust Company Limited
    Transazioni
    • 13 nov 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 03 mag 2017
    Consegnato il 09 mag 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    1 orion houses, bruce avenue, worthing, BN11 5JN title no. WSX377567; 23 st andrews road, worthing, BN13 1HW title no. WSX169853.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Spf Bridging Limited
    Transazioni
    • 09 mag 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 01 nov 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 03 mag 2017
    Consegnato il 09 mag 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    1 orion houses, bruce avenue, worthing, BN11 5JN title no. WSX377567; 23 st andrews road, worthing, BN13 1HW title no. WSX169853.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Spf Bridging Limited
    Transazioni
    • 09 mag 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 01 nov 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 31 mar 2016
    Consegnato il 02 apr 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Land on the north side of bruce avenue, worthing, west sussex.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 apr 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 29 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 25 nov 2015
    Consegnato il 02 dic 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    2 st andrews road burgess hill west sussex.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Sallie Parker
    • Richard Parker
    Transazioni
    • 02 dic 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 14 gen 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 07 apr 2014
    Consegnato il 10 apr 2014
    In corso
    Breve descrizione
    2 st andrew road burgess hill west sussex t/n WSX56208.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 apr 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Legal charge
    Creato il 25 lug 2012
    Consegnato il 27 lug 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Windmill cottage old mill place pulborough west sussex. By way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable from any lease, all goodwill, the proceeds of any insurance, all fixtures and fittings not forming part of the property, all plant and machinery, all furniture equipment tools and other goods kept at the property.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 27 lug 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 14 giu 2012
    Consegnato il 16 giu 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill,uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 giu 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 19 mag 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 23 lug 2010
    Consegnato il 24 lug 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on the north east side of 32 culvers south harting petersfield west sussex t/no. WSX334781 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 24 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 30 set 2008
    Consegnato il 04 ott 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    99-101 high street, steyning, west sussex by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 04 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 10 mar 2008
    Consegnato il 11 mar 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    99-101 high street steyning t/no WSX309256 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 mag 2007
    Consegnato il 12 mag 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at the rear of treetops hill farm lane codmore hill pulborough. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 29 gen 2007
    Consegnato il 02 feb 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The land at the rear of laburnham cottage, hill farm lane, codmore hill, pulborough, west sussex t/no WSX300165. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 29 gen 2007
    Consegnato il 02 feb 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a 42 high street, steyning t/no WSX257202. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 22 dic 2006
    Consegnato il 23 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 dic 2006
    Consegnato il 23 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a the land at the rear of laburnham cottage hill farm lane codmore hill pulborough west sussex together with the dwelling house erected thereon k/a yew tree cottage t/no WSX114171. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 dic 2006
    Consegnato il 23 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a 42 high street steyning t/no WSX257202. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CHADWICK HOMES LTD ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    20 ott 2020Inizio della liquidazione
    04 nov 2023Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Daniel Mark Richardson
    Greg'S Building 1 Booth Street
    M2 4DU Manchester
    Praticante
    Greg'S Building 1 Booth Street
    M2 4DU Manchester
    Edward Avery-Gee
    Cg & Co Gregs Building
    1 Booth Street
    M2 4DU Manchester
    Praticante
    Cg & Co Gregs Building
    1 Booth Street
    M2 4DU Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0