TISSUE REGENIX LIMITED

TISSUE REGENIX LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTISSUE REGENIX LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05807272
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di TISSUE REGENIX LIMITED?

    • Altre ricerche e sviluppo sperimentale in scienze naturali e ingegneria (72190) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova TISSUE REGENIX LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Unit 3, Phoenix Court Lotherton Way
    Garforth
    LS25 2GY Leeds
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di TISSUE REGENIX LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2025
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2026
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2024

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per TISSUE REGENIX LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al21 apr 2026
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma05 mag 2026
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al21 apr 2025
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per TISSUE REGENIX LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Iscrizione dell'ipoteca 058072720006, creata il 23 dic 2025

    67 pagineMR01

    Nomina di Miss Kirsten Mary Lund come amministratore in data 16 ott 2025

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Daniel Ray Lee come amministratore in data 15 ott 2025

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Jay Charles Lecoque come amministratore in data 04 set 2025

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Jonathan Martin Glenn come amministratore in data 05 set 2025

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2024

    24 pagineAA

    Cessazione della carica di David Claiborne Cocke come amministratore in data 31 lug 2025

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 apr 2025 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 apr 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2023

    23 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 apr 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2022

    24 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 058072720004, creata il 27 gen 2023

    64 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 058072720005, creata il 27 gen 2023

    64 pagineMR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2021

    25 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 apr 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    31 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Daniel Lee il 20 ago 2021

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 apr 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr David Claiborne Cocke come amministratore in data 21 gen 2021

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    28 pagineAA

    Nomina di Mr Jonathan Martin Glenn come amministratore in data 03 dic 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Alan Jonathan Richard Miller come amministratore in data 03 dic 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Gareth Hywel Jones come amministratore in data 24 nov 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Daniel Lee come amministratore in data 16 nov 2020

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di TISSUE REGENIX LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LUND, Kirsten Mary
    Lotherton Way
    Garforth
    LS25 2GY Leeds
    Unit 3, Phoenix Court
    England
    Segretario
    Lotherton Way
    Garforth
    LS25 2GY Leeds
    Unit 3, Phoenix Court
    England
    265561930001
    LECOQUE, Jay Charles
    Lotherton Way
    Garforth
    LS25 2GY Leeds
    Unit 3, Phoenix Court
    England
    Amministratore
    Lotherton Way
    Garforth
    LS25 2GY Leeds
    Unit 3, Phoenix Court
    England
    United StatesAmerican340125000001
    LUND, Kirsten Mary
    Lotherton Way
    Garforth
    LS25 2GY Leeds
    Unit 3, Phoenix Court
    England
    Amministratore
    Lotherton Way
    Garforth
    LS25 2GY Leeds
    Unit 3, Phoenix Court
    England
    EnglandBritish341789650001
    DEVLIN, Paul John
    Astley Way, Astley Lane Industrial Estate
    Swillington
    LS26 8XT Leeds
    Unit 1 And 2
    England
    Segretario
    Astley Way, Astley Lane Industrial Estate
    Swillington
    LS26 8XT Leeds
    Unit 1 And 2
    England
    222138520001
    JEFFERSON, Ian David
    Astley Way, Astley Lane Industrial Estate
    Swillington
    LS26 8XT Leeds
    Unit 1 And 2
    England
    Segretario
    Astley Way, Astley Lane Industrial Estate
    Swillington
    LS26 8XT Leeds
    Unit 1 And 2
    England
    169191130001
    JONES, Gareth Hywel
    Astley Way, Astley Lane Industrial Estate
    Swillington
    LS26 8XT Leeds
    Unit 1 And 2
    England
    Segretario
    Astley Way, Astley Lane Industrial Estate
    Swillington
    LS26 8XT Leeds
    Unit 1 And 2
    England
    252393110001
    IP2IPO SERVICES LIMITED
    Innovation Way
    Heslington
    YO10 5NY York
    The Biocentre
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Innovation Way
    Heslington
    YO10 5NY York
    The Biocentre
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione05325867
    122951520001
    TECHTRAN LIMITED
    Leeds Innovation Centre
    103 Clarendon Road
    LS2 9DF Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    Leeds Innovation Centre
    103 Clarendon Road
    LS2 9DF Leeds
    West Yorkshire
    101761630001
    BARKER, Michael Denis
    Astley Way, Astley Lane Industrial Estate
    Swillington
    LS26 8XT Leeds
    Unit 1 And 2
    England
    Amministratore
    Astley Way, Astley Lane Industrial Estate
    Swillington
    LS26 8XT Leeds
    Unit 1 And 2
    England
    EnglandBritish160393640002
    COCKE, David Claiborne
    Lotherton Way
    Garforth
    LS25 2GY Leeds
    Unit 3, Phoenix Court
    England
    Amministratore
    Lotherton Way
    Garforth
    LS25 2GY Leeds
    Unit 3, Phoenix Court
    England
    United StatesAmerican279282120001
    COULDWELL, Steven Ashley
    Astley Way, Astley Lane Industrial Estate
    Swillington
    LS26 8XT Leeds
    Unit 1 And 2
    England
    Amministratore
    Astley Way, Astley Lane Industrial Estate
    Swillington
    LS26 8XT Leeds
    Unit 1 And 2
    England
    EnglandBritish240376920001
    COVE, Jonathan Howard, Doctor
    8 Moorlands
    Westwood Drive
    LS29 9QZ Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    8 Moorlands
    Westwood Drive
    LS29 9QZ Ilkley
    West Yorkshire
    United KingdomBritish91894120001
    DEVLIN, Paul John
    Astley Way, Astley Lane Industrial Estate
    Swillington
    LS26 8XT Leeds
    Unit 1 And 2
    England
    Amministratore
    Astley Way, Astley Lane Industrial Estate
    Swillington
    LS26 8XT Leeds
    Unit 1 And 2
    England
    EnglandBritish113889280002
    DOYLE, Christina, Professor
    Innovation Way
    Heslington
    YO10 5NY York
    The Biocentre
    North Yorkshire
    Amministratore
    Innovation Way
    Heslington
    YO10 5NY York
    The Biocentre
    North Yorkshire
    EnglandBritish87254760001
    FISHER, John, Professor
    Innovation Way
    Heslington
    YO10 5NY York
    The Biocentre
    North Yorkshire
    Amministratore
    Innovation Way
    Heslington
    YO10 5NY York
    The Biocentre
    North Yorkshire
    EnglandBritish60523680001
    GLENN, Jonathan Martin
    Lotherton Way
    Garforth
    LS25 2GY Leeds
    Unit 3, Phoenix Court
    England
    Amministratore
    Lotherton Way
    Garforth
    LS25 2GY Leeds
    Unit 3, Phoenix Court
    England
    United KingdomBritish148251560003
    INGHAM, Eileen, Professor
    Innovation Way
    Heslington
    YO10 5NY York
    The Biocentre
    North Yorkshire
    Amministratore
    Innovation Way
    Heslington
    YO10 5NY York
    The Biocentre
    North Yorkshire
    United KingdomBritish52281140001
    JEFFERSON, Ian David
    Astley Way, Astley Lane Industrial Estate
    Swillington
    LS26 8XT Leeds
    Unit 1 And 2
    England
    Amministratore
    Astley Way, Astley Lane Industrial Estate
    Swillington
    LS26 8XT Leeds
    Unit 1 And 2
    England
    EnglandBritish80245080002
    JONES, Gareth Hywel
    Lotherton Way
    Garforth
    LS25 2GY Leeds
    Unit 3, Phoenix Court
    England
    Amministratore
    Lotherton Way
    Garforth
    LS25 2GY Leeds
    Unit 3, Phoenix Court
    England
    EnglandBritish252371380001
    LEE, Daniel Ray
    Lotherton Way
    Garforth
    LS25 2GY Leeds
    Unit 3, Phoenix Court
    England
    Amministratore
    Lotherton Way
    Garforth
    LS25 2GY Leeds
    Unit 3, Phoenix Court
    England
    United StatesAmerican277099400001
    MILLER, Alan Jonathan Richard
    Lotherton Way
    Garforth
    LS25 2GY Leeds
    Unit 3, Phoenix Court
    England
    Amministratore
    Lotherton Way
    Garforth
    LS25 2GY Leeds
    Unit 3, Phoenix Court
    England
    EnglandBritish127433380001
    ODELL, Antony Ruben
    Astley Way, Astley Lane Industrial Estate
    Swillington
    LS26 8XT Leeds
    Unit 1 And 2
    England
    Amministratore
    Astley Way, Astley Lane Industrial Estate
    Swillington
    LS26 8XT Leeds
    Unit 1 And 2
    England
    EnglandBritish152306920001
    SAMUEL, John Andrew Walter
    Astley Way, Astley Lane Industrial Estate
    Swillington
    LS26 8XT Leeds
    Unit 1 And 2
    England
    Amministratore
    Astley Way, Astley Lane Industrial Estate
    Swillington
    LS26 8XT Leeds
    Unit 1 And 2
    England
    EnglandBritish130457350001
    STEVENSON, Alexander James
    Innovation Way
    Heslington
    YO10 5NY York
    The Biocentre
    North Yorkshire
    Amministratore
    Innovation Way
    Heslington
    YO10 5NY York
    The Biocentre
    North Yorkshire
    United KingdomBritish152307480001
    IP2IPO SERVICES LIMITED
    Innovation Way
    Heslington
    YO10 5NY York
    The Biocentre
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Innovation Way
    Heslington
    YO10 5NY York
    The Biocentre
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione05325867
    122951520001
    TECHTRAN LIMITED
    Leeds Innovation Centre
    103 Clarendon Road
    LS2 9DF Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Leeds Innovation Centre
    103 Clarendon Road
    LS2 9DF Leeds
    West Yorkshire
    101761630001

    Chi sono le persone con controllo significativo di TISSUE REGENIX LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Astley Way, Astley Lane Industrial Estate
    Swillington
    LS26 8XT Leeds
    Unit 1 And 2
    England
    06 apr 2016
    Astley Way, Astley Lane Industrial Estate
    Swillington
    LS26 8XT Leeds
    Unit 1 And 2
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleGb: United Kingdom - England
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione05969271
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0