REDSPUR (DOLLAR BAY) LIMITED
Panoramica
Nome della società | REDSPUR (DOLLAR BAY) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 05921853 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di REDSPUR (DOLLAR BAY) LIMITED?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
- Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari
- Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova REDSPUR (DOLLAR BAY) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 55 Loudoun Road St John's Wood NW8 0DL London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di REDSPUR (DOLLAR BAY) LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
LONDON & NEWCASTLE (DOLLAR BAY) LIMITED | 04 apr 2007 | 04 apr 2007 |
O W PROPERTIES LIMITED | 25 set 2006 | 25 set 2006 |
OLIVER WOLFRYD (DOLLAR BAY) LIMITED | 01 set 2006 | 01 set 2006 |
Quali sono gli ultimi bilanci di REDSPUR (DOLLAR BAY) LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per REDSPUR (DOLLAR BAY) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 set 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2017 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 set 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2016 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Notifica di London & Newcastle Capital Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Revoca di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo il 05 set 2017 | 2 pagine | PSC09 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 set 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Daniel Soning il 20 apr 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher Robin Leslie Phillips il 09 feb 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Avviso di cambio di nome" | 2 pagine | CONNOT | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 set 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2015 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 set 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 set 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2013 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * 73/75 Mortimer Street London W1W 7SQ United Kingdom* in data 12 feb 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Robert Daniel Soning il 29 ott 2013 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 set 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2012 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di REDSPUR (DOLLAR BAY) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARNETT, David Melvyn | Amministratore | Loudoun Road St John's Wood NW8 0DL London 55 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 39132210004 | ||||||||
PHILLIPS, Christopher Robin Leslie | Amministratore | Loudoun Road St John's Wood NW8 0DL London 55 | England | British | Company Director | 46176700002 | ||||||||
SCHUETT, Baerbel | Amministratore | Loudoun Road St John's Wood NW8 0DL London 55 United Kingdom | England | German | None | 150389260002 | ||||||||
SONING, Robert Daniel | Amministratore | Loudoun Road St John's Wood NW8 0DL London 55 United Kingdom | England | British | Director | 33156140022 | ||||||||
CARGIL MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Segretario | Melton Street NW1 2BW London 22 United Kingdom |
| 38636470004 | ||||||||||
E L SERVICES LIMITED | Segretario | 25 Harley Street W1G 9BR London | 78638580003 | |||||||||||
BERG, Simon Mark | Amministratore | 12 Adelaide Close HA7 3EL Stanmore Middlesex | United Kingdom | British | Director | 66989000001 | ||||||||
FRANKHAM, Vivienne | Amministratore | Mortimer Street W1W 7SQ London 73/75 United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 150385630001 | ||||||||
HENRIKSEN, Troels Bugge | Amministratore | Bagley Cottage Spring Copse OX1 5BJ Oxford Oxfordshire | England | British,Danish | Group Finance Director | 44984800004 | ||||||||
SHAMALJI, Lalit | Amministratore | 12 Abbotswood Gardens IG5 0BG Clayhall Essex | British | Financial Controller | 115187080001 | |||||||||
WOLFRYD, Oliver | Amministratore | 4 St. Stephen's Mews W2 5QZ London | United Kingdom | British | Property Development | 115187090001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di REDSPUR (DOLLAR BAY) LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London & Newcastle Capital Limited | 06 apr 2016 | Loudoun Road St John's Wood NW8 0DL London 55 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per REDSPUR (DOLLAR BAY) LIMITED?
Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
---|---|---|
01 set 2016 | 01 set 2016 | La società non ha ancora completato le misure ragionevoli per determinare se vi sia alcuna persona che sia una persona registrabile o un'entità giuridica rilevante registrabile in relazione alla società. |
REDSPUR (DOLLAR BAY) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 29 mar 2010 Consegnato il 03 apr 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due of each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, all computers, plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental legal charge | Creato il 17 ago 2007 Consegnato il 30 ago 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each present and future member of the group to the chargee and/or the other secured finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari 597 manchester road london t/no LN49520 all buildings fixtures and fittings. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental legal charge | Creato il 13 apr 2007 Consegnato il 20 apr 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Flat 5, dollar bay lawn house close ilse of dogs tower hamlets t/no EGL419053. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Accession deed to a debenture dated 19 june 2006 and | Creato il 14 nov 2006 Consegnato il 28 nov 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari 13 dollar bay court lawn house close isle of docs london t/n EGL356476,fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0