2OC (HOLDINGS) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | 2OC (HOLDINGS) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 06300204 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di 2OC (HOLDINGS) LIMITED?
- Attività di società holding di produzione (64202) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova 2OC (HOLDINGS) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Bank Gallery High Street CV8 1LY Kenilworth England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di 2OC (HOLDINGS) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| BLUE-NG (HOLDINGS) LIMITED | 26 set 2007 | 26 set 2007 |
| INTERCEDE 2195 LIMITED | 03 lug 2007 | 03 lug 2007 |
Quali sono gli ultimi bilanci di 2OC (HOLDINGS) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per 2OC (HOLDINGS) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Suite 5B 2nd Floor 1-9 Castle Street Hinckley Leicestershire LE10 1DA United Kingdom a Bank Gallery High Street Kenilworth CV8 1LY in data 12 gen 2021 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2019 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Modifica dei dettagli di 2Oc Ltd come persona con controllo significativo il 01 mag 2020 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 2 Temple Back East Temple Quay Bristol England BS1 6EG a Suite 5B 2nd Floor 1-9 Castle Street Hinckley Leicestershire LE10 1DA in data 07 mag 2020 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 06 feb 2020 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Nigel Mitchell come amministratore in data 13 dic 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2018 | 13 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 26 apr 2019
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 giu 2018 al 31 dic 2018 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 06 feb 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 5 in pieno | 3 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2017 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 06 feb 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Philip Green come amministratore in data 31 ago 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ernest Ronald Oxburgh come amministratore in data 31 mar 2017 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2016 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 06 feb 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ovalsec Limited come segretario in data 30 dic 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di 2OC (HOLDINGS) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REINHEIMER-JONES, Philip | Amministratore | Lower Bond Street LE10 1QU Hinckley Atkins Building United Kingdom | England | British | 177046520001 | |||||||||
| DURRANT, Andrew Peter | Segretario | 340 Sidegate Lane IP4 3DW Ipswich Suffolk | British | 85381310004 | ||||||||||
| FORWARD, David Charles | Segretario | Temple Back East Temple Quay BS1 6EG Bristol 2 England England | British | 26385930010 | ||||||||||
| GREEN, Richard Philip | Segretario | Temple Back East Temple Quay BS1 6EG Bristol 2 | British | 162243360001 | ||||||||||
| MITRE SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London | 900004680001 | |||||||||||
| OVALSEC LIMITED | Segretario | Temple Back East Temple Quay BS1 6EG Bristol 2 |
| 149653060001 | ||||||||||
| ASTLE, Edward Morrison | Amministratore | Bailey Farmhouse Chatham Green, Little Waltham CM3 3LE Chelmsford Essex | United Kingdom | British | 68674100002 | |||||||||
| COCHRANE, John Gregory | Amministratore | 1-3 Strand London WC2N 5EH | American | 124590170001 | ||||||||||
| GREEN, Richard Philip | Amministratore | Lower Bond Street LE10 1QU Hinckley Atkins Building United Kingdom | England | British | 58023250002 | |||||||||
| MAYHEW, George Philip Angus | Amministratore | 1 Rookery Cottages The Street GU10 3DU Frensham Surrey | British | 124744520001 | ||||||||||
| MITCHELL, Nigel | Amministratore | Lower Bond Street LE10 1QU Hinckley Atkins Building United Kingdom | England | British | 43097880001 | |||||||||
| OXBURGH, Ernest Ronald, Lord | Amministratore | Lower Bond Street LE10 1QU Hinckley Atkins Building United Kingdom | England | British | 116247330001 | |||||||||
| SCOTT, Jeffrey Alan | Amministratore | Strand WC2N 5EH London 1-3 | Uk | British | 148649200001 | |||||||||
| WATERS, Christopher John | Amministratore | Temple Back East Temple Quay BS1 6EG Bristol 2 England England | United Kingdom | British | 133752200002 | |||||||||
| WOOD, Alison Jane | Amministratore | 1-3 Strand London WC2N 5EH | United Kingdom | British | 131902120001 | |||||||||
| MITRE DIRECTORS LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London | 900024450001 | |||||||||||
| MITRE SECRETARIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London | 900027570001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di 2OC (HOLDINGS) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2oc Ltd | 06 apr 2016 | 1-9 Castle Street LE10 1DA Hinckley Suite 5b 2nd Floor Leicestershire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
2OC (HOLDINGS) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Account charge | Creato il 27 mar 2013 Consegnato il 10 apr 2013 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Charged property meaning all assets subject of the security interests created by the 2OC account charge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Agreement | Creato il 14 mar 2013 Consegnato il 23 mar 2013 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The agreement and by way of security to secure the performance of the vendor's obligations under clause 14 of the agreement the vendor has irrevocable appointed the purchasers as its attorney to execute any and all documents instruments and proxies which the purchasers may in their absolute and unfettered discretion require to enable the purchasers to exercise all voting and other rights attaching to the relevant debt and relevant shares. Shares means 3,600,000 issued fullypaid ordinary shres of £1 each in the capital of the company comprising 90 per cent of the issued share capital of the company at completion see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 04 ott 2012 Consegnato il 09 ott 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company 20C (UK) limited and 20C limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 04 ott 2012 Consegnato il 09 ott 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company 20C (UK) limited and 20C limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over securities | Creato il 25 set 2007 Consegnato il 05 ott 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company formerly known as intercede 2195 limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All securities and all related rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0