2OC (HOLDINGS) LIMITED

2OC (HOLDINGS) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della società2OC (HOLDINGS) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 06300204
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di 2OC (HOLDINGS) LIMITED?

    • Attività di società holding di produzione (64202) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova 2OC (HOLDINGS) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Bank Gallery
    High Street
    CV8 1LY Kenilworth
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di 2OC (HOLDINGS) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BLUE-NG (HOLDINGS) LIMITED26 set 200726 set 2007
    INTERCEDE 2195 LIMITED03 lug 200703 lug 2007

    Quali sono gli ultimi bilanci di 2OC (HOLDINGS) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per 2OC (HOLDINGS) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Suite 5B 2nd Floor 1-9 Castle Street Hinckley Leicestershire LE10 1DA United Kingdom a Bank Gallery High Street Kenilworth CV8 1LY in data 12 gen 2021

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2019

    7 pagineAA

    Modifica dei dettagli di 2Oc Ltd come persona con controllo significativo il 01 mag 2020

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da 2 Temple Back East Temple Quay Bristol England BS1 6EG a Suite 5B 2nd Floor 1-9 Castle Street Hinckley Leicestershire LE10 1DA in data 07 mag 2020

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 feb 2020 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Nigel Mitchell come amministratore in data 13 dic 2019

    1 pagineTM01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2018

    13 pagineAA

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 26 apr 2019

    • Capitale: GBP 2
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 giu 2018 al 31 dic 2018

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 feb 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    3 pagineMR04

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2017

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 feb 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Cessazione della carica di Richard Philip Green come amministratore in data 31 ago 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Ernest Ronald Oxburgh come amministratore in data 31 mar 2017

    2 pagineTM01

    Bilancio redatto al 30 giu 2016

    18 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 feb 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Ovalsec Limited come segretario in data 30 dic 2016

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di 2OC (HOLDINGS) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    REINHEIMER-JONES, Philip
    Lower Bond Street
    LE10 1QU Hinckley
    Atkins Building
    United Kingdom
    Amministratore
    Lower Bond Street
    LE10 1QU Hinckley
    Atkins Building
    United Kingdom
    EnglandBritish177046520001
    DURRANT, Andrew Peter
    340 Sidegate Lane
    IP4 3DW Ipswich
    Suffolk
    Segretario
    340 Sidegate Lane
    IP4 3DW Ipswich
    Suffolk
    British85381310004
    FORWARD, David Charles
    Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    2
    England
    England
    Segretario
    Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    2
    England
    England
    British26385930010
    GREEN, Richard Philip
    Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    2
    Segretario
    Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    2
    British162243360001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Segretario nominato
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900004680001
    OVALSEC LIMITED
    Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    2
    Segretario
    Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    2
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione01379423
    149653060001
    ASTLE, Edward Morrison
    Bailey Farmhouse
    Chatham Green, Little Waltham
    CM3 3LE Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    Bailey Farmhouse
    Chatham Green, Little Waltham
    CM3 3LE Chelmsford
    Essex
    United KingdomBritish68674100002
    COCHRANE, John Gregory
    1-3 Strand
    London
    WC2N 5EH
    Amministratore
    1-3 Strand
    London
    WC2N 5EH
    American124590170001
    GREEN, Richard Philip
    Lower Bond Street
    LE10 1QU Hinckley
    Atkins Building
    United Kingdom
    Amministratore
    Lower Bond Street
    LE10 1QU Hinckley
    Atkins Building
    United Kingdom
    EnglandBritish58023250002
    MAYHEW, George Philip Angus
    1 Rookery Cottages
    The Street
    GU10 3DU Frensham
    Surrey
    Amministratore
    1 Rookery Cottages
    The Street
    GU10 3DU Frensham
    Surrey
    British124744520001
    MITCHELL, Nigel
    Lower Bond Street
    LE10 1QU Hinckley
    Atkins Building
    United Kingdom
    Amministratore
    Lower Bond Street
    LE10 1QU Hinckley
    Atkins Building
    United Kingdom
    EnglandBritish43097880001
    OXBURGH, Ernest Ronald, Lord
    Lower Bond Street
    LE10 1QU Hinckley
    Atkins Building
    United Kingdom
    Amministratore
    Lower Bond Street
    LE10 1QU Hinckley
    Atkins Building
    United Kingdom
    EnglandBritish116247330001
    SCOTT, Jeffrey Alan
    Strand
    WC2N 5EH London
    1-3
    Amministratore
    Strand
    WC2N 5EH London
    1-3
    UkBritish148649200001
    WATERS, Christopher John
    Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    2
    England
    England
    Amministratore
    Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    2
    England
    England
    United KingdomBritish133752200002
    WOOD, Alison Jane
    1-3 Strand
    London
    WC2N 5EH
    Amministratore
    1-3 Strand
    London
    WC2N 5EH
    United KingdomBritish131902120001
    MITRE DIRECTORS LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Amministratore delegato nominato
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900024450001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Amministratore delegato nominato
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900027570001

    Chi sono le persone con controllo significativo di 2OC (HOLDINGS) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    1-9 Castle Street
    LE10 1DA Hinckley
    Suite 5b 2nd Floor
    Leicestershire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    1-9 Castle Street
    LE10 1DA Hinckley
    Suite 5b 2nd Floor
    Leicestershire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione05349641
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    2OC (HOLDINGS) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Account charge
    Creato il 27 mar 2013
    Consegnato il 10 apr 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Charged property meaning all assets subject of the security interests created by the 2OC account charge.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Luxembourg S.A.
    Transazioni
    • 10 apr 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 30 nov 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Agreement
    Creato il 14 mar 2013
    Consegnato il 23 mar 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The agreement and by way of security to secure the performance of the vendor's obligations under clause 14 of the agreement the vendor has irrevocable appointed the purchasers as its attorney to execute any and all documents instruments and proxies which the purchasers may in their absolute and unfettered discretion require to enable the purchasers to exercise all voting and other rights attaching to the relevant debt and relevant shares. Shares means 3,600,000 issued fullypaid ordinary shres of £1 each in the capital of the company comprising 90 per cent of the issued share capital of the company at completion see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Icon Master Holdings Ii (Gbp) S.A.R.L and Eea Holdings Limited
    Transazioni
    • 23 mar 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 04 ott 2012
    Consegnato il 09 ott 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company 20C (UK) limited and 20C limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Michael Edge
    Transazioni
    • 09 ott 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 20 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 04 ott 2012
    Consegnato il 09 ott 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company 20C (UK) limited and 20C limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nigel Mitchell
    Transazioni
    • 09 ott 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 20 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge over securities
    Creato il 25 set 2007
    Consegnato il 05 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as intercede 2195 limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All securities and all related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Grid Blue Power Finance Limited
    Transazioni
    • 05 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0