NW INDUSTRIAL LLP

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNW INDUSTRIAL LLP
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà in accomandita semplice
    Numero di società OC310347
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Dove si trova NW INDUSTRIAL LLP?

    Indirizzo della sede legale
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NW INDUSTRIAL LLP?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    AMERDALE KILMARTIN LLP14 lug 200514 lug 2005
    AMERDALE INVESTMENTS LLP03 dic 200403 dic 2004

    Quali sono gli ultimi bilanci di NW INDUSTRIAL LLP?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per NW INDUSTRIAL LLP?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società a responsabilità limitata dal registro

    3 pagineLLDS01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2012

    8 pagineLLAR01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2012

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 dic 2011

    3 pagineLLAR01

    Modifiche ai dati del socio per Kilmartin Property Group Limited in data 03 dic 2011

    2 pagineLLCH02

    Modifiche ai dati del socio per Kilmartin Holdings Limited in data 03 dic 2011

    2 pagineLLCH02

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    15 pagineAA

    Dimissioni di un revisore

    2 pagineLLPAUD

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2010

    8 pagineLLAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da Amerdale Hopuse Broughton Hall Skipton North Yorkshire BD23 3AE in data 02 nov 2010

    2 pagineLLAD01

    Nomina di Kilmartin Holdings Limited come socio

    3 pagineLLAP02

    Cessazione della carica di Mark Hancock come socio

    2 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di David Hood come socio

    2 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Adam Kerr come socio

    2 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Jonathan Ridehalgh come socio

    2 pagineLLTM01

    Avviso di cambio di nome"

    pagineLLNM01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed amerdale kilmartin LLP\certificate issued on 16/04/10
    2 pagineCERTNM

    Bilancio annuale redatto al 03 dic 2009

    9 pagineLLAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da North Barn, Broughton Hall Broughton, Skipton North Yorkshire BD23 3AE in data 19 gen 2010

    1 pagineLLAD01

    Modifiche ai dati del socio per Adam Charles Kerr in data 30 mar 2006

    1 pagineLLCH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    16 pagineAA

    legacy

    4 pagineLLP363

    Chi sono gli amministratori di NW INDUSTRIAL LLP?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KILMARTIN HOLDINGS LIMITED (IN RECEIVERSHIP)
    2nd Floor 68-73 Queen Street
    EH2 4NH Edinburgh
    Erskine House
    Scotland
    Socio designato di LLP
    2nd Floor 68-73 Queen Street
    EH2 4NH Edinburgh
    Erskine House
    Scotland
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazioneSC149650
    153831270002
    KILMARTIN PROPERTY GROUP LIMITED (IN RECEIVERSHIP)
    2nd Floor
    68 - 73 Queen Street
    EH2 4NH Edinburgh
    Erskine House
    Scotland
    Socio designato di LLP
    2nd Floor
    68 - 73 Queen Street
    EH2 4NH Edinburgh
    Erskine House
    Scotland
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazioneSC158115
    141723240002
    HANCOCK, Mark Edward
    The Old Vicarage
    Arncliffe
    BD23 5QD Skipton
    Socio designato di LLP
    The Old Vicarage
    Arncliffe
    BD23 5QD Skipton
    England141515870001
    HOOD, David Richard
    Throstles Nest Farm
    Conistone With Kilnsey
    BD23 5HT Skipton
    Socio designato di LLP
    Throstles Nest Farm
    Conistone With Kilnsey
    BD23 5HT Skipton
    United Kingdom141372640001
    KERR, Adam Charles
    Snail Hall
    Millwood Road Polstead
    CO6 5AU Colchester
    Socio designato di LLP
    Snail Hall
    Millwood Road Polstead
    CO6 5AU Colchester
    United Kingdom141326000001
    RIDEHALGH, Jonathan Mark
    Burnt House Farm
    Blacko
    BB9 6RG Nelson
    Socio di LLP
    Burnt House Farm
    Blacko
    BB9 6RG Nelson
    United Kingdom76321080001

    NW INDUSTRIAL LLP ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of assignment and charge
    Creato il 22 giu 2007
    Consegnato il 05 lug 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The net rental income and the benefit of all other rights and claims in relation to the properties,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 22 giu 2007
    Consegnato il 27 giu 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a normanby park steelworks park farm road scunthorpe t/no HS112548, part of the f/h land lying to the west of park farm road scunthorpe t/no HS135826, part f/h land lying to the east and west of park farm road scunthorpe t/no HS129294 for details of further properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of assignment and charge
    Creato il 14 dic 2005
    Consegnato il 20 dic 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee
    Brevi particolari
    The net rental income and benefit of all other rights and claims in relation to the property and all its right title and interest in the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 14 dic 2005
    Consegnato il 20 dic 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee
    Brevi particolari
    F/H and l/h land and buildings on the east side of orrell lane and netherton way bootle known as trinity park t/no MS278682. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of assignment and charge
    Creato il 03 giu 2005
    Consegnato il 16 giu 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of assignment the net rental income and the benefit of all other rights and claims, by way of assignment the deposit and all right title and interets in the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 03 giu 2005
    Consegnato il 11 giu 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings on the east side of orrell lane and netherton way bootle k/a trinity park t/no MS278682. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 31 gen 2005
    Consegnato il 03 feb 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage the l/h property being moorgate point moorgate road knowsley industrial park (north) kirkby merseyside by way of fixed charge all buildings and other structures any goodwill by way of floating charge all unattached plant machinery chattels and goods. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 03 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of assignment and charge
    Creato il 31 gen 2005
    Consegnato il 03 feb 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee
    Brevi particolari
    By way of assignment the net rental income and the benefit to the borrower. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 03 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 28 gen 2005
    Consegnato il 03 feb 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 03 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0