CENTRE HOTELS (CRANSTON) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CENTRE HOTELS (CRANSTON) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC004676 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CENTRE HOTELS (CRANSTON) LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova CENTRE HOTELS (CRANSTON) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EG Edinburgh |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di CENTRE HOTELS (CRANSTON) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per CENTRE HOTELS (CRANSTON) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Verbale della riunione finale di liquidazione volontaria | 13 pagine | 4.26(Scot) | ||||||||||
Cessazione della carica di Justin Bruce Robinson come amministratore in data 14 set 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Haysmacintyre Company Secretaries Limited il 18 dic 2017 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Patrick Thomas Mabry il 18 dic 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Justin Bruce Robinson il 18 dic 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Michael Teasdale il 18 dic 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Holiday Inn 107 Queensferry Road Edinburgh EH4 3HL a Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EG in data 03 nov 2017 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere SC0046760005 | 5 pagine | MR05 | ||||||||||
Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere SC0046760004 | 5 pagine | MR05 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Stato del capitale al 10 lug 2017
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Justin Bruce Robinson il 03 feb 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 gen 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Justin Bruce Robinson il 20 feb 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 02 gen 2016 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Ivaylo Kolev come amministratore in data 17 dic 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Paul Loynes come amministratore in data 17 dic 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Paul Loynes come segretario in data 17 dic 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Skardon Francis Baker come amministratore in data 17 dic 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CENTRE HOTELS (CRANSTON) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Segretario | Queen Street Place EC4R 1AG London 10 United Kingdom |
| 89121630002 | ||||||||||
| MABRY, Patrick Thomas | Amministratore | 20 Castle Terrace EH1 2EG Edinburgh Saltire Court | Luxembourg | German | 204005420001 | |||||||||
| TEASDALE, Simon Michael | Amministratore | 20 Castle Terrace EH1 2EG Edinburgh Saltire Court | United Kingdom | British | 204008350001 | |||||||||
| BOLTON, Susan | Segretario | 10 Haygreen Close KT2 7TS Kingston Upon Thames Surrey | British | 59426570001 | ||||||||||
| COMBEER, Jean Brenda | Segretario | Robin Hill 3 St Johns Avenue KT22 7HT Leatherhead Surrey | British | 50345500001 | ||||||||||
| COMBEER, Jean Brenda | Segretario | Robin Hill 3 St Johns Avenue KT22 7HT Leatherhead Surrey | British | 50345500001 | ||||||||||
| CRANE, Julia Alison | Segretario | 27 Hatton Court Lubbock Road BR7 5JQ Chislehurst Kent | British | 46318020001 | ||||||||||
| ENGMANN, Catherine | Segretario | 18 Rays Avenue SL4 5HG Windsor Berkshire | British | 92722710002 | ||||||||||
| LOYNES, Paul | Segretario | St. George Street W1S 1FS London 25 United Kingdom | 203612770001 | |||||||||||
| TOON, Samantha Anne | Segretario | 10 St.Anthonys Court Nightingale Lane SW12 8NS London | British | 32930670001 | ||||||||||
| WHITNEY, Paul Sumpter | Segretario | The Barnstead Evenley NN13 5SG Brackley Northants | British | 418890001 | ||||||||||
| WILLIAMS, Alison | Segretario | 27 Valley Road CM11 2BS Billericay Essex | British | 78744290002 | ||||||||||
| HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Segretario | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 United Kingdom |
| 89121630002 | ||||||||||
| PAUL HASTINGS ADMINISTRATIVE SERVICES LIMITED | Segretario | Ten Bishops Square Eighth Floor E1 6EG London 10 United Kingdom |
| 125623230001 | ||||||||||
| BAKER, Skardon Francis | Amministratore | St. George Street W1S 1FS London 25 | United Kingdom | American | 196342720001 | |||||||||
| CASTON, Robert Warwick | Amministratore | Square De Heeus 20 FOREIGN 1400 Brussels Belgium | British | 1311840002 | ||||||||||
| EKAS, Petra Cecilia Maria | Amministratore | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 United Kingdom | United Kingdom | Dutch | 169731050002 | |||||||||
| FISH, Andrew John | Amministratore | Cherry Tree Cottage Manor Close KT24 6SA East Horsley Surrey | England | British | 77133450001 | |||||||||
| GRAHAM, Ian Christopher | Amministratore | Avenue Venus 2 1410 Waterloo Belgium | British | 31551670001 | ||||||||||
| JACKMAN, Robert Loehr | Amministratore | 4 Durning Place SL5 7EZ Ascot Berkshire | American | 35835670003 | ||||||||||
| KOLEV, Ivaylo | Amministratore | St. George Street W1S 1FS London 25 | Uk | Bulgarian | 193389430001 | |||||||||
| LOYNES, Paul | Amministratore | St. George Street W1S 1FS London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 241370450001 | |||||||||
| MCCARTHY, John Patrick | Amministratore | Regents Park Road NW1 8XL London 120 | United States | 112396050001 | ||||||||||
| MCEWAN, Allan Scott | Amministratore | 29 Kings Road SL4 2AD Windsor Berkshire | United Kingdom | British | 75569660002 | |||||||||
| NEWMAN, Mark | Amministratore | Flat 7 44 Sloane Street SW1X 9LU London | United Kingdom | Canadian | 62529820001 | |||||||||
| PRINCE, Ryan David | Amministratore | 7a Howick Place SW1P 1DZ London 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | Canadian | 85682450077 | |||||||||
| REES, Sally Irene | Amministratore | 3 Sandown Gate KT10 9LB Esher Surrey | England | British | 49954790002 | |||||||||
| RITSON, Leslie David | Amministratore | Old Middle Cator House Cator Widecombe In The Moor TQ13 7UA Newton Abbot Devonshire | British | 26098610002 | ||||||||||
| ROBINSON, Justin Bruce | Amministratore | 20 Castle Terrace EH1 2EG Edinburgh Saltire Court | United Kingdom | British | 225299130001 | |||||||||
| SPRINGETT, Catherine Mary | Amministratore | The Coach House 32 Kerrison Road Ealing W5 5NW London | United Kingdom | British | 147336720001 | |||||||||
| STOCKS, Nigel Peter | Amministratore | Birdwoods School Lane Shackleford GU8 6AZ Godalming Surrey | United Kingdom | British | 147336730001 | |||||||||
| VAN OOSTEROM, Sophie | Amministratore | Orlando Road SW4 0LD London 19 United Kingdom | United Kingdom | Dutch | 139801070001 | |||||||||
| WHITNEY, Paul Sumpter | Amministratore | The Barnstead Evenley NN13 5SG Brackley Northants | British | 418890001 | ||||||||||
| WINTER, Richard Thomas | Amministratore | 33 St Johns Avenue Putney SW15 6AL London | United Kingdom | British | 6308500001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CENTRE HOTELS (CRANSTON) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ribbon Hotels Group (Uk) Limited | 06 apr 2016 | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
CENTRE HOTELS (CRANSTON) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 01 dic 2015 Consegnato il 02 dic 2015 | In corso | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 01 dic 2015 Consegnato il 02 dic 2015 | In corso | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 22 mag 2013 Consegnato il 03 giu 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione The security agreement among others the ocmpany and the common security agent creates a fixed charge over present and future land and intellectual property rights owned by the company. Notification of addition to or amendment of charge. Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 22 mag 2013 Consegnato il 03 giu 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Notification of addition to or amendment of charge. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Memorandum of deposit | Creato il 13 feb 1966 Consegnato il 22 feb 1966 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Leasehold premises at kenilworth hotel, great russell street, waverley hotel, southampton row and ivanhoe hotel, bloomsbury street, london. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
CENTRE HOTELS (CRANSTON) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0