ABERNESS LTD.

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàABERNESS LTD.
    Stato della societàConvertita/Chiusa
    Forma giuridicaConvertita o chiusa
    Numero di società SC050246
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ABERNESS LTD.?

    • (5134) /
    • (5135) /
    • (5139) /
    • (5211) /

    Dove si trova ABERNESS LTD.?

    Indirizzo della sede legale
    Robert Owen House
    87 Bath Street
    G2 2EE Glasgow
    Scotland
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ABERNESS LTD.?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ABERNESS FOODS LIMITED07 apr 197207 apr 1972

    Quali sono gli ultimi bilanci di ABERNESS LTD.?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al02 gen 2010

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per ABERNESS LTD.?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per ABERNESS LTD.?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Certificato di iscrizione di una Società di mutuo soccorso

    3 pagineCERTIPS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Conversion to industrial & provident society 11/11/2010
    RES13

    Bilancio annuale redatto al 01 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 set 2010

    Stato del capitale al 14 set 2010

    • Capitale: GBP 148,687.5
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 02 gen 2010

    10 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Timothy Hurrell il 01 ago 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen Humes il 01 ago 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 02 mag 2009

    15 pagineAA

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 30 apr 2010 al 04 gen 2010

    1 pagineAA01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Dickson Minto 16 Charlotte Square Edinburgh Midlothian EH2 4DF* in data 02 nov 2009

    1 pagineAD01

    Nomina di Mrs Caroline Jane Sellers come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Emily Martin come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di William Robson come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    15 pagine419a(Scot)

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 26 apr 2008

    18 pagineAA

    legacy

    2 pagine288c

    Chi sono gli amministratori di ABERNESS LTD.?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SELLERS, Caroline Jane
    c/o Governance Dept, 5th Floor
    Corporation Street
    M60 6ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Segretario
    c/o Governance Dept, 5th Floor
    Corporation Street
    M60 6ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    146633780001
    HUMES, Stephen
    c/o Governance Dept.
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th Floor, New Century House
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Governance Dept.
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th Floor, New Century House
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director84087790001
    HURRELL, Timothy
    c/o Governance Dept.
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th Floor, New Century House
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Governance Dept.
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th Floor, New Century House
    United Kingdom
    United KingdomBritishGeneral Manager Food Group99724260001
    COCHRANE, Thomas Bruce
    11 Bayview Road
    AB15 4EY Aberdeen
    Segretario
    11 Bayview Road
    AB15 4EY Aberdeen
    BritishCompany Chairman80990001
    COOPER, Yvonne Mary
    Fairview Boyndlie
    AB43 7DT Fraserburgh
    Aberdeenshire
    Segretario
    Fairview Boyndlie
    AB43 7DT Fraserburgh
    Aberdeenshire
    BritishChartered Accountant60474240001
    GRANT, Stephen Martin
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishCompany Director20888800002
    HENDERSON, Sarah Michaella
    13 Arthurs Close
    Emersons Green
    BS16 7JB Bristol
    Segretario
    13 Arthurs Close
    Emersons Green
    BS16 7JB Bristol
    British77216170001
    HENSHAW, Stephen Anthony
    Eastleigh Stables
    Bishopstrow
    BA12 9HW Warminster
    Wiltshire
    Segretario
    Eastleigh Stables
    Bishopstrow
    BA12 9HW Warminster
    Wiltshire
    BritishCompany Secretary91828160006
    MARTIN, Emily Louise
    49 Henley Park
    Yatton
    BS49 4JJ Bristol
    Segretario
    49 Henley Park
    Yatton
    BS49 4JJ Bristol
    BritishCompany Secretary115285710001
    MONCUR, Brian
    41 Gilbert Road
    Bucksburn
    AB21 9AN Aberdeen
    Aberdeenshire
    Segretario
    41 Gilbert Road
    Bucksburn
    AB21 9AN Aberdeen
    Aberdeenshire
    British118915490001
    BACK, Steven John
    Fennels 119 Bicester Road
    Lower End
    HP18 9EF Long Crendon
    Amministratore
    Fennels 119 Bicester Road
    Lower End
    HP18 9EF Long Crendon
    United KingdomBritishFinance Director85825120001
    BICKERSTAFFE, Katie
    Aston Lodge
    5 Highdale Road
    BS21 7UW Clevedon
    Avon
    Amministratore
    Aston Lodge
    5 Highdale Road
    BS21 7UW Clevedon
    Avon
    BritishCompany Director110621690001
    CHEYNE, David George Thomson
    The Covert 98 Woodlands Road
    Ashurst
    SO40 7AH Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    The Covert 98 Woodlands Road
    Ashurst
    SO40 7AH Southampton
    Hampshire
    BritainBritishCompany Director74956170001
    CLELAND, John Bradley
    70 Andrews Close
    Alexander Quay
    SO14 3HS Ocean Village
    Southampton
    Amministratore
    70 Andrews Close
    Alexander Quay
    SO14 3HS Ocean Village
    Southampton
    BritishDirector115346060001
    COCHRANE, Thomas Bruce
    11 Bayview Road
    AB15 4EY Aberdeen
    Amministratore
    11 Bayview Road
    AB15 4EY Aberdeen
    ScotlandBritishCompany Chairman80990001
    COOPER, Yvonne Mary
    Fairview Boyndlie
    AB43 7DT Fraserburgh
    Aberdeenshire
    Amministratore
    Fairview Boyndlie
    AB43 7DT Fraserburgh
    Aberdeenshire
    BritishChartered Accountant60474240001
    CROSS, Thomas Patrick
    Charnwood House
    AB13 0AL Milltimber
    Aberdeen
    Amministratore
    Charnwood House
    AB13 0AL Milltimber
    Aberdeen
    ScotlandBritishCeo158559420001
    GRANT, Stephen Martin
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishCompany Director20888800002
    GRAY, Alan
    Dunnottar
    Aultnaskiach Avenue
    IV2 4AS Inverness
    Amministratore
    Dunnottar
    Aultnaskiach Avenue
    IV2 4AS Inverness
    BritishMerchant82250001
    HAY, Graeme
    4 Mill Road
    Port Elphinstone
    AB51 5UD Inverurie
    Aberdeenshire
    Amministratore
    4 Mill Road
    Port Elphinstone
    AB51 5UD Inverurie
    Aberdeenshire
    ScotlandBritishRetail Director52783300002
    HENSHAW, Stephen Anthony
    2 Ashton Coombe Lower Road
    Bratton
    BA13 4JQ Westbury
    Wiltshire
    Amministratore
    2 Ashton Coombe Lower Road
    Bratton
    BA13 4JQ Westbury
    Wiltshire
    BritishDirector91828160003
    MASON, Paul
    Moor Lane
    Burley Woodhead
    LS29 7SW Ilkley
    Moorlands
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Moor Lane
    Burley Woodhead
    LS29 7SW Ilkley
    Moorlands
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector141310720001
    MONCUR, Brian
    41 Gilbert Road
    Bucksburn
    AB21 9AN Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    41 Gilbert Road
    Bucksburn
    AB21 9AN Aberdeen
    Aberdeenshire
    United KingdomBritishChartered Accountant118915490001
    MORRICE, Stanley Watt
    2 Ogston Mill
    Mill Of Fintray
    AB21 0LW Aberdeen
    Amministratore
    2 Ogston Mill
    Mill Of Fintray
    AB21 0LW Aberdeen
    ScotlandBritishManaging Director27176530003
    NICOL, Bruce Walker
    18 Glenhome Walk
    Dyce
    AB2 0FJ Aberdeen
    Amministratore
    18 Glenhome Walk
    Dyce
    AB2 0FJ Aberdeen
    BritishMerchant38460630001
    OAKES, Martin Nicholas
    Oakhurst House
    Fulready, Ettington
    CV37 7PE Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Oakhurst House
    Fulready, Ettington
    CV37 7PE Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    United KingdomBritishLogistics Director86206380002
    ROBSON, William Henry Mark
    12 Kimble Close
    Knightcote
    CV47 2SJ Southam
    Warwickshire
    Amministratore
    12 Kimble Close
    Knightcote
    CV47 2SJ Southam
    Warwickshire
    EnglandBritishFinance Director57803420002
    SEAL, Michael James
    Ivydene
    Leewood Road
    FK15 0DZ Dunblane
    Perthshire
    Amministratore
    Ivydene
    Leewood Road
    FK15 0DZ Dunblane
    Perthshire
    BritishBusiness Consultant4975340001
    SHAND, George Dugald Baird
    13 Gullymoss View
    Westhill
    AB32 6PF Aberdeen
    Amministratore
    13 Gullymoss View
    Westhill
    AB32 6PF Aberdeen
    BritishMerchant81000001
    SMITH, Colin George
    Tallius
    Jubilee Road, Finchampstead
    RG40 3SR Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    Tallius
    Jubilee Road, Finchampstead
    RG40 3SR Wokingham
    Berkshire
    BritishDirector111628890001
    WILLIAMSON, Bruce Mitchell Scott
    The Old Mill Bayswater Road
    Headington
    OX3 9SB Oxford
    Amministratore
    The Old Mill Bayswater Road
    Headington
    OX3 9SB Oxford
    BritishFilm Producer55255350001
    WILLIAMSON, James Mitchell
    6 Woodend Road
    AB2 6YH Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    6 Woodend Road
    AB2 6YH Aberdeen
    Aberdeenshire
    BritishMerchant80980001
    WILLIAMSON, James Campbell
    2 Carnegie Gardens
    AB2 4AW Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    2 Carnegie Gardens
    AB2 4AW Aberdeen
    Aberdeenshire
    BritishMerchant80960001
    WILLIAMSON, Ronald Alexander
    14 Ravelston Dykes Road
    EH4 3PQ Edinburgh
    Amministratore
    14 Ravelston Dykes Road
    EH4 3PQ Edinburgh
    BritishMerchant80970001

    ABERNESS LTD. ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Floating charge
    Creato il 06 mar 2006
    Consegnato il 23 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 23 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 30 giu 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 20 gen 2006
    Consegnato il 08 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The supermarket premises known as one provost davidson drive, meiklemill in the parish of ellon and county of aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 20 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 20 gen 2006
    Consegnato il 08 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The subjects known as and forming the mace store, the clachan, roseneath, helensburgh dmb 53344.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 20 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 20 gen 2006
    Consegnato il 08 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The shop known as twenty two north street, bishopmill, elgin in the county of moray.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 20 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 20 gen 2006
    Consegnato il 08 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    That area of ground at auchtercairn farm extending to four hundred and thirty three square yards or thereby lying to the east of the public road leading from gairloch to poolewe along which it extends one hundred and twenty five feet six inches or thereby in the parish of gairloch.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 20 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 20 gen 2006
    Consegnato il 08 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The shop premises and others known as two and four bridge street, strichen in the parish of strichen and county of aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 20 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 20 gen 2006
    Consegnato il 08 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The shop premises known as numbers fifteen and seventeen fountainhall road, aberdeen consisting of a shop on ground floor level, the whole of the basement and cellar below the said shop and access leading thereto.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 20 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 20 gen 2006
    Consegnato il 08 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The shop premises known as seventy six and seventy eight countesswells road, aberdeen in the city and county of aberdeen together with ground attached.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 20 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 20 gen 2006
    Consegnato il 08 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The shop premises known as twenty high street, kenmay in the parish of kenmay and county of aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 26 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 20 gen 2006
    Consegnato il 01 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    That area of ground at auchtercairn farm extending to four hundred and thirty three square yards or thereby.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 01 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 20 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 20 gen 2006
    Consegnato il 01 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    2/4 bridge street, strichen, aberdeenshire.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 01 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 20 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 20 gen 2006
    Consegnato il 01 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    15-17 fountainhall road, aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 01 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 20 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 20 gen 2006
    Consegnato il 01 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    76 and 78 countesswells road, aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 01 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 20 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 20 gen 2006
    Consegnato il 01 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    22/24 north street, elgin.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 01 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 20 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 20 gen 2006
    Consegnato il 01 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The supermarket premises known as one provost davidson drive, meiklemill in the parish of ellon and county of aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 01 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 20 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 20 gen 2006
    Consegnato il 01 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The subjects known as and forming the mace store, the clachan, roseneath, helensburgh dmb 53344.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 01 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 20 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 20 gen 2006
    Consegnato il 01 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The shop premises known as twenty high street, kenmay in the parish of kenmay and county of aberdeen abn 35440.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 01 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 26 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Debenture
    Creato il 23 dic 2005
    Consegnato il 10 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 10 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 16 feb 2009
    • 24 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 23 dic 2005
    Consegnato il 04 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 04 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 10 gen 2006Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 30 giu 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Standard security
    Creato il 14 gen 2002
    Consegnato il 28 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    2.08 acres and 0.202 hectares at broadfield road, bridge of don industrial estate, aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 28 dic 2001
    Consegnato il 04 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 04 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 20 feb 1996
    Consegnato il 28 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    0.202 hectares of ground at broadfold road/silverburn place,bridge of don industrial estate,oldmachar,aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 28 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 08 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 02 nov 1994
    Consegnato il 08 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    (1ST) area of ground (2.08 acres) at broadfold road, bridge of don, aberdeen (2ND) lease granted by the grampian regional council ifo A.R. gray limited in respect of subjects extending to 0.202 hectares or thereby at broadfold road, bridge of don.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 08 nov 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 08 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 25 mag 1994
    Consegnato il 10 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Area of ground situated at north muirton, perth.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 10 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 09 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 13 feb 1992
    Consegnato il 21 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    76/78 countesswells road, aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 21 feb 1992Registrazione di un'ipoteca
    • 25 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0