TRINITY HOMES (SCOTLAND) LIMITED

TRINITY HOMES (SCOTLAND) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTRINITY HOMES (SCOTLAND) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC135523
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TRINITY HOMES (SCOTLAND) LIMITED?

    • Costruzione di edifici residenziali (41202) / Costruzioni

    Dove si trova TRINITY HOMES (SCOTLAND) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Stoneyfield House
    Stoneyfield Business Park
    IV2 7PA Inverness
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TRINITY HOMES (SCOTLAND) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TRINITY HOMES (INVERNESS) LIMITED22 gen 199222 gen 1992
    STOCKSYSTEM LIMITED10 dic 199110 dic 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di TRINITY HOMES (SCOTLAND) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 nov 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per TRINITY HOMES (SCOTLAND) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 ott 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 nov 2022

    12 pagineAA

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 giu 2022 al 30 nov 2022

    1 pagineAA01

    Nomina di Addleshaw Goddard (Scotland) Secretarial Limited come segretario in data 09 nov 2022

    2 pagineAP04

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 ott 2022 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 30 giu 2021

    7 pagineAA

    legacy

    35 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Seconda presentazione per la notifica di Thistle Spv2 Limited come persona con controllo significativo

    7 pagineRP04PSC02

    Notifica di Thistle Spv2 Limited come persona con controllo significativo il 30 nov 2021

    2 paginePSC02
    Note
    DataNota
    24 gen 2022Second Filing The information on the form PSC02 has been replaced by a second filing on 24/01/2022

    Cessazione di Tulloch Limited come persona con controllo significativo il 30 nov 2021

    1 paginePSC07

    Soddisfazione dell'onere SC1355230017 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere SC1355230015 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere SC1355230016 in pieno

    4 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 ott 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 30 giu 2020

    6 pagineAA

    legacy

    34 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 ott 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 30 giu 2019

    9 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di TRINITY HOMES (SCOTLAND) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ADDLESHAW GODDARD (SCOTLAND) SECRETARIAL LIMITED
    Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    Exchange Tower, 19
    Scotland
    Segretario
    Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    Exchange Tower, 19
    Scotland
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazioneSC131085
    665080009
    FRASER, George Gabriel
    Stoneyfield House
    Stoneyfield Business Park
    IV2 7PA Inverness
    Amministratore
    Stoneyfield House
    Stoneyfield Business Park
    IV2 7PA Inverness
    ScotlandBritishNone50219540001
    GRANT, Alexander James
    Stoneyfield House
    Stoneyfield Business Park
    IV2 7PA Inverness
    Amministratore
    Stoneyfield House
    Stoneyfield Business Park
    IV2 7PA Inverness
    United KingdomBritishDirector113195780003
    CAMERON, James
    Stoneyfield House
    Stoneyfield Business Park
    IV2 7PA Inverness
    Segretario
    Stoneyfield House
    Stoneyfield Business Park
    IV2 7PA Inverness
    British166637730001
    CAMPBELL, Gary Angus
    Clach Na Sanais
    Croy
    IV1 2PG Inverness
    Segretario
    Clach Na Sanais
    Croy
    IV1 2PG Inverness
    British44913110001
    MACDONALD, Ronald Sutherland
    135 Stewarton Drive
    G72 8DH Cambuslang
    Segretario
    135 Stewarton Drive
    G72 8DH Cambuslang
    BritishCompany Director145418810001
    STEWART, Katherine Marion
    7 Culloden Court
    Culloden
    IV1 2DX Inverness
    Inverness Shire
    Segretario
    7 Culloden Court
    Culloden
    IV1 2DX Inverness
    Inverness Shire
    British35539210001
    SUTHERLAND, Caroline Anne
    Slackbuie Way
    Fairways
    IV2 6AT Inverness
    29
    United Kingdom
    Segretario
    Slackbuie Way
    Fairways
    IV2 6AT Inverness
    29
    United Kingdom
    BritishSolicitor87534020003
    SUTHERLAND, David Fraser
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    Segretario
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    BritishChartered Accountant1321720003
    TRACE, Marjory Bremner
    1 Wellside Road
    Balloch
    IV2 7GS Inverness
    Segretario
    1 Wellside Road
    Balloch
    IV2 7GS Inverness
    British43522850004
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Segretario nominato
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    BOYD, Lynne Mackenzie
    2 Firthview Drive
    IV3 5LS Inverness
    Amministratore
    2 Firthview Drive
    IV3 5LS Inverness
    BritishSales Manager37279720001
    CAMERON, Neil Stuart
    30 Overton Avenue
    IV3 6RR Inverness
    Amministratore
    30 Overton Avenue
    IV3 6RR Inverness
    ScotlandBritishChartered Surveyor34848670001
    CHAVASSE, Ian Macdougall
    37 Edgemoor Park
    Balloch
    IV1 2RA Inverness
    Inverness Shire
    Amministratore
    37 Edgemoor Park
    Balloch
    IV1 2RA Inverness
    Inverness Shire
    BritishGeneral Manager20013390001
    MACDONALD, Ronald Sutherland
    135 Stewarton Drive
    G72 8DH Cambuslang
    Amministratore
    135 Stewarton Drive
    G72 8DH Cambuslang
    United KingdomBritishCompany Director145418810001
    MACLENNAN, Fiona
    Steinnola
    7 Macleod Place
    IV15 9TZ Dingwall
    Ross Shire
    Amministratore
    Steinnola
    7 Macleod Place
    IV15 9TZ Dingwall
    Ross Shire
    BritishChartered Accountant45638410001
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    BritishDirector109250000001
    PETERS, Douglas
    8 Margaret Rose Loan
    EH10 7EQ Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    8 Margaret Rose Loan
    EH10 7EQ Edinburgh
    Midlothian
    BritishFinancial Director108781900001
    SUTHERLAND, David Fraser
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    Amministratore
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    ScotlandBritishChartered Accountant1321720003
    TRACE, Marjory Bremner
    1 Wellside Road
    Balloch
    IV2 7GS Inverness
    Amministratore
    1 Wellside Road
    Balloch
    IV2 7GS Inverness
    BritishCompany Secretary43522850004
    WRIGHT, Donald James
    Griannan
    St Leonards Road
    IV36 2RE Forres
    Moray
    Amministratore
    Griannan
    St Leonards Road
    IV36 2RE Forres
    Moray
    ScotlandBritishChief Executive75244500002
    JORDANS (SCOTLAND) LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Amministratore delegato nominato
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000000001

    Chi sono le persone con controllo significativo di TRINITY HOMES (SCOTLAND) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    Exchange Tower, 19
    Scotland
    30 nov 2021
    Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    Exchange Tower, 19
    Scotland
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleScotland
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazioneSc715926
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Stoneyfield Business Park
    IV2 7PA Inverness
    Stoneyfield House
    Scotland
    06 apr 2016
    Stoneyfield Business Park
    IV2 7PA Inverness
    Stoneyfield House
    Scotland
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleUnited Kingdon
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazioneSc125792
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    TRINITY HOMES (SCOTLAND) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 17 ott 2018
    Consegnato il 25 ott 2018
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Standard security by trinity homes (scotland) limited in favour of bank of scotland PLC. Property: residential housing development at the courtyard, duff street, aberdeen, AB24 5LF.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 25 ott 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 17 dic 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 02 ago 2018
    Consegnato il 03 ago 2018
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 ago 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 17 dic 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 ott 2017
    Consegnato il 27 ott 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    All and whole the subjects described (in the first place) to (in the fifth place) that form part and portion of all and whole the subjects known as and forming 3, 4, 5-7 and 9, 11 and 13 duff street, aberdeen AB24 5LF, and being the whole subjects registered in the land register of scotland under title numbers ABN30939 and ABN92199 for further details please refer to the instrument.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC, (Registered Company Number SC327000)
    Transazioni
    • 27 ott 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 17 dic 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Bond & floating charge
    Creato il 12 nov 1997
    Consegnato il 19 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security
    Creato il 02 nov 1995
    Consegnato il 22 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Subjects at church street and queensgate, inverness....... See ch microfiche for full details.
    Persone aventi diritto
    • Scottish Homes
    Transazioni
    • 22 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 12 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 02 nov 1995
    Consegnato il 17 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £225,000 and all other sums due or to become due
    Brevi particolari
    Subjects at church street and queensgate, inverness comprising the nine flatted dwellinghouses to be erected....... See ch microfiche for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dunfermline Building Society
    Transazioni
    • 17 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 28 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 23 ott 1995
    Consegnato il 31 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £130,000 and all further sums due or to become due
    Brevi particolari
    37,39 & 43 culduthel park,inverness.
    Persone aventi diritto
    • Unfermline Building Society
    Transazioni
    • 31 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 28 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 28 set 1995
    Consegnato il 12 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 12 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 feb 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 13 giu 1995
    Consegnato il 23 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    0.279 ha at inshes wood,inverness.
    Persone aventi diritto
    • Scottish Homes
    Transazioni
    • 23 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 12 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 25 mag 1995
    Consegnato il 08 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £165,000 and all further sums due and that may become due
    Brevi particolari
    Inshes wood,inverness.
    Persone aventi diritto
    • Dunfermline Building Society
    Transazioni
    • 08 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 28 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 04 ott 1993
    Consegnato il 21 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Area of ground extending to 980 decimal or one thousandth parts of a hectare or thereby lying on or towards but not adjacent to the south east side of the public road from inverness to culloden moor in the county of inverness.
    Persone aventi diritto
    • Dunfermline Building Society
    Transazioni
    • 21 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 28 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 04 ott 1993
    Consegnato il 14 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    0.980 hectare lying on or towards but not adjecent to the south east side of the public road from inverness to culloden moor as relative to disposition ifo tulloch homes LTD dated 12TH aug & recorded 20TH oct 1992 (with exceptions).
    Persone aventi diritto
    • Scottish Homes
    Transazioni
    • 14 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 12 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 10 set 1993
    Consegnato il 17 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Ground extending to 0.261 ha lying to the north of kirkland avenure, ballingry, fife as relative to disposition in favour of trinity homes (scotland) limtied.
    Persone aventi diritto
    • Scottish Homes
    Transazioni
    • 17 set 1993Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 28 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 10 set 1993
    Consegnato il 17 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    0.261 hectare lying to the north of kirkland avenue, ballingry, fife as relative to disposition by dunfermline district council ifo the company dated 21ST june and recorded grs fife 29TH june both 1993.
    Persone aventi diritto
    • Dunfermline Building Society
    Transazioni
    • 17 set 1993Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 23 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0