LASER HOTELS THREE LIMITED

LASER HOTELS THREE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLASER HOTELS THREE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC141209
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LASER HOTELS THREE LIMITED?

    • Alberghi e simili strutture ricettive (55100) / Attività di alloggio e di ristorazione

    Dove si trova LASER HOTELS THREE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o HUDSON ADVISORS UK LIMITED
    First Floor, Quay 2
    139 Fountainbridge
    EH3 9QG Edinburgh
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LASER HOTELS THREE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MREF HOTELS THREE LIMITED07 feb 200707 feb 2007
    MACDONALD HOTELS (UK) LIMITED14 apr 199814 apr 1998
    MHL MANAGEMENT (NO.3) LIMITED12 nov 199212 nov 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di LASER HOTELS THREE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per LASER HOTELS THREE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Conto finale prima della dissoluzione in MVL (conto finale allegato)

    7 pagineLIQ13(Scot)

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 13 set 2019

    LRESSP

    Cessazione della carica di Vincent Frederic Marc Vernier come amministratore in data 08 lug 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Vincent Vernier come segretario in data 08 lug 2019

    1 pagineTM02

    Soddisfazione dell'onere 40 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere SC1412090041 in pieno

    1 pagineMR04

    Nomina di Mr Timothy Selwyn Jones come amministratore in data 13 dic 2018

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 nov 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Cessazione della carica di Robert Edward Gray come amministratore in data 24 ott 2018

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    19 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere SC1412090042 in pieno

    4 pagineMR04

    Cessazione della carica di John Brennan come amministratore in data 04 mag 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Michael Gallagher come amministratore in data 20 dic 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Darren William Guy come amministratore in data 20 dic 2017

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Vincent Vernier il 13 nov 2017

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 nov 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Cessazione della carica di Neal Morar come amministratore in data 03 ott 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Neal Morar come segretario in data 03 ott 2017

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Vincent Vernier come amministratore in data 06 ott 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Vincent Vernier come segretario in data 06 ott 2017

    2 pagineAP03

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    18 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Edward Gray il 01 nov 2016

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Neal Morar il 01 nov 2016

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Neal Morar il 01 nov 2016

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di LASER HOTELS THREE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GALLAGHER, Michael
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    IrelandIrishFinance Director243693110001
    JONES, Timothy Selwyn
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    United KingdomBritishAsset Manager226437520001
    BUSBY, James George William
    4 Murchison Road,Houston
    Bridge Of Weir
    PA6 7JU Renfrewshire
    Segretario
    4 Murchison Road,Houston
    Bridge Of Weir
    PA6 7JU Renfrewshire
    British584980003
    FRASER, Robert Gordon
    1 Glebe Court
    KA1 3BD Kilmarnock
    Ayrshire
    Segretario
    1 Glebe Court
    KA1 3BD Kilmarnock
    Ayrshire
    British120322350001
    GILLESPIE, Brendan
    56 Blairbeth Road
    Rutherglen
    G73 4JQ Glasgow
    Lanarkshire
    Segretario
    56 Blairbeth Road
    Rutherglen
    G73 4JQ Glasgow
    Lanarkshire
    British65199400001
    MORAR, Neal
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    Segretario
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    197427780001
    PALMER, Alan Charles
    7 Earlsgate
    Brierie Hills
    PA6 7FB Houston
    Renfrewshire
    Segretario
    7 Earlsgate
    Brierie Hills
    PA6 7FB Houston
    Renfrewshire
    British89601520001
    SANDERSON, Timothy Robin Llewelyn
    15 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8HA
    Segretario
    15 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8HA
    British69033180003
    VERNIER, Vincent
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    139 Fountainbridge
    EH3 9QG Edinburgh
    First Floor, Quay 2
    Segretario
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    139 Fountainbridge
    EH3 9QG Edinburgh
    First Floor, Quay 2
    239101540001
    ORR MACQUEEN W S
    36 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    Segretario
    36 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    39211930001
    BRENNAN, John
    Pembroke Road
    Ballsbridge
    146
    Dublin 4
    Ireland
    Amministratore
    Pembroke Road
    Ballsbridge
    146
    Dublin 4
    Ireland
    IrelandIrishChief Executive Officer211131960001
    BUSBY, James George William
    16 Fairyknowe Court
    Bothwell
    G71 8SZ Glasgow
    Amministratore
    16 Fairyknowe Court
    Bothwell
    G71 8SZ Glasgow
    United KingdomBritishDirector584980007
    CHRISTIE, Scott Sommervaille
    Gospatric House
    Bankhead Road Dalmeny
    EH30 9TT Edinburgh
    Amministratore
    Gospatric House
    Bankhead Road Dalmeny
    EH30 9TT Edinburgh
    ScotlandBritishDirector104262520001
    EDWARDS, Nicholas William John
    15 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8HA
    Amministratore
    15 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8HA
    EnglandBritishDirector166575000001
    FERGUSON DAVIE, Charles John
    15 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8HA
    Amministratore
    15 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8HA
    United KingdomBritishDirector159387570001
    FIGGE, Heiko
    15 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8HA
    Amministratore
    15 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8HA
    United KingdomBritishHotelier183639640001
    FRASER, Robert Gordon
    1 Glebe Court
    KA1 3BD Kilmarnock
    Ayrshire
    Amministratore
    1 Glebe Court
    KA1 3BD Kilmarnock
    Ayrshire
    United KingdomBritishDirector120322350001
    GILBARD, Marc Edward Charles
    15 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8HA
    Amministratore
    15 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8HA
    United KingdomBritishCompany Director29232300002
    GRAY, Robert Edward
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector188584900001
    GUILE, David Andrew
    5 Leaheath Way
    RG10 0TY Hurst
    Berkshire
    Amministratore
    5 Leaheath Way
    RG10 0TY Hurst
    Berkshire
    United KingdomBritishRegional M.D100133280001
    GUY, Darren
    Pembroke Road
    Ballsbridge
    146
    Dublin 4
    Ireland
    Amministratore
    Pembroke Road
    Ballsbridge
    146
    Dublin 4
    Ireland
    IrelandIrishDirector Of Finance294582970001
    HALL, Steven
    15 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8HA
    Amministratore
    15 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8HA
    United KingdomBritishDirector147752500001
    MACDONALD, Angus Donald Mackintosh
    18 Hermitage Drive
    EH10 6BZ Edinburgh
    Amministratore
    18 Hermitage Drive
    EH10 6BZ Edinburgh
    ScotlandBritishChartered Accountant43780001
    MACDONALD, Donald John
    Cardrona
    Glen Road
    FK15 0DT Dunblane
    Perthshire
    Amministratore
    Cardrona
    Glen Road
    FK15 0DT Dunblane
    Perthshire
    ScotlandBritishHotelier557590001
    MORAR, Neal
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director173110500001
    MURRAY, Rodger Grant
    36 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    36 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    Midlothian
    BritishSolicitor42591140001
    O'MALLEY, John
    132 Widney Manor Road
    B91 3JJ Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    132 Widney Manor Road
    B91 3JJ Solihull
    West Midlands
    BritishRegional M D84334340001
    ORR, Pauline Anne
    9 Saxe Coburg Street
    EH3 5BN Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    9 Saxe Coburg Street
    EH3 5BN Edinburgh
    Midlothian
    BritishSolicitor52526750005
    SIDWELL, Graham Robert
    15 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8HA
    Amministratore
    15 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8HA
    United KingdomBritishCompany Director72844280004
    SMITH, Gerard Henry
    Dallarich
    Caledonian Crescent
    PH3 1NG Gleneagles
    Perthshire
    Amministratore
    Dallarich
    Caledonian Crescent
    PH3 1NG Gleneagles
    Perthshire
    United KingdomBritishHotelier40871240003
    SMITH, Gerard Henry
    Dallarich
    Caledonian Crescent
    PH3 1NG Gleneagles
    Perthshire
    Amministratore
    Dallarich
    Caledonian Crescent
    PH3 1NG Gleneagles
    Perthshire
    United KingdomBritishHotelier40871240003
    STANLEY, Graham Bryan
    15 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8HA
    Amministratore
    15 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8HA
    United KingdomBritishCompany Director46112880007
    VERNIER, Vincent Frederic Marc
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    139 Fountainbridge
    EH3 9QG Edinburgh
    First Floor, Quay 2
    Amministratore
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    139 Fountainbridge
    EH3 9QG Edinburgh
    First Floor, Quay 2
    United KingdomFrenchDirector Portfolio Management185884890003

    Chi sono le persone con controllo significativo di LASER HOTELS THREE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    17 Dominion Street
    EC2M 2EF London
    C/O Hudson Advisors Uk Limited
    United Kingdom
    24 mag 2016
    17 Dominion Street
    EC2M 2EF London
    C/O Hudson Advisors Uk Limited
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione05893844
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    LASER HOTELS THREE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 18 feb 2015
    Consegnato il 26 feb 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    N/A.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Wells Fargo Bank, N.A., London Branch as Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 26 feb 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 21 giu 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 16 feb 2015
    Consegnato il 24 feb 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Wells Fargo Bank
    Transazioni
    • 24 feb 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 14 ago 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 20 ago 2010
    Consegnato il 03 set 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 set 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    • 14 ago 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 24 nov 2005
    Consegnato il 07 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal charge over the freehold property known as bank house, lake road, bowness-on-windermere CU84188.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 25 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 31 ott 2005
    Consegnato il 07 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Crutherland house hotel, strathaven road, east kilbride LAN42816.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 25 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 31 ott 2005
    Consegnato il 07 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Whiteside house, whiteside industrial estate, bathgate WLN9242.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 25 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 31 ott 2005
    Consegnato il 07 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Inchyra lodge, grange road, polmont, falkirk STG33156.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 25 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Floating charge
    Creato il 19 ott 2005
    Consegnato il 27 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transazioni
    • 27 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 23 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 19 ott 2005
    Consegnato il 27 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transazioni
    • 27 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 23 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 19 ott 2005
    Consegnato il 27 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All that freehold property known as botley park hotel, winchester road, boorley green, hants hp 370641 and hp 188618 see form 410 paper apart for further details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transazioni
    • 27 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 25 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Legal charge
    Creato il 19 ott 2005
    Consegnato il 27 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All that freehold property known as property known as kilhey court hotel, chorley road, standish, wigan gm 413206.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transazioni
    • 27 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 25 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Legal charge
    Creato il 22 ott 2003
    Consegnato il 27 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due under each of the relevant doucments
    Brevi particolari
    The freehold property known as the last drop hotel, haydock lane and 130, 132 and 134 hospital road, bromley cross, turton (title number GM235281).
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 26 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 05 set 2003
    Consegnato il 11 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Whiteside house, whiteside industrial estate, bathgate--title number WLN9242.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 set 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 26 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 05 set 2003
    Consegnato il 11 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Inchyra lodge, grange road, polmont, falkirk--title number stg 33156.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 set 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 26 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 05 set 2003
    Consegnato il 11 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Crutherland house hotel, strathaven road, east kilbride--title number LAN42816.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 set 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 26 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 03 set 2003
    Consegnato il 05 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Egerton house hotel, blackburn road, egerton--title number GM410176.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 set 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 26 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 03 set 2003
    Consegnato il 05 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Dunkenhalgh hotel, blackburn road, clayton le moors, hinburn--title number LA721713.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 set 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 26 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 03 set 2003
    Consegnato il 05 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The de monfort hotel, the square and abbey end, kenilworth--title number WK359414.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 set 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 26 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 03 set 2003
    Consegnato il 05 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Albrighton hall and the principals house, albrighton near shrewsbury, shropshire--title numbers SL9972 and SL9023.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 set 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 26 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 03 set 2003
    Consegnato il 05 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The bower hotel, hollingwood avenue, chadderton, greater manchester--title numbers GM826608 and GM826610.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 set 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 26 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 03 set 2003
    Consegnato il 05 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The buckatree hall hotel and farm cottage, ercall lane, wellington, telford, shropshire--title numbers SL92817 and SL16554.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 set 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 26 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 03 set 2003
    Consegnato il 05 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Ansty hall hotel and land st shilton ansty, coventry, warwickshire--title numbers WK312327 and WK370731.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 set 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 26 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 03 set 2003
    Consegnato il 05 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Botley park hotel and country club, winchester road, boorley green and the hawthorns, maddoxford lane, boorley green--title numbers HP370641 and HP188618.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 set 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 26 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 03 set 2003
    Consegnato il 05 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The tickled trout hotel, preston new road, samlesbury, lancashire--title number LA721705.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 set 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 26 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 03 set 2003
    Consegnato il 05 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Park house hotel, park street, shifnal, telford, shropshire--title number SL66539.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 set 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 26 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    LASER HOTELS THREE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    11 mag 2022Data prevista di scioglimento
    13 set 2019Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Notescottish-insolvency-info

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0