ROSYTH REGENERATION LIMITED

ROSYTH REGENERATION LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàROSYTH REGENERATION LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC152258
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ROSYTH REGENERATION LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova ROSYTH REGENERATION LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    MAZARS LLP
    90 St. Vincent Street
    G2 5UB Glasgow
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ROSYTH REGENERATION LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ROSYTH 2000 LIMITED23 set 199423 set 1994
    RANDOTTE (NO. 345) LIMITED02 ago 199402 ago 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di ROSYTH REGENERATION LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 feb 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per ROSYTH REGENERATION LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per ROSYTH REGENERATION LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Verbale della riunione finale di liquidazione volontaria

    3 pagine4.26(Scot)

    Indirizzo della sede legale modificato da * 93 George Street Edinburgh EH2 3ES* in data 26 set 2012

    2 pagineAD01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Bilancio annuale redatto al 02 ago 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 ago 2012

    Stato del capitale al 20 ago 2012

    • Capitale: GBP 1,000,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 29 feb 2012

    5 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2011

    4 pagineAA

    Nomina di Mr Simon Charles Mccabe come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Ivan Goldberg come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 02 ago 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    legacy

    4 pagineMG03s

    Bilancio annuale redatto al 02 ago 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Esplanade Director Limited il 02 ago 2010

    2 pagineCH02

    Dettagli del segretario cambiati per Esplanade Secretarial Services Limited il 02 ago 2010

    2 pagineCH04

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2010

    6 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * 4a Melville Street Edinburgh EH3 7NS United Kingdom* in data 15 mar 2010

    2 pagineAD01

    Bilancio redatto al 28 feb 2009

    13 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Ivan Anthony Goldberg il 01 ott 2009

    3 pagineCH01

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    3 pagine288a

    Bilancio redatto al 29 feb 2008

    14 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine190

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine353

    Chi sono gli amministratori di ROSYTH REGENERATION LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ESPLANADE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    England
    Segretario
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione6133270
    123430250001
    MCCABE, Simon Charles
    St. Vincent Street
    G2 5UB Glasgow
    90
    Amministratore
    St. Vincent Street
    G2 5UB Glasgow
    90
    EnglandBritishDevelopment Executive162929290001
    ESPLANADE DIRECTOR LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    England
    Amministratore
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione6133267
    123430390001
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Segretario
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    BritishDirector1267050001
    GREIG, John David Taylor
    29 Howe Street
    EH3 6TF Edinburgh
    Segretario
    29 Howe Street
    EH3 6TF Edinburgh
    OtherSolicitor51884660001
    KENNEDY, Andrew Patrick
    12 Torphin Bank
    Colinton
    EH13 0PH Edinburgh
    Midlothian
    Segretario
    12 Torphin Bank
    Colinton
    EH13 0PH Edinburgh
    Midlothian
    British591490002
    MCCABE, Sandra
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    The White House
    North Yorkshire
    Segretario
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    The White House
    North Yorkshire
    British920260005
    MEIKLEJOHN, Iain Maury Campbell
    14 Dalrymple Crescent
    EH9 2NX Edinburgh
    Segretario nominato
    14 Dalrymple Crescent
    EH9 2NX Edinburgh
    British900003350001
    TEESLAND SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    93 George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    Segretario
    93 George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    90707230001
    BATTY, David Stewart
    10 Bowling Green Road
    EH29 9BG Kirkliston
    West Lothian
    Amministratore
    10 Bowling Green Road
    EH29 9BG Kirkliston
    West Lothian
    United KingdomBritishCompany Director25024920003
    BERRY, Charles Andrew
    5 Grange Road
    Bearsden
    G61 3PL Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    5 Grange Road
    Bearsden
    G61 3PL Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritishExecutive Director Cust Sales109780690001
    CLARKE, David Michael
    2 Garyvard
    Main Street, Buchlyvie
    FK8 3LR Stirling
    Stirlingshire
    Amministratore
    2 Garyvard
    Main Street, Buchlyvie
    FK8 3LR Stirling
    Stirlingshire
    BritishMarketing Director Energy 7 Su68170950001
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Amministratore
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritishDirector1267050001
    EASTON, Murray Simpson
    7 Cromalt Crescent North Baljaffray
    Bearsden
    G61 4RX Glasgow
    Amministratore
    7 Cromalt Crescent North Baljaffray
    Bearsden
    G61 4RX Glasgow
    BritishDirector52962730001
    FLEMING, Alistair
    Mayfield 8 Erskine Road
    Giffnock
    G46 6TQ Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    Mayfield 8 Erskine Road
    Giffnock
    G46 6TQ Glasgow
    Lanarkshire
    BritishDirector1359650001
    GOLDBERG, Ivan Anthony
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Amministratore
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United KingdomBritishAccountant133676040001
    LANDELS, William Daniel
    41 Ayr Road
    Giffnock
    G46 6SD Glasgow
    Amministratore
    41 Ayr Road
    Giffnock
    G46 6SD Glasgow
    BritishManaging Director40909860001
    LINDSAY, Douglas Wallace
    60 Muirs
    KY13 8AU Kinross
    Perth & Kinross
    Amministratore
    60 Muirs
    KY13 8AU Kinross
    Perth & Kinross
    BritishCompany Director69982090001
    MACPHERSON, Alexander Allan
    Barns Khowe
    Old Sauchie Sauchieburn
    FK7 9QE Stirling
    Amministratore
    Barns Khowe
    Old Sauchie Sauchieburn
    FK7 9QE Stirling
    BritishProfessional Engineer40967800001
    MASTERTON, Gavin George
    6 Coldingham Place
    Garvock Hill
    KY12 7XS Dunfermline
    Fife
    Amministratore
    6 Coldingham Place
    Garvock Hill
    KY12 7XS Dunfermline
    Fife
    United KingdomBritishBanker663070001
    MAY, Christine Elizabeth Mary
    Cairngorm Crescent
    KY2 5RG Kirkcaldy
    27
    Fife
    Amministratore
    Cairngorm Crescent
    KY2 5RG Kirkcaldy
    27
    Fife
    ScotlandIrish,BritishCouncillor51665990001
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    BritishCompany Director109250000001
    MEIKLEJOHN, Iain Maury Campbell
    14 Dalrymple Crescent
    EH9 2NX Edinburgh
    Amministratore delegato nominato
    14 Dalrymple Crescent
    EH9 2NX Edinburgh
    British900003350001
    MORRISON, Alexander Charles
    Drum House
    Drum
    KY13 0UN Kinross
    Fife
    Amministratore
    Drum House
    Drum
    KY13 0UN Kinross
    Fife
    BritishPersonnel Director806880001
    REID, Robert Paul, Sir
    24 Ashley Gardens
    Ambrosden Avenue
    SW1P 1QD London
    Amministratore
    24 Ashley Gardens
    Ambrosden Avenue
    SW1P 1QD London
    EnglandBritishCo Chairman2507910001
    ROBERTSON, Ian
    5 Boswall Road
    EH5 3RH Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    5 Boswall Road
    EH5 3RH Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishBanker106197810002
    ROWLEY, Alexander Andrew Penman
    38 Mossgreen
    KY4 0AD Kelty
    Fife
    Amministratore
    38 Mossgreen
    KY4 0AD Kelty
    Fife
    ScotlandBritishCouncillor48317740001
    SAUNDERS, Stewart Henry
    Blaenwern 13 Dean Park Gardens
    Chapel
    KY2 6XX Kirkcaldy
    Fife
    Amministratore
    Blaenwern 13 Dean Park Gardens
    Chapel
    KY2 6XX Kirkcaldy
    Fife
    United KingdomBritishGeneral Manager70345950001
    SMITH, Allan Keppie
    The Forts
    Hawes Brae
    EH30 9TE South Queensferry
    West Lothian
    Amministratore
    The Forts
    Hawes Brae
    EH30 9TE South Queensferry
    West Lothian
    BritishExecutive Director160830001
    SMITH, Terence Patrick
    Old Market Garden
    10 Ettrick Grove
    EH10 5AW Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    Old Market Garden
    10 Ettrick Grove
    EH10 5AW Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritishQuantity Surveyor27223670007
    TAYLOR, William Gordon, Director
    Hayston Park
    Quarry Road
    KY16 0AN Balmullo
    Fife
    Amministratore
    Hayston Park
    Quarry Road
    KY16 0AN Balmullo
    Fife
    ScotlandBritishCorporate Manager96317990001
    THOMPSON, Hugh Macrae
    Fryern Barn
    Fryern Park
    RH20 4HG Storrington
    West Sussex
    Amministratore
    Fryern Barn
    Fryern Park
    RH20 4HG Storrington
    West Sussex
    BritishChief Executive4959050005
    TITTERTON, David George
    8 Ermelo Gardens
    Lindsayfield
    G75 East Kilbride
    Scotland
    Amministratore
    8 Ermelo Gardens
    Lindsayfield
    G75 East Kilbride
    Scotland
    BritishCompany Director60565540002
    WHYTE, Duncan
    4 Victoria Crescent
    G65 9BJ Kilsyth
    Lanarkshire
    Amministratore
    4 Victoria Crescent
    G65 9BJ Kilsyth
    Lanarkshire
    United KingdomBritishExecutive Director102248880001
    WILL, James Robert
    Myreside
    EH41 4JA Gifford
    East Lothian
    Amministratore delegato nominato
    Myreside
    EH41 4JA Gifford
    East Lothian
    ScotlandBritish900003650001

    ROSYTH REGENERATION LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Standard security
    Creato il 12 mar 2001
    Consegnato il 29 mar 2001
    In corso
    Importo garantito
    All sums due and that may become due under terms of bond and obligation
    Brevi particolari
    Area of ground forming the oilf fuel depot, east tip & st margarets marsh at rosyth, fife and extending to 71.789 hectares.
    Persone aventi diritto
    • The Secretary of State for Defence
    Transazioni
    • 29 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 12 mar 2001
    Consegnato il 29 mar 2001
    In corso
    Importo garantito
    £150,000
    Brevi particolari
    Area of ground forming the oil fuel depot, east tip & st maragrets marsh at rosyth, fife and extending to 71.789 hectares.
    Persone aventi diritto
    • The Secretary of State for Defence
    Transazioni
    • 29 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    Floating charge
    Creato il 16 feb 1998
    Consegnato il 03 mar 1998
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Secretary of State for Defence
    Transazioni
    • 03 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    Bond & floating charge
    Creato il 17 dic 1997
    Consegnato il 29 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The whole assets of the company.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 01 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)

    ROSYTH REGENERATION LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    24 set 2014Data di scioglimento
    13 set 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Tim Alan Askham
    The Lexicon Mount Street
    M2 5NT Manchester
    Praticante
    The Lexicon Mount Street
    M2 5NT Manchester
    Notescottish-insolvency-info

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0