John David Taylor GREIG
Persona fisica
Titolo | Mr |
---|---|
Nome | John |
Secondo nome | David Taylor |
Cognome | GREIG |
Data di nascita | |
È un dirigente societario | No |
Incarichi | |
Attivo | 0 |
Inattivo | 1 |
Dimesso | 35 |
Totale | 36 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH TREES SERVICES (UK) LIMITED | 30 giu 2014 | Sciolta | Consultant | Amministratore | South Croxted Road SE21 8AZ London 21 England | England | British | |
DEFENCE SCS LIMITED | 04 apr 2008 | 01 giu 2014 | Sciolta | Segretario | Devonport Royal Dockyard Devonport PL1 4SG Plymouth Devon | Other | ||
APPLEDORE SHIPBUILDERS (2004) LIMITED | 01 apr 2008 | 01 giu 2014 | Attiva | Company Secretary | Segretario | Devonport Royal Dockyard Devonport Plymouth Pl1 4sg | Other | |
DEVONPORT ROYAL DOCKYARD LIMITED | 01 apr 2008 | 01 giu 2014 | Attiva | Company Secretary | Segretario | Devonport Royal Dockyard Devonport PL1 4SG Plymouth | Other | |
BABCOCK MARINE (DEVONPORT) LIMITED | 01 apr 2008 | 01 giu 2014 | Attiva | Company Secretary | Segretario | C/O Devonport Royal Dockyard Ltd Devonport PL1 4SG Plymouth | Other | |
BABCOCK MARINE (ROSYTH) LIMITED | 24 gen 2008 | 01 giu 2014 | Attiva | Segretario | Rosyth KY11 2YD Dunfermline Rosyth Business Park Fife Scotland | Other | ||
FBM BABCOCK MARINE HOLDINGS (UK) LIMITED | 14 ott 2004 | 01 giu 2014 | Attiva | Segretario | Wigmore Street W1U 1QX London 33 | Other | ||
BNS PENSIONS LIMITED | 28 ago 2002 | 01 giu 2014 | Attiva | Company Secretary | Segretario | c/o Babcock International Group Rosyth KY11 2YD Dunfermline Rosyth Business Park Fife Scotland | Other | |
MARINE ENGINEERING & FABRICATIONS (HOLDINGS) LIMITED | 02 ago 2002 | 01 giu 2014 | Attiva | Segretario | Wigmore Street W1U 1QX London 33 | Other | ||
MARINE ENGINEERING & FABRICATIONS LIMITED | 02 ago 2002 | 01 giu 2014 | Attiva | Segretario | Wigmore Street W1U 1QX London 33 | Other | ||
BABCOCK MARINE (CLYDE) LIMITED | 07 ago 2001 | 01 giu 2014 | Attiva | Co Secretary | Segretario | Rosyth KY11 2YD Dunfermline Rosyth Business Park Fife | Other | |
BABCOCK MANAGEMENT 2019 LIMITED | 06 mar 2001 | 01 giu 2014 | Attiva | Segretario | Wigmore Street W1U 1QX London 33 | Other | ||
FBM BABCOCK MARINE LIMITED | 03 nov 2000 | 01 giu 2014 | Attiva | Segretario | Wigmore Street W1U 1QX London 33 | Other | ||
FBV DESIGNS LIMITED | 21 giu 2000 | 01 giu 2014 | Sciolta | Segretario | Wigmore Street W1U 1QX London 33 | Other | ||
BABCOCK DEFENCE SYSTEMS LIMITED | 16 mag 2000 | 01 giu 2014 | Attiva | Segretario | Wigmore Street W1U 1QX London 33 | Other | ||
ROSYTH ROYAL DOCKYARD LIMITED | 28 apr 2000 | 01 giu 2014 | Attiva | Segretario | c/o Babcock International Rosyth KY11 2YD Dunfermline Rosyth Business Park Fife Scotland | Other | ||
ARMSTRONG TECHNOLOGY ASSOCIATES LIMITED | 27 gen 2000 | 01 giu 2014 | Attiva | Segretario | Wigmore Street W1U 1QX London 33 | Other | ||
BABCOCK DS 2019 LIMITED | 01 apr 1997 | 01 giu 2014 | Attiva | Company Secretary | Segretario | Wigmore Street W1U 1QX London 33 | Other | |
BABCOCK DESIGN & TECHNOLOGY LIMITED | 10 mar 1997 | 01 giu 2014 | Attiva | Segretario | Rosyth Business Park Rosyth KY11 2YD Dunfermline Fife | Other | ||
PORT BABCOCK ROSYTH LIMITED | 10 mar 1997 | 01 giu 2014 | Attiva | Segretario | Rosyth Business Park Rosyth KY11 2YD Dunfermline Fife | Other | ||
ROSYTH ROYAL DOCKYARD PENSION TRUSTEES LIMITED | 28 feb 2001 | 15 mar 2013 | Attiva | Solicitor | Amministratore | c/o C/O Babcock International Group Rosyth KY11 2YD Dunfermline Rosyth Business Park Fife | England | British |
BNS PENSION TRUSTEES LIMITED | 21 giu 1999 | 01 mag 2012 | Attiva | Segretario | c/o Babcock International Group Rosyth KY11 2YD Dunfermline Rosyth Business Park Fife Scotland | Other | ||
ROSYTH ROYAL DOCKYARD PENSION TRUSTEES LIMITED | 31 mag 2000 | 01 ago 2011 | Attiva | Segretario | c/o C/O Babcock International Group Rosyth KY11 2YD Dunfermline Rosyth Business Park Fife | Other | ||
BABCOCK SUPPORT SERVICES LIMITED | 28 apr 2000 | 03 giu 2011 | Attiva | Segretario | Dalmore House 310 St Vincent Street G2 5QR Glasgow C/O Biggart Baillie Llp Scotland Scotland | Other | ||
FMA SERVICES LIMITED | 17 mag 2006 | 15 mag 2009 | Sciolta | Segretario | 29 Howe Street EH3 6TF Edinburgh | Other | ||
AIR POWER INTERNATIONAL LIMITED | 29 gen 2001 | 14 apr 2009 | Sciolta | Company Secretary | Segretario | 29 Howe Street EH3 6TF Edinburgh | Other | |
BABCOCK AIRPORTS LIMITED | 17 mag 2006 | 16 gen 2009 | Attiva | Segretario | 29 Howe Street EH3 6TF Edinburgh | Other | ||
BABCOCK SERVICES GROUP LIMITED | 17 mag 2006 | 16 gen 2009 | Attiva | Segretario | 29 Howe Street EH3 6TF Edinburgh | Other | ||
ALSTEC AUTOMATION LIMITED | 17 mag 2006 | 16 gen 2009 | Sciolta | Segretario | 29 Howe Street EH3 6TF Edinburgh | Other | ||
ALSTEC DEFENCE LIMITED | 17 mag 2006 | 16 gen 2009 | Sciolta | Segretario | 29 Howe Street EH3 6TF Edinburgh | Other | ||
CAVENDISH NUCLEAR LIMITED | 17 mag 2006 | 16 gen 2009 | Attiva | Segretario | 29 Howe Street EH3 6TF Edinburgh | Other | ||
BABCOCK POWER MAINTENANCE LIMITED | 17 mag 2006 | 16 gen 2009 | Sciolta | Segretario | 29 Howe Street EH3 6TF Edinburgh | Other | ||
CMR CONSULTANTS LIMITED | 10 feb 2000 | 01 mar 2004 | Attiva | Solicitor | Segretario | 29 Howe Street EH3 6TF Edinburgh | Other | |
ENER-G SERVICES CO LIMITED | 10 feb 2000 | 01 mar 2004 | Sciolta | Solicitor | Segretario | 29 Howe Street EH3 6TF Edinburgh | Other | |
ROSYTH REGENERATION LIMITED | 11 ago 1997 | 10 apr 2002 | Sciolta | Solicitor | Segretario | 29 Howe Street EH3 6TF Edinburgh | Other |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0