GOALS SOCCER CENTRES PLC

GOALS SOCCER CENTRES PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGOALS SOCCER CENTRES PLC
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società SC202545
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di GOALS SOCCER CENTRES PLC?

    • Gestione di impianti sportivi (93110) / Attività artistiche, sportive e di divertimento

    Dove si trova GOALS SOCCER CENTRES PLC?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Dla Piper Scotland Llp Collins House
    Rutland Square
    EH1 2AA Edinburgh
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GOALS SOCCER CENTRES PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GOALS SOCCER CENTRES LIMITED12 feb 200112 feb 2001
    FORTIS LEISURE LIMITED14 gen 200014 gen 2000
    DMWS 389 LIMITED21 dic 199921 dic 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di GOALS SOCCER CENTRES PLC?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2018
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 giu 2019
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per GOALS SOCCER CENTRES PLC?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al29 nov 2019
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma13 dic 2019
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al29 nov 2018
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per GOALS SOCCER CENTRES PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore

    31 pagineAM10(Scot)

    Ordinanza del tribunale in una liquidazione (e allegato dell'ordinanza del tribunale)

    5 pagineWU01(Scot)

    Avviso di proroga del periodo di amministrazione

    3 pagineAM19(Scot)

    Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore

    37 pagineAM10(Scot)

    Nomina di un amministratore sostitutivo o aggiuntivo

    3 pagineAM11(Scot)

    Ordinanza di revoca dell'amministratore dall'incarico

    4 pagineAM16(Scot)

    Ordinanza di revoca dell'amministratore dall'incarico

    4 pagineAM16(Scot)

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Teneo Financial Advisory Limited 100 West George Street Glasgow Scotland G2 1PJ a C/O Dla Piper Scotland Llp Collins House Rutland Square Edinburgh EH1 2AA in data 02 nov 2023

    2 pagineAD01

    Avviso di proroga del periodo di amministrazione

    3 pagineAM19(Scot)

    Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore

    20 pagineAM10(Scot)

    Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore

    20 pagineAM10(Scot)

    Avviso di proroga del periodo di amministrazione

    3 pagineAM19(Scot)

    Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore

    19 pagineAM10(Scot)

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Teneo Restructuring Limited 100 West George Street Glasgow Scotland G2 1PJ a C/O Teneo Financial Advisory Limited 100 West George Street Glasgow Scotland G2 1PJ in data 23 feb 2022

    2 pagineAD01

    Avviso di proroga del periodo di amministrazione

    4 pagineAM19(Scot)

    Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore

    20 pagineAM10(Scot)

    Avviso di proroga del periodo di amministrazione

    3 pagineAM19(Scot)

    Indirizzo della sede legale modificato da 100 West Geogre Street Glasgow G2 1PJ Scotland a C/O Teneo Restructuring Limited 100 West George Street Glasgow Scotland G2 1PJ in data 02 set 2021

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2DB a 100 West Geogre Street Glasgow G2 1PJ in data 28 giu 2021

    2 pagineAD01

    Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore

    19 pagineAM10(Scot)

    Ordinanza di revoca dell'amministratore dall'incarico

    9 pagineAM16(Scot)

    Nomina di un amministratore sostitutivo o aggiuntivo

    3 pagineAM11(Scot)

    Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore

    16 pagineAM10(Scot)

    Avviso di proroga del periodo di amministrazione

    3 pagineAM19(Scot)

    Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore

    19 pagineAM10(Scot)

    Chi sono gli amministratori di GOALS SOCCER CENTRES PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GOW, William Berrie Gordon
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    Segretario
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    British74161570001
    PARK, Louise Emily
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    Saltire Court
    Segretario
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    Saltire Court
    254376660001
    ROGERS, Keith Taylor
    Over Lethame House
    ML10 6RW Strathaven
    Lanarkshire
    Segretario
    Over Lethame House
    ML10 6RW Strathaven
    Lanarkshire
    British67066370003
    DM COMPANY SERVICES LIMITED
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    Segretario nominato
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    900000320001
    LYCIDAS SECRETARIES LIMITED
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    Segretario nominato
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    900003290001
    ANSON, Andrew Edward
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    Amministratore
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    United KingdomBritishChief Executive245777290001
    BASING, Nicolas Andrew
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    Amministratore
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    EnglandBritishChairman183640000001
    BOLINGBROKE, Michael
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    Saltire Court
    Amministratore
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    Saltire Court
    EnglandBritishNon Executive209626860001
    BRUCE, Roderick Lawrence
    Campend Farmhouse
    Campend Farm
    EH22 1RS Dalkeith
    Midlothian
    Amministratore delegato nominato
    Campend Farmhouse
    Campend Farm
    EH22 1RS Dalkeith
    Midlothian
    British900018790001
    BURKS, Philip Adrian
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    Amministratore
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    United KingdomBritishNon Executove Director146669160001
    EDELMAN, Keith Graeme
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    Amministratore
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    EnglandBritishCompany Director143145410001
    GOW, William Berrie Gordon
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    Amministratore
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    United KingdomBritishAccountant74161570001
    HAND, Alan Michael
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    Saltire Court
    Amministratore
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    Saltire Court
    EnglandIrishDirector254880700001
    JONES, Mark Vincent
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    Amministratore
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    EnglandBritishChief Executive107650230003
    KIRKPATRICK, Stephen
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    Saltire Court
    Amministratore
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    Saltire Court
    United KingdomBritishDirector129442070001
    LLOYD, Scott Anthony
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    Amministratore
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    United KingdomBritishCompany Director65590160004
    MIDDLETON, Shaun Norman Skene
    19 Queens Crescent
    EH9 2BB Edinburgh
    Amministratore
    19 Queens Crescent
    EH9 2BB Edinburgh
    United KingdomBritishInvestment Manager72074940002
    MILLS, Christopher Harwood Bernard
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    Saltire Court
    Amministratore
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    Saltire Court
    EnglandBritishInvestment Manager201205110001
    MINTO, Bruce Watson
    The Avenue 40 Greenhill Gardens
    EH10 4BJ Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    The Avenue 40 Greenhill Gardens
    EH10 4BJ Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishSolicitor36629160003
    PAYTON, Morris Iain
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    Amministratore
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    ScotlandBritishCompany Director152257760001
    ROGERS, John
    2 Maple Avenue
    Stenhousemuir
    FK5 4BT Larbert
    Stirlingshire
    Amministratore
    2 Maple Avenue
    Stenhousemuir
    FK5 4BT Larbert
    Stirlingshire
    BritishDirector69404460001
    ROGERS, Keith Taylor
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    Amministratore
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    ScotlandBritishCompany Director67066370003
    RONSON, Jacqueline Ann
    Redwood Crescent
    East Kilbride
    G74 5PA Glasgow
    Goals Soccer Centres Plc
    Scotland
    Amministratore
    Redwood Crescent
    East Kilbride
    G74 5PA Glasgow
    Goals Soccer Centres Plc
    Scotland
    United KingdomBritishDigital, Crm & Insights Director115470920003
    SCOULER, Brian Buchanan
    31 Cramond Road North
    EH4 6LY Edinburgh
    Amministratore
    31 Cramond Road North
    EH4 6LY Edinburgh
    ScotlandBritishInvestment Banker35968050002
    SHORT, Alexander Brian Cooper
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    Amministratore
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    ScotlandBritishFinance Director91254170004
    WALKER, Rodney Myerscough, Sir
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    Amministratore
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    EnglandBritishDirector56514100001
    WILSON, Robert Graham
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    Amministratore
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    United KingdomBritishDirector6564660002

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per GOALS SOCCER CENTRES PLC?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    29 nov 2016La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    GOALS SOCCER CENTRES PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 29 nov 2016
    Consegnato il 06 dic 2016
    In corso
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC in Its Capacity as Security Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 06 dic 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 26 apr 2016
    Consegnato il 05 mag 2016
    In corso
    Breve descrizione
    Leasehold property known as land at high gosforth park, newcastle upon tyne registered at H.M. land registry under title number TY476459.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 mag 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 18 set 2014
    Consegnato il 23 set 2014
    In corso
    Breve descrizione
    The golf course land at redcote lane, kirkstall, leeds forming part of the landlord’s freehold title registered at H. M. land registry with absolute title under title number WYK819547, as more particularly described in the lease between (1) ogden waller limited (in administration); (2) k l dukes, I d green & d j kelly; and (3) goals soccer centres PLC.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 23 set 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 18 set 2014
    Consegnato il 23 set 2014
    In corso
    Breve descrizione
    The land at goals soccer centre, redcote lane, kirkstall, leeds forming part of the landlord’s freehold title registered at H. M. land registry with absolute title under title number WYK819547, as more particularly described in the lease between (1) ogden waller limited (in administration); (2) k l dukes, I d green & d j kelly; and (3) goals soccer centres PLC.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 23 set 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 28 nov 2013
    Consegnato il 04 dic 2013
    In corso
    Breve descrizione
    1. by way of legal mortgage the leasehold land and buildings at wheatley hall road, doncaster forming part of the landlord's freehold title registered at hm land registry with absolute title under title number SYK446882 and SYK598925 as more particularly described in a lease dated 8 april 2013 between (1) st modwen ventures limited and (2) goals soccer centres PLC and now registered with absolute title under title number SYK607111 ("the property") together with all present and future buildings and fixtures (including trade and tenant's fixtures) which are at any time on or attached to the property;. 2. by way of fixed charge any goodwill relating to the property or the business or undertaking conducted at the property;. 3. by way of fixed charge all plant, machinery and other items attached to and forming part of the property on or at any time after the date of the charge;. 4. by way of assignment the rents, profits, income, fees and other sums at any time payable by any lessees, underlessees, tenants or licensees of the property to the owner pursuant to the terms of any agreements for lease, leases, underleases, tenancies or licences to which all or any part of the property is subject but not any sums payable in respect of services provided to such lessees, underlessees, tenant or licensees or payable in respect of insurance premiums or reasonable professional fees or expenses together with the benefit of all rights and remedies of the borrower relating to them to the bank absolutely subject to redemption upon repayment of the secured liabilities. 5. by way of fixed charge all rights and interests in and claims made under any insurance policy relating to any of the property charged under the charge; and. 6. by way of floating charge all unattached plant, machinery, chattels and goods now or at any time after the date of the charge on or in or used in connection with the property or the business or undertaking conducted and the property. Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 04 dic 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 04 ott 2013
    Consegnato il 18 ott 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 18 ott 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 04 ott 2013
    Consegnato il 18 ott 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 18 ott 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Legal charge
    Creato il 19 feb 2013
    Consegnato il 21 feb 2013
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Leasehold land and buildings known as land at queens road cheetham hill manchester GM934832.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 feb 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    Legal charge
    Creato il 03 mag 2012
    Consegnato il 05 mag 2012
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Chester commerce park bumpers lane chester CH555723.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 mag 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    Legal charge
    Creato il 15 feb 2012
    Consegnato il 21 feb 2012
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Leasehold property known as land and buildings at durham road sunderland tyne & wear.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 feb 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    Legal charge
    Creato il 03 feb 2012
    Consegnato il 07 feb 2012
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Leasehold land and premises at rope walk ipswich suffolk SK240769.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 feb 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    Legal charge
    Creato il 01 dic 2011
    Consegnato il 19 dic 2011
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over land and buildings at crown hill community college, gwendolen road, leicester LT439826.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 19 dic 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    Legal charge
    Creato il 14 ott 2011
    Consegnato il 18 ott 2011
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Land and buildings at crown hill community college gwendolen road leicester LT3998370.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 18 ott 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    Legal charge
    Creato il 12 set 2011
    Consegnato il 14 set 2011
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Land at abbeyfields school, northampton.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 set 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    Legal charge
    Creato il 08 ago 2011
    Consegnato il 13 ago 2011
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Leasehold property known as tangiers road portsmouth 1) portsmouth college and 2)goals soccer centres PLC PM16644.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 ago 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    Standard security
    Creato il 02 mag 2011
    Consegnato il 17 mag 2011
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Premises forming all and whole the area of ground to the north of great southern road aberdeen knc 21413.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 17 mag 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    Legal charge
    Creato il 05 apr 2011
    Consegnato il 07 apr 2011
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Leasehold land known as hewett school cecil road norwich NK402587.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 apr 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    Legal charge
    Creato il 25 gen 2011
    Consegnato il 26 gen 2011
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Leasehold land and buildings at site a ipark innovation road hull.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 26 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    Legal charge
    Creato il 18 nov 2010
    Consegnato il 20 nov 2010
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Land and buildings at syon lane, osterley.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 20 nov 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    Legal charge
    Creato il 05 ott 2010
    Consegnato il 06 ott 2010
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Bushey middle school playing fields beverley way west wimbledon london.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 06 ott 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    Legal charge
    Creato il 01 ott 2010
    Consegnato il 05 ott 2010
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Leasehold property known as land on the north side of speke boulevard liverpool MS575526.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 ott 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    Legal charge
    Creato il 23 lug 2010
    Consegnato il 03 ago 2010
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Leasehold property known as land and buildings on the south side of ironmould lane brislington BL110763.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    Legal charge
    Creato il 14 gen 2010
    Consegnato il 16 gen 2010
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Leasehold property known as land situate at hanson school sutton avenue bradford.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 16 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    Legal charge
    Creato il 02 dic 2009
    Consegnato il 08 dic 2009
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Premises at granville road sheffield.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    Legal charge
    Creato il 27 ott 2009
    Consegnato il 16 nov 2009
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Land at bulmershe school, woodley.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 16 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01s)

    GOALS SOCCER CENTRES PLC ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    31 ott 2019Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Gavin George Scott Park
    110 Queen Street
    G1 3BX Glasgow
    Praticante
    110 Queen Street
    G1 3BX Glasgow
    Robert James Harding
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Praticante
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Michael John Magnay
    Saltire Court 20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    Praticante
    Saltire Court 20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    Stephen Hunt
    Griffins, Tavistock House North Tavistock Square
    WC1H 9HR London
    Praticante
    Griffins, Tavistock House North Tavistock Square
    WC1H 9HR London
    2
    DataTipo
    13 giu 2024Data della petizione
    13 giu 2024Inizio della liquidazione
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Stephen Hunt
    Griffins, Tavistock House North Tavistock Square
    WC1H 9HR London
    Praticante
    Griffins, Tavistock House North Tavistock Square
    WC1H 9HR London
    Notescottish-insolvency-info

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0