MIDLANDS COMPANY SERVICES LIMITED - Pagina 4
Dirigente societario
Nome | MIDLANDS COMPANY SERVICES LIMITED |
---|---|
È un dirigente societario | Sì |
Incarichi | |
Attivo | 0 |
Inattivo | 0 |
Dimesso | 145 |
Totale | 145 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Ruolo | Indirizzo |
---|---|---|---|---|---|
HYPERJAM LIMITED | 15 ott 1997 | 15 ott 1997 | Sciolta | Segretario | Suite 116 Lonsdale House 52 Blucher Street B1 1QU Birmingham |
DIRECT PENSIONS LIMITED | 08 ott 1997 | 08 ott 1997 | Sciolta | Segretario | Suite 116 Lonsdale House 52 Blucher Street B1 1QU Birmingham |
SPENCERS CLEANING LIMITED | 16 set 1997 | 16 set 1997 | Sciolta | Segretario | Suite 116 Lonsdale House 52 Blucher Street B1 1QU Birmingham |
SENSATIONS HOLDINGS LIMITED | 12 set 1997 | 12 set 1997 | Attiva | Segretario | Suite 116 Lonsdale House 52 Blucher Street B1 1QU Birmingham |
ANCA TAPES LIMITED | 14 ago 1997 | 14 ago 1997 | Attiva | Segretario | Suite 116 Lonsdale House 52 Blucher Street B1 1QU Birmingham |
REVILL COMPUTER SYSTEMS LIMITED | 14 ago 1997 | 14 ago 1997 | Sciolta | Segretario | Suite 116 Lonsdale House 52 Blucher Street B1 1QU Birmingham |
M.P. ASHWIN LIMITED | 07 ago 1997 | 07 ago 1997 | Sciolta | Segretario | Suite 116 Lonsdale House 52 Blucher Street B1 1QU Birmingham |
PINNACLE HEATING SERVICES LIMITED | 22 lug 1997 | 22 lug 1997 | Sciolta | Segretario | Suite 116 Lonsdale House 52 Blucher Street B1 1QU Birmingham |
SHEPPARD LIMITED | 21 lug 1997 | 22 lug 1997 | Sciolta | Segretario | Suite 116 Lonsdale House 52 Blucher Street B1 1QU Birmingham |
SWISHCOM LTD. | 08 lug 1997 | 08 lug 1997 | Sciolta | Segretario | Suite 116 Lonsdale House 52 Blucher Street B1 1QU Birmingham |
CENTRAL UTILITY SERVICES LIMITED | 01 lug 1997 | 01 lug 1997 | Sciolta | Segretario | Suite 116 Lonsdale House 52 Blucher Street B1 1QU Birmingham |
CASCADE UPHOLSTERY LIMITED | 01 lug 1997 | 01 lug 1997 | Sciolta | Segretario | Suite 116 Lonsdale House 52 Blucher Street B1 1QU Birmingham |
ANDREWS ELECTRICAL LIMITED | 26 giu 1997 | 26 giu 1997 | Attiva | Segretario | Suite 116 Lonsdale House 52 Blucher Street B1 1QU Birmingham |
MILLENIUM COMMERCIAL LIMITED | 20 feb 1997 | 24 giu 1997 | Sciolta | Segretario | Suite 116 Lonsdale House 52 Blucher Street B1 1QU Birmingham |
PENN-ONLINE LIMITED | 20 giu 1997 | 20 giu 1997 | Sciolta | Segretario | Suite 116 Lonsdale House 52 Blucher Street B1 1QU Birmingham |
THE OFFICE SHOP LIMITED | 20 giu 1997 | 20 giu 1997 | Sciolta | Segretario | Suite 116 Lonsdale House 52 Blucher Street B1 1QU Birmingham |
DIRECT SPECS LIMITED | 21 mag 1997 | 21 mag 1997 | Attiva | Segretario | Suite 116 Lonsdale House 52 Blucher Street B1 1QU Birmingham |
THE REASONABLE PRICES COMPANY LIMITED | 21 mag 1997 | 21 mag 1997 | Sciolta | Segretario | Suite 116 Lonsdale House 52 Blucher Street B1 1QU Birmingham |
PEGASUS GLOBAL SOLUTIONS LIMITED | 28 apr 1997 | 29 apr 1997 | Sciolta | Segretario | Suite 116 Lonsdale House 52 Blucher Street B1 1QU Birmingham |
WOLVERHAMPTON TRUCK REPAIRS LIMITED | 22 apr 1997 | 24 apr 1997 | Sciolta | Segretario | Suite 116 Lonsdale House 52 Blucher Street B1 1QU Birmingham |
HALDON ASSOCIATES LIMITED | 24 feb 1997 | 11 apr 1997 | Attiva | Segretario | Suite 116 Lonsdale House 52 Blucher Street B1 1QU Birmingham |
RAINBOW SIGNS AND GRAPHICS LIMITED | 11 mar 1997 | 12 mar 1997 | Attiva | Segretario | Suite 116 Lonsdale House 52 Blucher Street B1 1QU Birmingham |
PAGEWORKS LIMITED | 27 feb 1997 | 28 feb 1997 | Attiva | Segretario | Suite 116 Lonsdale House 52 Blucher Street B1 1QU Birmingham |
GALLAGHERS LIMITED | 13 feb 1997 | 17 feb 1997 | Sciolta | Segretario | Suite 116 Lonsdale House 52 Blucher Street B1 1QU Birmingham |
GENERAL COMMERCIAL TRADING COMPANY LIMITED | 30 gen 1997 | 12 feb 1997 | Sciolta | Segretario | Suite 116 Lonsdale House 52 Blucher Street B1 1QU Birmingham |
THE CARE BUREAU LIMITED | 16 gen 1997 | 21 gen 1997 | Attiva | Segretario | Suite 116 Lonsdale House 52 Blucher Street B1 1QU Birmingham |
MISKIN LIMITED | 18 nov 1996 | 19 nov 1996 | Sciolta | Segretario | Suite 116 Lonsdale House 52 Blucher Street B1 1QU Birmingham |
P. D. H. PROPERTY SERVICES LIMITED | 18 nov 1996 | 19 nov 1996 | Sciolta | Segretario | Suite 116 Lonsdale House 52 Blucher Street B1 1QU Birmingham |
PRINT & MAILING LIMITED | 12 nov 1996 | 13 nov 1996 | Sciolta | Segretario | Suite 116 Lonsdale House 52 Blucher Street B1 1QU Birmingham |
BELMOUNT INVESTMENTS LIMITED | 17 ott 1996 | 18 ott 1996 | Sciolta | Segretario | Suite 116 Lonsdale House 52 Blucher Street B1 1QU Birmingham |
GRANT RESEARCH LIMITED | 16 ott 1996 | 16 ott 1996 | Attiva | Segretario | Suite 116 Lonsdale House 52 Blucher Street B1 1QU Birmingham |
FORTY-TWO TRUSTEES LIMITED | 02 ott 1996 | 04 ott 1996 | Sciolta | Segretario | Suite 116 Lonsdale House 52 Blucher Street B1 1QU Birmingham |
MAYFLOWER CONTROL LIMITED | 05 set 1996 | 09 set 1996 | Attiva | Segretario | Suite 116 Lonsdale House 52 Blucher Street B1 1QU Birmingham |
HOMEBASED CARE (UK) LIMITED | 27 ago 1996 | 28 ago 1996 | Sciolta | Segretario | Suite 116 Lonsdale House 52 Blucher Street B1 1QU Birmingham |
GREVAN ESTATES LIMITED | 23 lug 1996 | 26 lug 1996 | Sciolta | Segretario | Suite 116 Lonsdale House 52 Blucher Street B1 1QU Birmingham |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0