PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED - Pagina 7
Dirigente societario
Nome | PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED |
---|---|
È un dirigente societario | Sì |
Incarichi | |
Attivo | 0 |
Inattivo | 0 |
Dimesso | 281 |
Totale | 281 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Ruolo | Indirizzo |
---|---|---|---|---|---|
THE DAVID SCHEME LIMITED | 04 feb 1997 | 27 mar 1997 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds |
GERAUD (UK) LIMITED | 21 gen 1997 | 27 mar 1997 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds |
ROCKSTAR GAMES UK LIMITED | 04 feb 1997 | 26 mar 1997 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds |
POOLEND COURTYARD MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 20 ago 1996 | 25 mar 1997 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds |
I.M. PROPERTIES DEVELOPMENT LIMITED | 04 feb 1997 | 11 mar 1997 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds |
FILTERMIST HOLDINGS LIMITED | 04 feb 1997 | 10 mar 1997 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds |
W WING YIP (MANCHESTER PROPERTIES) LIMITED | 12 dic 1996 | 05 mar 1997 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds |
CHASE MIDLAND VCT LIMITED | 26 feb 1997 | 03 mar 1997 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds |
VANDERLANDE INDUSTRIES UNITED KINGDOM LIMITED | 02 gen 1997 | 28 feb 1997 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds |
ROTHMERE LIMITED | 25 nov 1996 | 28 feb 1997 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds |
BRITISH JEFFREY DIAMOND 100 LIMITED | 15 ott 1996 | 20 feb 1997 | Liquidazione | Amministratore delegato nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds |
CARRS PAINTS LIMITED | 25 nov 1996 | 17 feb 1997 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds |
BE AVIATION LTD | 21 gen 1997 | 10 feb 1997 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds |
ALBION PRIME VCT PLC | 14 ott 1996 | 04 feb 1997 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds |
VEOLIA ES LAMBETH LIMITED | 12 dic 1996 | 30 gen 1997 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds |
THE FUEL CARD GROUP LIMITED | 02 gen 1997 | 29 gen 1997 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds |
ROM GROUP LIMITED | 12 dic 1996 | 22 gen 1997 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds |
TARMAC TOPFLOOR LIMITED | 30 lug 1996 | 31 dic 1996 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds |
TARMAC MASONRY PRODUCTS LIMITED | 30 lug 1996 | 31 dic 1996 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds |
TARMAC TOPBLOCK LIMITED | 12 lug 1996 | 31 dic 1996 | Liquidazione | Amministratore delegato nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds |
TARMAC PRECAST CONCRETE LIMITED | 12 lug 1996 | 31 dic 1996 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds |
INTEROTEX LIMITED | 02 mag 1996 | 23 dic 1996 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds |
IMI GROUP SERVICES LIMITED | 12 nov 1996 | 20 dic 1996 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds |
LAND REGENERATION MANAGEMENT LIMITED | 09 ott 1996 | 20 dic 1996 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds |
NEWMOND EMPLOYEES TRUSTEES LIMITED | 25 nov 1996 | 18 dic 1996 | Liquidazione | Amministratore delegato nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds |
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT (UK) LIMITED | 22 ago 1996 | 06 dic 1996 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds |
RSA SANTON LIMITED | 25 nov 1996 | 02 dic 1996 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds |
NEWMOND (NUMBER 7) LIMITED | 25 nov 1996 | 02 dic 1996 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds |
SYNIGENCE PLC | 17 ott 1996 | 02 dic 1996 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds |
EES CAPITAL TRUSTEES LIMITED | 08 nov 1996 | 29 nov 1996 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds |
LAMPHOLDER 2000 LTD | 18 nov 1996 | 27 nov 1996 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds |
G&K SMART DEVELOPMENTS VCT LIMITED | 12 nov 1996 | 18 nov 1996 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds |
OMC INTERNATIONAL (FINE FABRICS) LIMITED | 03 ott 1996 | 11 nov 1996 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds |
MIMOSA FINANCE LTD | 28 ago 1996 | 11 nov 1996 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds |
TRUCKHAVEN LTD. | 05 nov 1996 | 07 nov 1996 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0