David FLINT
Persona fisica
| Titolo | |
|---|---|
| Nome | David |
| Cognome | FLINT |
| È un dirigente societario | No |
| Incarichi | |
| Attivo | 2 |
| Inattivo | 0 |
| Dimesso | 231 |
| Totale | 233 |
Incarichi
| Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W.J.HARTE (CITY) LIMITED | 17 mag 1988 | In amministrazione controllata | Segretario nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | |||
| W.J.HARTE (CITY) LIMITED | 17 mag 1988 | In amministrazione controllata | Amministratore delegato nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | |||
| CLYDE MATERIALS HANDLING LIMITED | 05 set 1996 | 28 lug 2000 | Sciolta | Segretario nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
| CLYDE MATERIALS HANDLING LIMITED | 05 set 1996 | 28 lug 2000 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
| GRAMPIAN OAT PRODUCTS LIMITED | 04 lug 1997 | 04 lug 1998 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
| HUNA DEVELOPMENT LIMITED | 21 mar 1997 | 28 nov 1997 | Attiva | Segretario nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
| HUNA DEVELOPMENT LIMITED | 21 mar 1997 | 28 nov 1997 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
| INVERNESS AIR TERMINAL LIMITED | 23 gen 1997 | 21 nov 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
| INVERNESS AIR TERMINAL LIMITED | 23 gen 1997 | 21 nov 1997 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
| MACROCOM (422) LIMITED | 28 mag 1997 | 22 set 1997 | Liquidazione | Amministratore delegato nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
| MACROCOM (422) LIMITED | 28 mag 1997 | 22 set 1997 | Liquidazione | Segretario nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
| EMPACE LIMITED | 09 giu 1997 | 09 set 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
| EMPACE LIMITED | 09 giu 1997 | 09 set 1997 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
| AYR ESTATES LIMITED | 04 lug 1997 | 02 set 1997 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
| AYR ESTATES LIMITED | 04 lug 1997 | 02 set 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
| GRAMPIAN OAT PRODUCTS LIMITED | 04 lug 1997 | 13 ago 1997 | Attiva | Segretario nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
| HAMLYNS OF SCOTLAND LIMITED | 04 lug 1997 | 13 ago 1997 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
| HAMLYNS OF SCOTLAND LIMITED | 04 lug 1997 | 13 ago 1997 | Attiva | Segretario nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
| SOMERSTON HOTELS (FIVE) LIMITED | 08 mag 1997 | 24 giu 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
| SOMERSTON HOTELS (FIVE) LIMITED | 08 mag 1997 | 24 giu 1997 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
| INDIGO LIGHTHOUSE SOLUTIONS LIMITED | 09 giu 1997 | 18 giu 1997 | Attiva | Segretario nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
| INDIGO LIGHTHOUSE SOLUTIONS LIMITED | 09 giu 1997 | 18 giu 1997 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
| LCM123 LIMITED | 08 mag 1997 | 02 giu 1997 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
| LCM123 LIMITED | 08 mag 1997 | 02 giu 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
| INDIGO LIGHTHOUSE GROUP LIMITED | 28 mag 1997 | 30 mag 1997 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
| INDIGO LIGHTHOUSE GROUP LIMITED | 28 mag 1997 | 30 mag 1997 | Attiva | Segretario nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
| MACROCOM (419) LIMITED | 08 mag 1997 | 21 mag 1997 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
| MACROCOM (419) LIMITED | 08 mag 1997 | 21 mag 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
| GLENFESHIE SEAFOODS LIMITED | 21 mar 1997 | 29 apr 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
| GLENFESHIE SEAFOODS LIMITED | 21 mar 1997 | 29 apr 1997 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
| SILVER CHOICE TRAVEL LIMITED | 23 gen 1997 | 28 apr 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
| SILVER CHOICE TRAVEL LIMITED | 23 gen 1997 | 28 apr 1997 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
| SLEAFORD POWER LIMITED | 13 feb 1997 | 09 apr 1997 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
| SLEAFORD POWER LIMITED | 13 feb 1997 | 09 apr 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
| BRITISH ENERGY FINANCE LIMITED | 21 mar 1997 | 08 apr 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0