• Dati
  • Gran Bretagna
  • Aziende
  • Cerca aziende
  • Sanzioni
  • Cerca sanzioni
  • David FLINT

    Persona fisica

    Titolo
    NomeDavid
    CognomeFLINT
    È un dirigente societarioNo
    Incarichi
    Attivo2
    Inattivo0
    Dimesso231
    Totale233

    Incarichi

    Incarichi assegnati
    Nominato aData di nominaData di dimissioniStato della societàProfessioneRuoloIndirizzoPaese di residenzaNazionalità
    W.J.HARTE (CITY) LIMITED17 mag 1988In amministrazione controllataSegretario nominato
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    W.J.HARTE (CITY) LIMITED17 mag 1988In amministrazione controllataAmministratore delegato nominato
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    CLYDE MATERIALS HANDLING LIMITED05 set 199628 lug 2000ScioltaSegretario nominato
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    CLYDE MATERIALS HANDLING LIMITED05 set 199628 lug 2000ScioltaAmministratore delegato nominato
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    GRAMPIAN OAT PRODUCTS LIMITED04 lug 199704 lug 1998AttivaAmministratore delegato nominato
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    HUNA DEVELOPMENT LIMITED21 mar 199728 nov 1997AttivaSegretario nominato
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    HUNA DEVELOPMENT LIMITED21 mar 199728 nov 1997AttivaAmministratore delegato nominato
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    INVERNESS AIR TERMINAL LIMITED23 gen 199721 nov 1997ScioltaSegretario nominato
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    INVERNESS AIR TERMINAL LIMITED23 gen 199721 nov 1997ScioltaAmministratore delegato nominato
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    MACROCOM (422) LIMITED28 mag 199722 set 1997LiquidazioneAmministratore delegato nominato
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    MACROCOM (422) LIMITED28 mag 199722 set 1997LiquidazioneSegretario nominato
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    EMPACE LIMITED09 giu 199709 set 1997ScioltaSegretario nominato
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    EMPACE LIMITED09 giu 199709 set 1997ScioltaAmministratore delegato nominato
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    AYR ESTATES LIMITED04 lug 199702 set 1997ScioltaAmministratore delegato nominato
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    AYR ESTATES LIMITED04 lug 199702 set 1997ScioltaSegretario nominato
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    GRAMPIAN OAT PRODUCTS LIMITED04 lug 199713 ago 1997AttivaSegretario nominato
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    HAMLYNS OF SCOTLAND LIMITED04 lug 199713 ago 1997AttivaAmministratore delegato nominato
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    HAMLYNS OF SCOTLAND LIMITED04 lug 199713 ago 1997AttivaSegretario nominato
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    SOMERSTON HOTELS (FIVE) LIMITED08 mag 199724 giu 1997ScioltaSegretario nominato
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    SOMERSTON HOTELS (FIVE) LIMITED08 mag 199724 giu 1997ScioltaAmministratore delegato nominato
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    INDIGO LIGHTHOUSE SOLUTIONS LIMITED09 giu 199718 giu 1997AttivaSegretario nominato
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    INDIGO LIGHTHOUSE SOLUTIONS LIMITED09 giu 199718 giu 1997AttivaAmministratore delegato nominato
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    LCM123 LIMITED08 mag 199702 giu 1997ScioltaAmministratore delegato nominato
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    LCM123 LIMITED08 mag 199702 giu 1997ScioltaSegretario nominato
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    INDIGO LIGHTHOUSE GROUP LIMITED28 mag 199730 mag 1997AttivaAmministratore delegato nominato
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    INDIGO LIGHTHOUSE GROUP LIMITED28 mag 199730 mag 1997AttivaSegretario nominato
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    MACROCOM (419) LIMITED08 mag 199721 mag 1997ScioltaAmministratore delegato nominato
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    MACROCOM (419) LIMITED08 mag 199721 mag 1997ScioltaSegretario nominato
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    GLENFESHIE SEAFOODS LIMITED21 mar 199729 apr 1997ScioltaSegretario nominato
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    GLENFESHIE SEAFOODS LIMITED21 mar 199729 apr 1997ScioltaAmministratore delegato nominato
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    SILVER CHOICE TRAVEL LIMITED23 gen 199728 apr 1997ScioltaSegretario nominato
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    SILVER CHOICE TRAVEL LIMITED23 gen 199728 apr 1997ScioltaAmministratore delegato nominato
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    SLEAFORD POWER LIMITED13 feb 199709 apr 1997ScioltaAmministratore delegato nominato
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    SLEAFORD POWER LIMITED13 feb 199709 apr 1997ScioltaSegretario nominato
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    BRITISH ENERGY FINANCE LIMITED21 mar 199708 apr 1997ScioltaSegretario nominato
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0