David FLINT - Pagina 6
Persona fisica
Titolo | |
---|---|
Nome | David |
Cognome | FLINT |
Data di nascita | |
È un dirigente societario | No |
Incarichi | |
Attivo | 2 |
Inattivo | 0 |
Dimesso | 231 |
Totale | 233 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIRDRESSING SUPPLIES LIMITED | 20 nov 1992 | 27 gen 1993 | Liquidazione | Amministratore delegato nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
HAIRDRESSING SUPPLIES LIMITED | 20 nov 1992 | 27 gen 1993 | Liquidazione | Segretario nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
THE CRANLEIGH BRICK AND TILE COMPANY LIMITED | 20 nov 1992 | 02 dic 1992 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
THE CRANLEIGH BRICK AND TILE COMPANY LIMITED | 20 nov 1992 | 02 dic 1992 | Sciolta | Segretario nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
TELEVISUAL DATA LIMITED | 01 lug 1992 | 06 lug 1992 | Sciolta | Segretario nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
TELEVISUAL DATA LIMITED | 01 lug 1992 | 06 lug 1992 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
CUMBRIA BEARINGS & TRANSMISSIONS LIMITED | 18 apr 1989 | 18 apr 1992 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
THE JOHNSTON PRESS TRUSTEE COMPANY LIMITED | 18 ott 1991 | 09 apr 1992 | Sciolta | Segretario nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
THE JOHNSTON PRESS TRUSTEE COMPANY LIMITED | 18 ott 1991 | 09 apr 1992 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
T.S. MCNEE LIMITED | 21 feb 1992 | 06 apr 1992 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
T.S. MCNEE LIMITED | 21 feb 1992 | 06 apr 1992 | Sciolta | Segretario nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
APERTA LIMITED | 21 feb 1992 | 12 mar 1992 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
APERTA LIMITED | 21 feb 1992 | 12 mar 1992 | Attiva | Segretario nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
MEDIA MANAGEMENT (UK) LIMITED | 18 dic 1991 | 12 mar 1992 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
MEDIA MANAGEMENT (UK) LIMITED | 18 dic 1991 | 12 mar 1992 | Sciolta | Segretario nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
P. MCKENNA & SONS (TRANSPORT SERVICES) LIMITED | 25 mar 1991 | 04 mar 1992 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
CORE IMAGE LIMITED | 18 ott 1991 | 10 gen 1992 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
CORE IMAGE LIMITED | 18 ott 1991 | 10 gen 1992 | Attiva | Segretario nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
PAPINGO LIMITED | 13 dic 1988 | 13 dic 1991 | Sciolta | Segretario nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
PAPINGO LIMITED | 13 dic 1988 | 13 dic 1991 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
BARCLAY PROPERTY INVESTMENTS 2004 LTD. | 30 set 1991 | 09 ott 1991 | Attiva | Segretario nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
BARCLAY PROPERTY INVESTMENTS 2004 LTD. | 30 set 1991 | 09 ott 1991 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
ANALYTICAL SERVICES CENTRE (FOOD PARK) LIMITED | 25 set 1991 | 07 ott 1991 | Sciolta | Segretario nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
ANALYTICAL SERVICES CENTRE (FOOD PARK) LIMITED | 25 set 1991 | 07 ott 1991 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
TECHNOLOGY TRANSFER CENTRE LIMITED | 06 ago 1991 | 16 set 1991 | Sciolta | Segretario nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
TECHNOLOGY TRANSFER CENTRE LIMITED | 06 ago 1991 | 16 set 1991 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
LEES GROUP LIMITED | 17 set 1990 | 09 set 1991 | Attiva | Segretario nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
LEES GROUP LIMITED | 17 set 1990 | 09 set 1991 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
BOTHWELL PARK BRICK COMPANY LIMITED | 15 mar 1988 | 06 ago 1991 | Liquidazione | Amministratore delegato nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
BOTHWELL PARK BRICK COMPANY LIMITED | 15 mar 1988 | 06 ago 1991 | Liquidazione | Segretario nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
STRATTON CONSULTANCY SERVICES LIMITED | 13 dic 1988 | 14 giu 1991 | Sciolta | Segretario nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
STRATTON CONSULTANCY SERVICES LIMITED | 13 dic 1988 | 14 giu 1991 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
FEATHER BROOKSBANK LIMITED | 17 set 1990 | 08 nov 1990 | Sciolta | Segretario nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
FEATHER BROOKSBANK LIMITED | 17 set 1990 | 08 nov 1990 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | ||
HIGHMORE HOMES NORTH LIMITED | 16 mar 1989 | 14 set 1990 | Sciolta | Segretario nominato | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0