SIMCO COMPANY SERVICES LIMITED - Pagina 2
Dirigente societario
Nome | SIMCO COMPANY SERVICES LIMITED |
---|---|
È un dirigente societario | Sì |
Incarichi | |
Attivo | 0 |
Inattivo | 0 |
Dimesso | 131 |
Totale | 131 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Ruolo | Indirizzo |
---|---|---|---|---|---|
XSCAPE LIMITED | 07 nov 1994 | 09 nov 1994 | Sciolta | Segretario nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds West Yorkshire |
BPT (ASSURED HOMES) LIMITED | 29 lug 1994 | 20 ott 1994 | Attiva | Segretario nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds West Yorkshire |
BCD TUBES LIMITED | 10 ott 1994 | 11 ott 1994 | Attiva | Segretario nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds West Yorkshire |
BARRETT STEEL ENGINEERING LIMITED | 29 lug 1994 | 30 set 1994 | Sciolta | Segretario nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds West Yorkshire |
CAPITAL & REGIONAL OUT-OF-TOWN (ASHFORD) LIMITED | 15 set 1994 | 26 set 1994 | Sciolta | Segretario nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds West Yorkshire |
TRIANGLE HOUSE LIMITED | 29 lug 1994 | 13 set 1994 | Sciolta | Segretario nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds West Yorkshire |
ACTOMED LIMITED | 01 set 1994 | 01 set 1994 | Sciolta | Segretario nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds West Yorkshire |
HIGH CLIFF DEVELOPMENTS LIMITED | 08 giu 1994 | 30 giu 1994 | Sciolta | Segretario nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds West Yorkshire |
MTS NATIONWIDE LIMITED | 06 apr 1994 | 09 mag 1994 | In amministrazione | Segretario nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds West Yorkshire |
66 SOUTHWOOD LANE FREEHOLD LIMITED | 07 feb 1994 | 28 apr 1994 | Attiva | Segretario nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds West Yorkshire |
UNIVERSITY OF LEEDS FARMS LIMITED | 06 apr 1994 | 25 apr 1994 | Sciolta | Segretario nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds West Yorkshire |
SPRING RAM BATHROOMS LIMITED | 16 apr 1993 | 16 apr 1994 | Sciolta | Segretario nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds West Yorkshire |
MERCHANT HARDWARE LIMITED | 21 feb 1994 | 24 mar 1994 | Sciolta | Segretario nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds West Yorkshire |
TOTTY LIMITED | 09 nov 1993 | 23 feb 1994 | Sciolta | Segretario nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds West Yorkshire |
UNITED STEEL SERVICES (LEEDS) LIMITED | 07 dic 1993 | 15 feb 1994 | Attiva | Segretario nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds West Yorkshire |
BARRETT PROCESSING SERVICES LIMITED | 07 dic 1993 | 15 feb 1994 | Attiva | Segretario nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds West Yorkshire |
ZEDMATE DEVELOPMENTS (COVENTRY) LIMITED | 26 gen 1994 | 01 feb 1994 | Liquidazione | Segretario nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds West Yorkshire |
THE MALL PEOPLE MANAGEMENT LIMITED | 14 set 1993 | 01 feb 1994 | Sciolta | Segretario nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds West Yorkshire |
PARKSIDE FLEXIBLES LIMITED | 09 nov 1993 | 26 gen 1994 | Sciolta | Segretario nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds West Yorkshire |
LAKELAND LABORATORIES LIMITED | 26 nov 1993 | 24 gen 1994 | Attiva | Segretario nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds West Yorkshire |
HYDROGEN SUPPLIES LIMITED | 15 nov 1993 | 24 gen 1994 | Attiva | Segretario nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds West Yorkshire |
RESIDENTIAL PROPERTY REVERSIONS V LIMITED | 15 nov 1993 | 12 gen 1994 | Sciolta | Segretario nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds West Yorkshire |
RIDGEWAY RENTALS VI LIMITED | 01 set 1993 | 11 gen 1994 | Sciolta | Segretario nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds West Yorkshire |
RIDGEWAY RENTALS V LIMITED | 01 set 1993 | 11 gen 1994 | Sciolta | Segretario nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds West Yorkshire |
RIDGEWAY RENTALS IV LIMITED | 27 ago 1993 | 11 gen 1994 | Sciolta | Segretario nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds West Yorkshire |
AIRPORT BUSES LIMITED | 08 lug 1993 | 09 dic 1993 | Attiva | Segretario nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds West Yorkshire |
PLEXUS CORP (UK) LIMITED | 16 nov 1993 | 01 dic 1993 | Attiva | Segretario nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds West Yorkshire |
PHYSIO MED LIMITED | 14 set 1993 | 30 nov 1993 | Attiva | Segretario nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds West Yorkshire |
OPTARE (LEEDS) LIMITED | 12 nov 1993 | 29 nov 1993 | Sciolta | Segretario nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds West Yorkshire |
REXAM BEVERAGE PACKAGING HOLDINGS LIMITED | 24 nov 1992 | 24 nov 1993 | Attiva | Segretario nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds West Yorkshire |
HOMESELECT (UK) LIMITED | 26 ago 1993 | 21 nov 1993 | Sciolta | Segretario nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds West Yorkshire |
CHG HOMES LIMITED | 27 ott 1993 | 12 nov 1993 | Sciolta | Segretario nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds West Yorkshire |
BARRETT STEEL TUBES LIMITED | 10 feb 1993 | 21 ott 1993 | Attiva | Segretario nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds West Yorkshire |
CYTEC INDUSTRIES UK LIMITED | 08 set 1993 | 20 ott 1993 | Sciolta | Segretario nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds West Yorkshire |
CYTEC ENGINEERED MATERIALS LIMITED | 08 set 1993 | 20 ott 1993 | Attiva | Segretario nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds West Yorkshire |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0