Paul Matthew RAFTERY - Pagina 6
Persona fisica
Titolo | Mr |
---|---|
Nome | Paul |
Secondo nome | Matthew |
Cognome | RAFTERY |
Data di nascita | |
È un dirigente societario | No |
Incarichi | |
Attivo | 1 |
Inattivo | 4 |
Dimesso | 213 |
Totale | 218 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVESTMENT CONNECTIONS LIMITED | 28 gen 2003 | 16 mar 2003 | Attiva | Segretario | 9 Redcourt Avenue M20 3QL Manchester | British | ||
TO THE WORLD'S END LIMITED | 28 gen 2003 | 10 mar 2003 | Attiva | Segretario | 9 Redcourt Avenue M20 3QL Manchester | British | ||
POCHIN RESIDENTIAL LIMITED | 07 ott 2002 | 29 gen 2003 | Liquidazione | Segretario | 9 Redcourt Avenue M20 3QL Manchester | British | ||
ATCL REALISATIONS 2014 LIMITED | 22 gen 2003 | 24 gen 2003 | Sciolta | Segretario | 9 Redcourt Avenue M20 3QL Manchester | British | ||
CHARTER HEALTH LIMITED | 04 ott 2002 | 16 gen 2003 | Sciolta | Segretario | 9 Redcourt Avenue M20 3QL Manchester | British | ||
MANCHESTER SHIP CANAL DEVELOPMENTS ADVENT LIMITED | 21 mag 2002 | 12 dic 2002 | Attiva | Segretario | 9 Redcourt Avenue M20 3QL Manchester | British | ||
SANGAMO LIMITED | 25 lug 2002 | 20 nov 2002 | Attiva | Segretario | 9 Redcourt Avenue M20 3QL Manchester | British | ||
DSC PACKAGING LTD | 25 lug 2002 | 02 ott 2002 | Attiva | Segretario | 9 Redcourt Avenue M20 3QL Manchester | British | ||
IMT INTERNATIONAL LIMITED | 21 mag 2002 | 20 ago 2002 | Liquidazione | Segretario | 9 Redcourt Avenue M20 3QL Manchester | British | ||
PUMA LOGISTICS SERVICES LIMITED | 21 mag 2002 | 09 ago 2002 | Sciolta | Segretario | 9 Redcourt Avenue M20 3QL Manchester | British | ||
BLAKES VAN & TRUCK CENTRE LIMITED | 21 mag 2002 | 26 lug 2002 | Sciolta | Segretario | 9 Redcourt Avenue M20 3QL Manchester | British | ||
61 HOPE STREET LIMITED | 15 feb 2002 | 16 lug 2002 | Attiva | Segretario | 9 Redcourt Avenue M20 3QL Manchester | British | ||
ELEPHANT LEASING LIMITED | 10 set 2001 | 05 giu 2002 | Sciolta | Segretario | 9 Redcourt Avenue M20 3QL Manchester | British | ||
AMCOL MINERALS EU LIMITED | 14 feb 2002 | 24 mag 2002 | Attiva | Segretario | 9 Redcourt Avenue M20 3QL Manchester | British | ||
OAKHOUSE FOODS LIMITED | 31 mag 2001 | 22 mag 2002 | Attiva | Segretario | 9 Redcourt Avenue M20 3QL Manchester | British | ||
TECNOVEX LIMITED | 14 feb 2002 | 27 mar 2002 | Sciolta | Segretario | 9 Redcourt Avenue M20 3QL Manchester | British | ||
VERITEC LIMITED | 11 gen 2002 | 27 mar 2002 | Sciolta | Segretario | 9 Redcourt Avenue M20 3QL Manchester | British | ||
CRANKS LIMITED | 11 gen 2002 | 25 mar 2002 | Attiva | Segretario | 9 Redcourt Avenue M20 3QL Manchester | British | ||
NANDO'S GROCERY LIMITED | 11 gen 2002 | 25 mar 2002 | Sciolta | Segretario | 9 Redcourt Avenue M20 3QL Manchester | British | ||
RAINBOW COSMETICS (MANCHESTER) LIMITED | 11 gen 2002 | 18 gen 2002 | Attiva | Segretario | 9 Redcourt Avenue M20 3QL Manchester | British | ||
IPCC LIMITED | 10 set 2001 | 14 gen 2002 | Sciolta | Segretario | 9 Redcourt Avenue M20 3QL Manchester | British | ||
S & B NORTHWEST LIMITED | 10 set 2001 | 18 dic 2001 | Attiva | Segretario | 9 Redcourt Avenue M20 3QL Manchester | British | ||
EXTREXEC LTD | 10 set 2001 | 20 nov 2001 | Sciolta | Segretario | 9 Redcourt Avenue M20 3QL Manchester | British | ||
MINTHEAD LIMITED | 31 mag 2001 | 30 ott 2001 | Sciolta | Segretario | 9 Redcourt Avenue M20 3QL Manchester | British | ||
KNOWLEDGE CALL LIMITED | 14 mar 2001 | 07 set 2001 | Attiva | Segretario | 9 Redcourt Avenue M20 3QL Manchester | British | ||
INDUSTRIAL SPACE LIMITED | 31 mag 2001 | 12 lug 2001 | Sciolta | Segretario | 9 Redcourt Avenue M20 3QL Manchester | British | ||
UKLP WALKER HOUSE LIMITED | 14 mar 2001 | 09 lug 2001 | Sciolta | Segretario | 9 Redcourt Avenue M20 3QL Manchester | British | ||
HABIT DIAMOND LIMITED | 19 apr 2001 | 14 mag 2001 | Sciolta | Segretario | 9 Redcourt Avenue M20 3QL Manchester | British | ||
UNITED TOOL DISTRIBUTORS LIMITED | 14 mar 2001 | 18 apr 2001 | Attiva | Segretario | 9 Redcourt Avenue M20 3QL Manchester | British | ||
THE CLAIMS RECOVERY SERVICE COMPANY LIMITED | 14 mar 2001 | 12 apr 2001 | Sciolta | Segretario | 9 Redcourt Avenue M20 3QL Manchester | British | ||
HYDRA PROPERTIES LIMITED | 17 gen 2001 | 15 mar 2001 | Sciolta | Segretario | 9 Redcourt Avenue M20 3QL Manchester | British | ||
CLARKSON OSBORN INTERNATIONAL LIMITED | 17 gen 2001 | 15 mar 2001 | Attiva | Segretario | 9 Redcourt Avenue M20 3QL Manchester | British | ||
TMDH LIMITED | 21 nov 2000 | 25 gen 2001 | Attiva | Segretario | 9 Redcourt Avenue M20 3QL Manchester | British | ||
GO4AWALK.COM LIMITED | 21 nov 2000 | 25 gen 2001 | Attiva | Segretario | 9 Redcourt Avenue M20 3QL Manchester | British | ||
CAB MOBILITY LIMITED | 20 nov 2000 | 12 gen 2001 | Sciolta | Segretario | 9 Redcourt Avenue M20 3QL Manchester | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0