Kevin BREWER - Pagina 170
Persona fisica
Titolo | Dr |
---|---|
Nome | Kevin |
Cognome | BREWER |
Data di nascita | |
È un dirigente societario | No |
Incarichi | |
Attivo | 0 |
Inattivo | 7 |
Dimesso | 7377 |
Totale | 7384 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDM DEVELOPMENTS LIMITED | 05 lug 1995 | 05 lug 1995 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
EAGLE AIR CORPORATION LIMITED | 05 lug 1995 | 05 lug 1995 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
MARRICK COMMUNICATIONS LIMITED | 05 lug 1995 | 05 lug 1995 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
EXCEL ENGLISH LANGUAGE SCHOOL LIMITED | 05 lug 1995 | 05 lug 1995 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
XENON TECHNOLOGY LIMITED | 18 apr 1995 | 03 lug 1995 | Attiva | Amministratore delegato nominato | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
INTERTRADE CONSULTANTS LIMITED | 12 apr 1995 | 03 lug 1995 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
THE RIGHT SOLUTION LIMITED | 01 giu 1995 | 30 giu 1995 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
CARS DIRECT LIMITED | 10 nov 1994 | 30 giu 1995 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
BROADFIELD & PARTNERS LIMITED | 29 giu 1995 | 29 giu 1995 | Attiva | Amministratore delegato nominato | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
CLEVECRETE CONCRETE LIMITED | 29 giu 1995 | 29 giu 1995 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
DIRECT FILM INDUSTRIES LIMITED | 27 giu 1995 | 27 giu 1995 | Attiva | Amministratore delegato nominato | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
NU-WELD ENGINEERING SERVICES LIMITED | 27 giu 1995 | 27 giu 1995 | Attiva | Amministratore delegato nominato | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
DATAFLOW CONTRACTS LIMITED | 27 giu 1995 | 27 giu 1995 | Attiva | Amministratore delegato nominato | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
STEWART RUSSELL ASSOCIATES LIMITED | 27 giu 1995 | 27 giu 1995 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
FOUR SEASONS PROPERTIES LIMITED | 22 giu 1995 | 27 giu 1995 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
C A DESIGN LTD | 27 giu 1995 | 27 giu 1995 | Liquidazione | Amministratore delegato nominato | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
AMBLE BOAT COMPANY LIMITED | 23 giu 1995 | 23 giu 1995 | Attiva | Segretario nominato | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | British | ||
IMPRINT COLOUR PRINTERS LIMITED | 23 giu 1995 | 23 giu 1995 | Attiva | Amministratore delegato nominato | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
D.C. ENGINEERING (WIRRAL) LIMITED | 20 giu 1995 | 20 giu 1995 | Attiva | Amministratore delegato nominato | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
CONSERVATORY COMPONENTS LIMITED | 19 giu 1995 | 19 giu 1995 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
HUGO NICOLLE GARDEN DESIGN LIMITED | 19 giu 1995 | 19 giu 1995 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
BLUEPRINT DEVELOPMENTS LIMITED | 01 giu 1995 | 19 giu 1995 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
INSIGHT BUILDERS LIMITED | 12 apr 1995 | 19 giu 1995 | Liquidazione | Amministratore delegato nominato | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
WATERLOO CORPORATION LIMITED | 07 apr 1995 | 16 giu 1995 | Liquidazione | Amministratore delegato nominato | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
MAGICAL SOLUTIONS LIMITED | 14 giu 1995 | 14 giu 1995 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
CONDOR INTERIORS LIMITED | 14 giu 1995 | 14 giu 1995 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
ACRELEA LIMITED | 13 giu 1995 | 13 giu 1995 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
HARRISON CLOSE MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 12 giu 1995 | 12 giu 1995 | Attiva | Amministratore delegato nominato | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
CYLINDER TESTING & SALES (U.K.) LIMITED | 12 giu 1995 | 12 giu 1995 | Attiva | Amministratore delegato nominato | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
GEORGES TRADITION LIMITED | 12 giu 1995 | 12 giu 1995 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
THE REPTILE MASTERS LIMITED | 07 apr 1995 | 09 giu 1995 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
BLACKFRIARS CONSULTANTS LIMITED | 13 mar 1995 | 08 giu 1995 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
VISUAL PRECISION LIMITED | 07 giu 1995 | 07 giu 1995 | Attiva | Segretario nominato | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | British | ||
TRISTAR TELEVISION LIMITED | 07 giu 1995 | 07 giu 1995 | Attiva | Amministratore delegato nominato | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
THAMES CRESCENT (CHISWICK) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 07 giu 1995 | 07 giu 1995 | Attiva | Segretario nominato | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | British |
Precedente23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211Successivo
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0