Lesley Joyce GRAEME - Pagina 22
Persona fisica
| Titolo | |
|---|---|
| Nome | Lesley |
| Secondo nome | Joyce |
| Cognome | GRAEME |
| Data di nascita | |
| È un dirigente societario | No |
| Incarichi | |
| Attivo | 0 |
| Inattivo | 0 |
| Dimesso | 9881 |
| Totale | 9881 |
Incarichi
| Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSBURY FABRICS LIMITED | 17 mag 2004 | 17 mag 2004 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
| HGA ENTERPRISES LIMITED | 17 mag 2004 | 17 mag 2004 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
| DAMA CONSTRUCTION LIMITED | 14 mag 2004 | 14 mag 2004 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
| WINFIELD HOLDINGS LIMITED | 13 mag 2004 | 13 mag 2004 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
| THE GOLF CONSULTANCY LIMITED | 13 mag 2004 | 13 mag 2004 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
| TALENTSPACE LIMITED | 13 mag 2004 | 13 mag 2004 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
| INNENDESIGN LTD | 13 mag 2004 | 13 mag 2004 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
| VACANT DESIGNS LIMITED | 13 mag 2004 | 13 mag 2004 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
| HAYBELL LTD | 13 mag 2004 | 13 mag 2004 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
| WINFIELD'S LIMITED | 13 mag 2004 | 13 mag 2004 | In amministrazione | Amministratore delegato nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
| SEDGEFIELD PROPERTIES LIMITED | 13 mag 2004 | 20 lug 2004 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
| COOLINGE DEVELOPMENTS LIMITED | 12 mag 2004 | 12 mag 2004 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
| PENISTONE WIRE LIMITED | 12 mag 2004 | 12 mag 2004 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
| LIFTED FILMS LIMITED | 12 mag 2004 | 12 mag 2004 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
| TARGAMAR HOLDINGS LIMITED | 12 mag 2004 | 12 mag 2004 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
| CLEARVIEW CONSULTING (MIDLANDS) LIMITED | 12 mag 2004 | 12 mag 2004 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
| N.A. CASELTON BUILDING SERVICES LIMITED | 12 mag 2004 | 12 mag 2004 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
| MARCLE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED | 11 mag 2004 | 06 ott 2004 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
| LOUISE BENDALL H R CONSULTANT LIMITED | 11 mag 2004 | 11 mag 2004 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
| YORKSHIRE BED & SUITE CENTRE LIMITED | 10 mag 2004 | 10 mag 2004 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
| TANTON SCAFFOLDING LIMITED | 10 mag 2004 | 10 mag 2004 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
| ROSELINE SERVICES LIMITED | 10 mag 2004 | 24 set 2004 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
| MACHYNYS PENINSULA GOLF & COUNTRY CLUB LIMITED | 10 mag 2004 | 10 mag 2004 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
| VALLEYVIEW ENTERPRISES LIMITED | 10 mag 2004 | 23 giu 2004 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
| FPGA DESIGN CONSULTANTS LIMITED | 10 mag 2004 | 10 mag 2004 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
| SENSEI LIMITED | 10 mag 2004 | 10 mag 2004 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
| ANITA GUEST CATERING LIMITED | 10 mag 2004 | 19 mag 2004 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
| STICK & GO LIMITED | 10 mag 2004 | 05 ott 2004 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
| WASHMORE LIMITED | 10 mag 2004 | 10 mag 2004 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
| BLUEBUS INTERACTIVE LIMITED | 07 mag 2004 | 07 mag 2004 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
| UNITED CONVERTING (UK) LTD. | 06 mag 2004 | 06 mag 2004 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
| CANDIDATE HR LIMITED | 06 mag 2004 | 06 mag 2004 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
| LE FOOT LIMITED | 06 mag 2004 | 06 mag 2004 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
| SIGNSHOPPE LIMITED | 06 mag 2004 | 06 mag 2004 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
| WG BS AGENCY LIMITED | 06 mag 2004 | 06 mag 2004 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British |
Precedente23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283Successivo
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0