BRISTOL LEGAL SERVICES LIMITED - Pagina 120
Dirigente societario
Nome | BRISTOL LEGAL SERVICES LIMITED |
---|---|
È un dirigente societario | Sì |
Incarichi | |
Attivo | 7 |
Inattivo | 1 |
Dimesso | 4824 |
Totale | 4832 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Ruolo | Indirizzo |
---|---|---|---|---|---|
SOUTH WEST TRACTORS LIMITED | 22 feb 1996 | 22 feb 1996 | Sciolta | Segretario nominato | Pembroke House 7 Brunswick Square BS2 8PE Bristol Avon |
RICORDINI & CO. LIMITED | 22 feb 1996 | 22 feb 1996 | Sciolta | Segretario nominato | Pembroke House 7 Brunswick Square BS2 8PE Bristol Avon |
INTERTECH PROCESS MACHINERY (SPARES) LTD | 19 feb 1996 | 19 feb 1996 | Sciolta | Segretario nominato | Pembroke House 7 Brunswick Square BS2 8PE Bristol Avon |
A.L.P. SERVICES LIMITED | 19 feb 1996 | 19 feb 1996 | Sciolta | Segretario nominato | Pembroke House 7 Brunswick Square BS2 8PE Bristol Avon |
KEITH WILLIS ASSOCIATES LIMITED | 15 feb 1996 | 16 feb 1996 | Attiva | Segretario nominato | Pembroke House 7 Brunswick Square BS2 8PE Bristol Avon |
WORKING SOLUTIONS CONSULTANTS LIMITED | 15 feb 1996 | 15 feb 1996 | Attiva | Segretario nominato | Pembroke House 7 Brunswick Square BS2 8PE Bristol Avon |
TAYLOR-MADE CREATIVE SERVICES LIMITED | 15 feb 1996 | 15 feb 1996 | Sciolta | Segretario nominato | Pembroke House 7 Brunswick Square BS2 8PE Bristol Avon |
STANLEY PLUMBING LTD. | 12 feb 1996 | 12 feb 1996 | Sciolta | Segretario nominato | Pembroke House 7 Brunswick Square BS2 8PE Bristol Avon |
CCM (HOLDINGS) LIMITED | 08 feb 1996 | 08 feb 1996 | Sciolta | Segretario nominato | Pembroke House 7 Brunswick Square BS2 8PE Bristol Avon |
GREENLANDS INVESTMENT PROPERTIES LTD | 07 feb 1996 | 07 feb 1996 | Attiva | Segretario nominato | Pembroke House 7 Brunswick Square BS2 8PE Bristol Avon |
QUARLESTON PROPERTY MANAGEMENT LIMITED | 07 feb 1996 | 07 feb 1996 | Attiva | Segretario nominato | Pembroke House 7 Brunswick Square BS2 8PE Bristol Avon |
POSITIVE ADVERTISING LIMITED | 07 feb 1996 | 07 feb 1996 | Sciolta | Segretario nominato | Pembroke House 7 Brunswick Square BS2 8PE Bristol Avon |
KENNET CITIZENS ADVICE BUREAU LIMITED | 07 feb 1996 | 07 feb 1996 | Sciolta | Segretario nominato | Pembroke House 7 Brunswick Square BS2 8PE Bristol Avon |
CHEDDAR CHEESE STRAWS LIMITED | 05 feb 1996 | 05 feb 1996 | Attiva | Segretario nominato | Pembroke House 7 Brunswick Square BS2 8PE Bristol Avon |
MTD INVESTMENTS LIMITED | 05 feb 1996 | 05 feb 1996 | Attiva | Segretario nominato | Pembroke House 7 Brunswick Square BS2 8PE Bristol Avon |
COOPERS WHOLESALE LIMITED | 05 feb 1996 | 05 feb 1996 | Sciolta | Segretario nominato | Pembroke House 7 Brunswick Square BS2 8PE Bristol Avon |
LEYBROOK LIMITED | 25 gen 1996 | 25 gen 1996 | Attiva | Segretario nominato | Pembroke House 7 Brunswick Square BS2 8PE Bristol Avon |
C JAY ENTERPRISES LIMITED | 22 gen 1996 | 22 gen 1996 | Sciolta | Segretario nominato | Pembroke House 7 Brunswick Square BS2 8PE Bristol Avon |
FENSBOROUGH LIMITED | 17 gen 1996 | 17 gen 1996 | Attiva | Segretario nominato | Pembroke House 7 Brunswick Square BS2 8PE Bristol Avon |
PAUL MATTY SPORTSCARS LIMITED | 17 gen 1996 | 17 gen 1996 | Liquidazione | Segretario nominato | Pembroke House 7 Brunswick Square BS2 8PE Bristol Avon |
ARDEN MOTORSPORT LIMITED | 15 gen 1996 | 15 gen 1996 | Attiva | Segretario nominato | Pembroke House 7 Brunswick Square BS2 8PE Bristol Avon |
6 VICTORIA PARK (WESTON-SUPER-MARE) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 15 gen 1996 | 15 gen 1996 | Attiva | Segretario nominato | Pembroke House 7 Brunswick Square BS2 8PE Bristol Avon |
SOUTHERN COUNTIES SHOOTING LIMITED | 10 gen 1996 | 10 gen 1996 | Sciolta | Segretario nominato | Pembroke House 7 Brunswick Square BS2 8PE Bristol Avon |
OUT AND ABOUT SYSTEMS LIMITED | 10 gen 1996 | 10 gen 1996 | Sciolta | Segretario nominato | Pembroke House 7 Brunswick Square BS2 8PE Bristol Avon |
6 BATH STREET FROME (MANAGEMENT) LIMITED | 05 gen 1996 | 05 gen 1996 | Attiva | Segretario nominato | Pembroke House 7 Brunswick Square BS2 8PE Bristol Avon |
KINGFISHER LABELS LIMITED | 08 dic 1995 | 05 gen 1996 | Attiva | Segretario nominato | Pembroke House 7 Brunswick Square BS2 8PE Bristol Avon |
TARRYSTONE LIMITED | 05 gen 1996 | 05 gen 1996 | Sciolta | Segretario nominato | Pembroke House 7 Brunswick Square BS2 8PE Bristol Avon |
DHS CONTRACTORS LIMITED | 05 gen 1996 | 05 gen 1996 | Sciolta | Segretario nominato | Pembroke House 7 Brunswick Square BS2 8PE Bristol Avon |
DROITWICH ROOFING AND BUILDING SPECIALISTS LIMITED | 02 gen 1996 | 02 gen 1996 | Attiva | Segretario nominato | Pembroke House 7 Brunswick Square BS2 8PE Bristol Avon |
SUNHILL QUARRIES LIMITED | 27 dic 1995 | 27 dic 1995 | Sciolta | Segretario nominato | Pembroke House 7 Brunswick Square BS2 8PE Bristol Avon |
BRITCLEAN (U.K.) LIMITED | 08 dic 1995 | 22 dic 1995 | Attiva | Segretario nominato | Pembroke House 7 Brunswick Square BS2 8PE Bristol Avon |
STONEMAN & STARLING PHOTOGRAPHERS LIMITED | 21 dic 1995 | 21 dic 1995 | Sciolta | Segretario nominato | Pembroke House 7 Brunswick Square BS2 8PE Bristol Avon |
ORCHARD COMPUTERS (UK) LIMITED | 20 dic 1995 | 20 dic 1995 | Sciolta | Segretario nominato | Pembroke House 7 Brunswick Square BS2 8PE Bristol Avon |
NEWTON PROPERTIES LIMITED | 14 dic 1995 | 14 dic 1995 | Sciolta | Segretario nominato | Pembroke House 7 Brunswick Square BS2 8PE Bristol Avon |
KENSIT SYSTEMS LIMITED | 14 dic 1995 | 14 dic 1995 | Sciolta | Segretario nominato | Pembroke House 7 Brunswick Square BS2 8PE Bristol Avon |
Precedente23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139Successivo
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0