Clifford Donald WING - Pagina 45
Persona fisica
| Titolo | |
|---|---|
| Nome | Clifford |
| Secondo nome | Donald |
| Cognome | WING |
| Data di nascita | |
| È un dirigente societario | No |
| Incarichi | |
| Attivo | 4 |
| Inattivo | 33 |
| Dimesso | 1634 |
| Totale | 1671 |
Incarichi
| Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOPTON MARRIOTT HILLIER LIMITED | 15 dic 1994 | 15 dic 1994 | Attiva | Segretario | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| BASEDATA LIMITED | 14 dic 1994 | 14 dic 1994 | Attiva | Segretario | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| TIRES 4 LESS LIMITED | 13 dic 1994 | 13 dic 1994 | Attiva | Segretario | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| DYNASTY JEWELS LIMITED | 13 dic 1994 | 13 dic 1994 | Attiva | Segretario | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| R.B. LABELS LIMITED | 09 dic 1994 | 09 dic 1994 | Attiva | Company Secretary | Segretario | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | |
| LAU CORPORATION LIMITED | 07 dic 1994 | 07 dic 1994 | Sciolta | Segretario | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| H M C LOGISTICS LIMITED | 07 dic 1994 | 07 dic 1994 | Attiva | Segretario | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| HILLIER & SONS LIMITED | 06 dic 1994 | 06 dic 1994 | Attiva | Segretario | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| VISITPOINT LIMITED | 02 dic 1994 | 20 dic 1994 | Sciolta | Segretario | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| GOSCOTE LIMITED | 02 dic 1994 | 14 gen 1995 | Sciolta | Company Secretary | Segretario | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | |
| YARDSCALE LIMITED | 02 dic 1994 | 03 gen 1995 | Attiva | Segretario | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| STATIONSIDE COMMERCIALS LIMITED | 30 nov 1994 | 30 nov 1994 | Attiva | Segretario | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| GRIFFIN WYLDE INDEPENDENT FINANCIAL ADVISORS LIMITED | 25 nov 1994 | 25 nov 1994 | Attiva | Company Secretary | Segretario | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | |
| AVENUES D AND B LIMITED | 25 nov 1994 | 15 dic 1994 | Attiva | Segretario | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| AVERHALL LIMITED | 25 nov 1994 | 25 nov 1994 | Sciolta | Segretario | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| SOUTHFORK 4 X 4 CENTRE LIMITED | 24 nov 1994 | 24 nov 1994 | Sciolta | Segretario | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| MULBERRY COURT (URMSTON) LIMITED | 18 nov 1994 | 18 nov 1994 | Attiva | Segretario | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| C3IMAGING (LIVERPOOL) LIMITED | 17 nov 1994 | 17 nov 1994 | Sciolta | Segretario | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| CLIMAX PRO-SQUASH LIMITED | 16 nov 1994 | 28 nov 1994 | Attiva | Segretario | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| THE REDWALL ABBEY COMPANY LIMITED | 16 nov 1994 | 15 dic 1994 | Attiva | Segretario | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| CALLFIELD LIMITED | 16 nov 1994 | 12 dic 1994 | Attiva | Company Secretary | Segretario | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | |
| FALCON PLASTIC FABRICATION LIMITED | 14 nov 1994 | 15 dic 1994 | Sciolta | Segretario | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| ESSEX MASONIC PROPERTY COMPANY LIMITED | 14 nov 1994 | 07 dic 1994 | Liquidazione | Segretario | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| PREMIER JOINERY & REMEDIAL SERVICES LIMITED | 14 nov 1994 | 07 dic 1994 | Attiva | Segretario | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| A.J. TAYLOR LIMITED | 14 nov 1994 | 14 nov 1994 | Attiva | Segretario | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| RED VALLEY TECHNOLOGY LIMITED | 11 nov 1994 | 11 nov 1994 | Attiva | Company Secretary | Segretario | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | |
| MANOR COURT (CHESHUNT) PROPERTY MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 11 nov 1994 | 11 nov 1994 | Attiva | Segretario | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| MERRYSCOPE LIMITED | 10 nov 1994 | 11 nov 1994 | Sciolta | Segretario | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| MATHUR ELECTRO-MEDICAL LIMITED | 08 nov 1994 | 08 nov 1994 | Sciolta | Company Secretary | Segretario | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | |
| A JAY ENGINEERING LIMITED | 08 nov 1994 | 08 nov 1994 | Sciolta | Segretario | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| MANCHESTER CITY LIMITED | 08 nov 1994 | 09 nov 1994 | Attiva | Segretario | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| MOBILE INFORMATION SYSTEMS LIMITED | 03 nov 1994 | 03 nov 1994 | Sciolta | Segretario | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| ACE TRACK (U.K.) LIMITED | 02 nov 1994 | 02 nov 1994 | Attiva | Segretario | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| POOLBROOK PROPERTIES LIMITED | 02 nov 1994 | 02 nov 1994 | Sciolta | Segretario | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | ||
| ASSISTED RECOVERIES (U.K.) LIMITED | 01 nov 1994 | 01 nov 1994 | Attiva | Segretario | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British |
Precedente23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748Successivo
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0