EVERSECRETARY LIMITED - Pagina 7
Dirigente societario
Nome | EVERSECRETARY LIMITED |
---|---|
È un dirigente societario | Sì |
Incarichi | |
Attivo | 8 |
Inattivo | 203 |
Dimesso | 1404 |
Totale | 1615 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Ruolo | Indirizzo |
---|---|---|---|---|---|
PIA PRESSURE LIMITED | 07 ago 2006 | 31 dic 2020 | Attiva | Segretario | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House |
CHAMARAC LIMITED | 27 lug 2005 | 31 dic 2020 | Attiva | Segretario | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester |
RX BAR UK LIMITED | 07 apr 2018 | 31 dic 2020 | Sciolta | Segretario | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
MILLBROOK PARK RESIDENTS MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 20 ott 2011 | 01 set 2020 | Attiva | Segretario | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
UNIVERSITY CENTRE PETERBOROUGH | 05 giu 2020 | 31 lug 2020 | Attiva | Segretario | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House England |
EP INVEST LIMITED | 02 ott 2015 | 15 giu 2020 | Attiva | Segretario | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
EGGBOROUGH POWER LIMITED | 26 mag 2010 | 15 giu 2020 | Attiva | Segretario | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
GREP1 LIMITED | 09 dic 2011 | 28 mag 2020 | Attiva | Segretario | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
LINCOLNSHIRE BIOMASS LTD | 09 dic 2011 | 28 mag 2020 | Attiva | Segretario | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
CEP BIOMASS LIMITED | 19 mag 2011 | 28 mag 2020 | Attiva | Segretario | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
STOCKPORT EXCHANGE PHASE 3 LIMITED | 30 ago 2018 | 15 mag 2020 | Attiva | Segretario | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
WILKHAHN LIMITED | 13 feb 2006 | 07 feb 2020 | Attiva | Segretario | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester |
SKINNERS' ACADEMIES TRUST | 08 dic 2011 | 22 gen 2020 | Attiva | Segretario | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
ARJO WIGGINS FINE PAPERS LIMITED | 22 lug 2005 | 17 gen 2020 | In amministrazione | Segretario | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester |
WIGGINS TEAPE GROUP LIMITED(THE) | 22 lug 2005 | 17 gen 2020 | Sciolta | Segretario | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester |
AW UK HOLDINGS LIMITED | 22 lug 2005 | 17 gen 2020 | Sciolta | Segretario | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester |
ARJOWIGGINS SOURCING LIMITED | 19 feb 2009 | 17 gen 2020 | Liquidazione | Segretario | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House England |
ARJOWIGGINS CHARTHAM LIMITED | 22 lug 2005 | 17 gen 2020 | Liquidazione | Segretario | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester |
AW-WS GROUP LIMITED | 22 lug 2005 | 17 gen 2020 | Liquidazione | Segretario | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester |
ARJOBEX LIMITED | 22 lug 2005 | 17 gen 2020 | Liquidazione | Segretario | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester |
AW IVYBRIDGE LIMITED | 22 lug 2005 | 17 gen 2020 | Liquidazione | Segretario | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester |
CCFSG HOLDINGS LIMITED | 08 nov 2018 | 12 nov 2019 | Attiva | Segretario | Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester 70 England |
ACETATE PRODUCTS LIMITED | 01 lug 2004 | 30 ott 2019 | Liquidazione | Segretario | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester |
PENTAIR UK HOLDINGS LIMITED | 11 giu 2018 | 07 ott 2019 | Attiva | Segretario | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
PENTAIR INTERNATIONAL (UK) LTD | 26 gen 2018 | 07 ott 2019 | Attiva | Segretario | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House Lancashire United Kingdom |
PENTAIR TUBING LIMITED | 01 mag 2017 | 07 ott 2019 | Attiva | Segretario | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
PENTAIR UK GROUP LIMITED | 01 dic 2017 | 07 ott 2019 | Sciolta | Segretario | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
SUDMO (UK) LIMITED | 01 mar 2017 | 07 ott 2019 | Sciolta | Segretario | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
PENTAIR ENVIRONMENTAL SYSTEMS LIMITED | 01 mar 2017 | 07 ott 2019 | Sciolta | Segretario | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
FMC TECHNOLOGIES GLOBAL BUSINESS SERVICES LTD | 05 dic 2016 | 07 ott 2019 | Sciolta | Segretario | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
CROSBY SERVICES INTERNATIONAL LIMITED | 06 apr 2016 | 07 ott 2019 | Sciolta | Segretario | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
AABB LIMITED | 06 apr 2016 | 07 ott 2019 | Sciolta | Segretario | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
BRAINLOOP LIMITED | 20 giu 2013 | 07 ago 2019 | Sciolta | Segretario | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
NEW YORK COLLEGE IN LONDON LIMITED | 22 ott 2013 | 05 ago 2019 | Sciolta | Segretario | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
THE RUSSELL GROUP OF UNIVERSITIES | 06 feb 2007 | 16 mag 2019 | Attiva | Segretario | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
Precedente234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647Successivo
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0