THE GRANT SMITH LAW PRACTICE - Pagina 3
Dirigente societario
Nome | THE GRANT SMITH LAW PRACTICE |
---|---|
È un dirigente societario | Sì |
Incarichi | |
Attivo | 0 |
Inattivo | 39 |
Dimesso | 133 |
Totale | 172 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Ruolo | Indirizzo |
---|---|---|---|---|---|
BODY & FACE ST. CYRUS LIMITED | 24 ott 1994 | 02 ago 2011 | Attiva | Segretario | 252 Union Street AB10 1TN Aberdeen Amicable House Scotland |
GRANT SMITH LAW PRACTICE LIMITED | 08 set 1993 | 02 ago 2011 | Attiva | Segretario | 252 Union Street AB10 1TN Aberdeen Amicable House Scotland |
CROMDALE LIMITED | 01 apr 1993 | 02 ago 2011 | Attiva | Segretario | 252 Union Street AB10 1TN Aberdeen Amicable House Scotland |
BURNS CONSTRUCTION (ABERDEEN) LIMITED | 02 ago 2011 | Attiva | Segretario | 252 Union Street AB10 1TN Aberdeen Amicable House Scotland | |
HUNTER LEGAL LIMITED | 15 set 2009 | 31 lug 2011 | Sciolta | Segretario | 252 Union Street AB10 1TN Aberdeen Amicable House Scotland |
KEITH CLARK TECHNICAL SERVICES LIMITED | 17 lug 2007 | 31 lug 2011 | Attiva | Segretario | 252 Union Street AB10 1TN Aberdeen Amicable House Scotland |
ATLANTIC WATER CO. LIMITED | 08 set 2006 | 31 lug 2011 | Sciolta | Segretario | 252 Union Street AB10 1TN Aberdeen Amicable House Scotland |
BOTA SOLUTIONS LIMITED | 21 apr 2006 | 31 lug 2011 | Sciolta | Segretario | 252 Union Street AB10 1TN Aberdeen Amicable House Scotland |
BRAEMAR COMMUNITY LTD. | 01 nov 2005 | 31 lug 2011 | Attiva | Segretario | 252 Union Street AB10 1TN Aberdeen Amicable House Scotland |
DR ELINE PEDERSEN LIMITED | 28 ott 2005 | 31 lug 2011 | Attiva | Segretario | 252 Union Street AB10 1TN Aberdeen Amicable House United Kingdom |
GRAY & SKENE CONSULTANCY LIMITED | 03 ott 2005 | 31 lug 2011 | Sciolta | Segretario | 252 Union Street AB10 1TN Aberdeen Amicable House Aberdeenshire Scotland |
OSTARA LIFE LIMITED | 08 ago 2005 | 31 lug 2011 | Attiva | Segretario | 252 Union Street AB10 1TN Aberdeen Amicable House Scotland |
ABERDEEN OVERSEAS PROPERTIES LIMITED | 18 gen 2005 | 31 lug 2011 | Sciolta | Segretario | 252 Union Street AB10 1TN Aberdeen Amicable House Scotland |
AUTO CENTRE INVERURIE LIMITED | 23 dic 2004 | 31 lug 2011 | Attiva | Segretario | 252 Union Street AB10 1TN Aberdeen Amicable House Scotland |
CARTRIDGE WORLD (ABERDEEN) LIMITED | 21 set 2004 | 31 lug 2011 | Sciolta | Segretario | 252 Union Street AB10 1TN Aberdeen Amicable House Scotland |
MARK LOUGH CONSULTING LIMITED | 17 set 2004 | 31 lug 2011 | Sciolta | Segretario | 252 Union Street AB10 1TN Aberdeen Amicable House Scotland |
SHISH TANDOORI (ABERDEEN) LIMITED | 09 lug 2004 | 31 lug 2011 | Attiva | Segretario | 252 Union Street AB10 1TN Aberdeen Amicable House Scotland |
SPLIT ROCK DEVELOPMENTS LIMITED | 27 apr 2004 | 31 lug 2011 | Sciolta | Segretario | 252 Union Street AB10 1TN Aberdeen Amicable House Scotland |
GSLP TRUSTEES LIMITED | 16 dic 2003 | 31 lug 2011 | Attiva | Segretario | 252 Union Street AB10 1TN Aberdeen Amicable House Scotland |
MGM ABERDEEN LIMITED | 11 nov 2003 | 31 lug 2011 | Attiva | Segretario | 252 Union Street AB10 1TN Aberdeen Amicable House Scotland |
LOGIK COMMUNICATION LIMITED | 20 ott 2003 | 31 lug 2011 | Sciolta | Segretario | 252 Union Street AB10 1TN Aberdeen Amicable House Scotland |
KAREN MACRAE RESOURCES LIMITED | 15 ott 2003 | 31 lug 2011 | Sciolta | Segretario | 252 Union Street AB10 1TN Aberdeen Amicable House Scotland |
ENTERPRISE NORTH EAST LIMITED | 06 ott 2003 | 31 lug 2011 | Sciolta | Segretario | 252 Union Street AB10 1TN Aberdeen Amicable House Scotland |
ABERDEENSHIRE INVESTMENTS LIMITED | 25 set 2003 | 31 lug 2011 | Sciolta | Segretario | 252 Union Street AB10 1TN Aberdeen Amicable House Scotland |
FACILITIES MANAGEMENT (ABERDEEN) LIMITED | 29 ago 2003 | 31 lug 2011 | Attiva | Segretario | 252 Union Street AB10 1TN Aberdeen Amicable House Scotland |
166A TBR LTD | 01 ago 2003 | 31 lug 2011 | Attiva | Segretario | 252 Union Street AB10 1TN Aberdeen Amicable House Scotland |
WIFE.COM LIMITED | 15 apr 2003 | 31 lug 2011 | Attiva | Segretario | 252 Union Street AB10 1TN Aberdeen Amicable House Scotland |
WD HARCUS GROUNDWORKS LIMITED | 04 apr 2003 | 31 lug 2011 | Sciolta | Segretario | 252 Union Street AB10 1TN Aberdeen Amicable House Scotland |
WEE ANGELS LIMITED | 16 dic 2002 | 31 lug 2011 | Sciolta | Segretario | 252 Union Street AB10 1TN Aberdeen Amicable House Scotland |
GSLP FINANCIAL MANAGEMENT LTD. | 28 ott 2002 | 31 lug 2011 | Sciolta | Segretario | 252 Union Street AB10 1TN Aberdeen Amicable House Scotland |
GORDON ENTERPRISE TRUST LIMITED | 31 gen 2002 | 31 lug 2011 | Sciolta | Segretario | 252 Union Street AB10 1TN Aberdeen Amicable House Scotland |
FOX AND HARE ENTERPRISES LIMITED | 21 giu 2001 | 31 lug 2011 | Sciolta | Segretario | 252 Union Street AB10 1TN Aberdeen Amicable House Scotland |
ROSEBURN (ABERDEEN) LIMITED | 01 mag 2001 | 31 lug 2011 | Sciolta | Segretario | 252 Union Street AB10 1TN Aberdeen Amicable House Scotland |
MULTI ETHNIC ABERDEEN LIMITED | 10 lug 2000 | 31 lug 2011 | Sciolta | Segretario | 252 Union Street AB10 1TN Aberdeen Amicable House Scotland |
MULTIPLE SCLEROSIS CENTRE, MID-ARGYLL LIMITED | 31 gen 2000 | 31 lug 2011 | Attiva | Segretario | 252 Union Street AB10 1TN Aberdeen Amicable House Scotland |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0