Michael Sheldon SILVERSTONE - Pagina 13
Persona fisica
Titolo | |
---|---|
Nome | Michael |
Secondo nome | Sheldon |
Cognome | SILVERSTONE |
Data di nascita | |
È un dirigente societario | No |
Incarichi | |
Attivo | 0 |
Inattivo | 0 |
Dimesso | 441 |
Totale | 441 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOURBAY STRUCTURES LIMITED | 30 nov 1993 | 02 dic 1993 | Procedura concorsuale | Amministratore delegato nominato | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
P NAYLOR CONSTRUCTION LTD | 22 ott 1993 | 02 dic 1993 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
POSMARK LIMITED | 18 nov 1993 | 30 nov 1993 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
35 CROCKERTON ROAD MANAGEMENT COMPANY LTD | 17 nov 1993 | 18 nov 1993 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
ALBANY COURT (BECKENHAM) MANAGEMENT LTD. | 08 nov 1993 | 09 nov 1993 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
SIMSOFT SYSTEMS LTD | 27 ott 1993 | 31 ott 1993 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
BRADWELL CONTRACTING (1993) LTD | 13 ott 1993 | 14 ott 1993 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
HALCYON DESIGNS LTD. | 29 set 1993 | 11 ott 1993 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
WESTNORTH LTD | 21 set 1993 | 11 ott 1993 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
K P LIMITED | 29 set 1993 | 29 set 1993 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
HEATHERDALE AUDIO LTD | 21 set 1993 | 28 set 1993 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
WESTVIEW (U.K.) LTD | 09 set 1993 | 16 set 1993 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
TRAILBLAZER INVESTMENTS LTD. | 28 lug 1993 | 02 set 1993 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
BRIGHTSPELL LTD. | 28 lug 1993 | 31 ago 1993 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
PINNACLE INVESTMENTS LTD | 28 giu 1993 | 31 ago 1993 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
THE DATA ORGANIZATION ORGANIZATION LTD | 26 ago 1993 | 27 ago 1993 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
ELITE ELECTRICAL DESIGN SERVICES LTD | 14 lug 1993 | 15 lug 1993 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
MODERNEON (LONDON) LTD. | 13 lug 1993 | 15 lug 1993 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
UPSHALL TECHNICAL SERVICES LTD | 06 lug 1993 | 07 lug 1993 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
LIGHTBIRCH LTD | 29 mar 1994 | 31 mar 1993 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
COOPSVILLE LIMITED | 31 lug 1992 | 08 ott 1992 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0