THORNTONS WS - Pagina 3
Dirigente societario
Nome | THORNTONS WS |
---|---|
È un dirigente societario | Sì |
Incarichi | |
Attivo | 2 |
Inattivo | 1 |
Dimesso | 205 |
Totale | 208 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Ruolo | Indirizzo |
---|---|---|---|---|---|
LIVINGSTON PIZZA COMPANY LIMITED | 04 lug 2003 | 30 nov 2004 | Sciolta | Segretario | 50 Castle Street DD1 3RU Dundee |
STREAMTEC LIMITED | 27 mag 2003 | 30 nov 2004 | Attiva | Segretario | 50 Castle Street DD1 3RU Dundee |
TRIGGER GROUP LIMITED | 20 mag 2003 | 30 nov 2004 | Sciolta | Segretario | 50 Castle Street DD1 3RU Dundee |
THE PERTHSHIRE INVESTMENT FUND LIMITED | 14 mag 2003 | 30 nov 2004 | Sciolta | Segretario | 50 Castle Street DD1 3RU Dundee |
EASYJOB UK LIMITED | 28 apr 2003 | 30 nov 2004 | Sciolta | Segretario | 50 Castle Street DD1 3RU Dundee |
BETES LIMITED | 28 apr 2003 | 30 nov 2004 | Sciolta | Segretario | 50 Castle Street DD1 3RU Dundee |
LEADHILLS SPORTING LIMITED | 26 mar 2003 | 30 nov 2004 | Sciolta | Segretario | 50 Castle Street DD1 3RU Dundee |
FIFEX LTD | 26 mar 2003 | 30 nov 2004 | Attiva | Segretario | 50 Castle Street DD1 3RU Dundee |
MEDICAL INSTRUMENTATION (UK) LIMITED | 11 feb 2003 | 30 nov 2004 | Sciolta | Segretario | 50 Castle Street DD1 3RU Dundee |
ISIS RETAIL LIMITED | 20 ago 2002 | 30 nov 2004 | Liquidazione | Segretario | 50 Castle Street DD1 3RU Dundee |
GENDISOT LIMITED | 30 gen 2002 | 30 nov 2004 | Attiva | Segretario | 50 Castle Street DD1 3RU Dundee |
DUNDEE SCIENCE CENTRE ENTERPRISES LIMITED | 30 gen 2002 | 30 nov 2004 | Attiva | Segretario | 50 Castle Street DD1 3RU Dundee |
DUNDEE SCIENCE CENTRE | 30 gen 2002 | 30 nov 2004 | Attiva | Segretario | 50 Castle Street DD1 3RU Dundee |
NORTH SHIELDS RETAIL PARK NO 3 LIMITED | 21 dic 2001 | 30 nov 2004 | Sciolta | Segretario | 50 Castle Street DD1 3RU Dundee |
NORTH SHIELDS RETAIL PARK NO 1 LIMITED | 21 dic 2001 | 30 nov 2004 | Sciolta | Segretario | 50 Castle Street DD1 3RU Dundee |
NORTH SHIELDS RETAIL PARK NO 2 LIMITED | 21 dic 2001 | 30 nov 2004 | Sciolta | Segretario | 50 Castle Street DD1 3RU Dundee |
UNICORN PRESERVATION SOCIETY (THE) | 14 giu 2001 | 30 nov 2004 | Attiva | Segretario | 50 Castle Street DD1 3RU Dundee |
THE CAIRNGORM CARTRIDGE COMPANY LIMITED | 31 mag 2001 | 30 nov 2004 | Attiva | Segretario | 50 Castle Street DD1 3RU Dundee |
DEAP LIMITED | 19 apr 2001 | 30 nov 2004 | Sciolta | Segretario | 50 Castle Street DD1 3RU Dundee |
TECHNOTOTS MEDIA LIMITED | 27 mar 2001 | 30 nov 2004 | Sciolta | Segretario | 50 Castle Street DD1 3RU Dundee |
UNION STREET PROPERTIES LTD. | 05 mar 2001 | 30 nov 2004 | Attiva | Segretario | 50 Castle Street DD1 3RU Dundee |
UNION STREET DEVELOPMENTS LTD. | 05 mar 2001 | 30 nov 2004 | Attiva | Segretario | 50 Castle Street DD1 3RU Dundee |
TAYSIDE BUSINESS GATEWAY LIMITED | 27 feb 2001 | 30 nov 2004 | Sciolta | Segretario | 50 Castle Street DD1 3RU Dundee |
KEAN SLATERS (DUNDEE) LIMITED | 27 feb 2001 | 30 nov 2004 | Sciolta | Segretario | 50 Castle Street DD1 3RU Dundee |
C. & K. YEAMAN LIMITED | 29 gen 2001 | 30 nov 2004 | Sciolta | Segretario | 50 Castle Street DD1 3RU Dundee |
BLACKSCROFT PROPERTY CO. LIMITED | 26 gen 2001 | 30 nov 2004 | Attiva | Segretario | 50 Castle Street DD1 3RU Dundee |
ELITE HOMES (TAYSIDE) LIMITED | 22 gen 2001 | 30 nov 2004 | Attiva | Segretario | 50 Castle Street DD1 3RU Dundee |
MEDIA SCOTLAND LTD. | 28 nov 2000 | 30 nov 2004 | Sciolta | Segretario | 50 Castle Street DD1 3RU Dundee |
DJS CREATIVE MARKETING LTD. | 06 nov 2000 | 30 nov 2004 | Attiva | Segretario | 50 Castle Street DD1 3RU Dundee |
EDENBANK PROPERTIES LIMITED | 04 set 2000 | 30 nov 2004 | Sciolta | Segretario | 50 Castle Street DD1 3RU Dundee |
THE CAIRNGORM COUNTRY CLOTHING COMPANY LIMITED | 04 set 2000 | 30 nov 2004 | Sciolta | Segretario | 50 Castle Street DD1 3RU Dundee |
AMCET LIMITED | 09 mag 2000 | 30 nov 2004 | Sciolta | Segretario | 50 Castle Street DD1 3RU Dundee |
CLAIRE ENDERS LIMITED | 26 apr 2000 | 30 nov 2004 | Attiva | Segretario | 50 Castle Street DD1 3RU Dundee |
BODY POSITIVE TAYSIDE | 10 mar 2000 | 30 nov 2004 | Sciolta | Segretario | 50 Castle Street DD1 3RU Dundee |
Q-TECH DESIGN LIMITED | 16 set 1999 | 30 nov 2004 | Sciolta | Segretario | 50 Castle Street DD1 3RU Dundee |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0